Actos BORME de Mecatronia Automatizaciones Sl
31 de Enero de 2019Ceses/Dimisiones. Liquidador: PORTAS ARRONDO IVAN. Consejero: HERREKOR GESTION SL;PORTAS ARRONDOIVAN;COGOLLOS MARTINEZ JUAN-ALBERTO;PATRIBUS FELCAR SL;SILVA CASAL MARTIN. Secretario: PAISAN RUIZ PABLO.
14 de Julio de 2017Ceses/Dimisiones. Presidente: COGOLLOS MARTINEZ JUAN-ALBERTO. Nombramientos. Presidente: PATRIBUS FELCAR SL.Datos registrales. T 2533 , F 217, S 8, H SS 33925, I/A 10 ( 4.07.17).
Ceses/Dimisiones. Con.Delegado: PORTAS ARRONDO IVAN. Revocaciones. Apoderado: COGOLLOS MARTINEZ JUAN-ALBERTO. Nombramientos. Apoderado: LASA ALBERDI JOSE MANUEL. Datos registrales. T 2533 , F 217, S 8, H SS 33925, I/A11 ( 4.07.17).
05 de Abril de 2017Nombramientos. Auditor: AUDITORIA Y GESTION EMPRESARIAL SL. Datos registrales. T 2533 , F 216, S 8, H SS 33925, I/A 9
19 de Octubre de 2016Nombramientos. Consejero: HERREKOR GESTION SL. Ampliaci贸n de capital. Capital: 501,00 Euros. Resultante Suscrito:4.759,50 Euros. Datos registrales. T 2533 , F 216, S 8, H SS 33925, I/A 8 (13.10.16).
12 de Agosto de 2014Reelecciones. Auditor: AUDITORIA Y GESTION EMPRESARIAL SL. Datos registrales. T 2533 , F 216, S 8, H SS 33925, I/A 7(28.07.14).
02 de Enero de 2014Nombramientos. Auditor: AUDITORIA Y GESTION EMPRESARIAL SL. Datos registrales. T 2533 , F 216, S 8, H SS 33925, I/A 6(23.12.13).
13 de Mayo de 2013Ampliaci贸n de capital. Capital: 501,00 Euros. Resultante Suscrito: 4.258,50 Euros. Otros conceptos: Modificaci贸n de losARTICULOS 5潞 y 6潞 de los Estatutos Sociales para adptarlos a la nueva estructura del capital social. Datos registrales. T 2533 , F215, S 8, H SS 33925, I/A 5 ( 3.05.13).
08 de Mayo de 2013Ceses/Dimisiones. Con.Delegado: COGOLLOS MARTINEZ JUAN-ALBERTO. Revocaciones. Apo.D.Gral.: PORTAS ARRONDOIVAN. Nombramientos. Con.Delegado: PORTAS ARRONDO IVAN. Apoderado: COGOLLOS MARTINEZ JUAN-ALBERTO. Datosregistrales. T 2533 , F 214, S 8, H SS 33925, I/A 4 (26.04.13).
19 de Diciembre de 2012Ceses/Dimisiones. Secretario: PORTAS ARRONDO IVAN. Nombramientos. Secretario: PAISAN RUIZ PABLO. Vicesecret.: RUIZPOZUETA ANE. Datos registrales. T 2533 , F 214, S 8, H SS 33925, I/A 3 (11.12.12).
24 de Mayo de 2012Ceses/Dimisiones. Adm. Solid.: COGOLLOS MARTINEZ JUAN-ALBERTO;PORTAS ARRONDO IVAN. Nombramientos.Consejero: PORTAS ARRONDO IVAN;COGOLLOS MARTINEZ JUAN-ALBERTO;PATRIBUS FELCAR SL;SILVA CASAL MARTIN.Presidente: COGOLLOS MARTINEZ JUAN-ALBERTO. Secretario: PORTAS ARRONDO IVAN. Con.Delegado: COGOLLOSMARTINEZ JUAN-ALBERTO. Apo.D.Gral.: PORTAS ARRONDO IVAN. Ampliaci贸n de capital. Capital: 751,50 Euros. ResultanteSuscrito: 3.757,50 Euros. Modificaciones estatutarias. Cambio del Organo de Administraci贸n: Administradores solidarios a Consejode administraci贸n. Otros conceptos: Adaptar y Refundir los Estatutos Sociales. Datos registrales. T 2533 , F 211, S 8, H SS33925, I/A 2 (14.05.12).
25 de Noviembre de 2011Constituci贸n. Comienzo de operaciones: 20.10.11. Objeto social: a) La ingenier铆a de automatizaciones para instalacionesindustriales. b) La realizaci贸n de proyectos de ingenier铆a electromec谩nica multisectorial. c)La adquisici贸n, venta, cesi贸n, inversi贸n,tenencia, disfrute, administraci贸n, gesti贸n, estudios y negociaci贸n en general de participaciones, ETC. Domicilio: PASEO MIKELETEGI,N潞56. (DONOSTIA-SAN SEBASTIAN). Capital: 3.006,00 Euros. Nombramientos. Adm. Solid.: PORTAS ARRONDOIVAN;COGOLLOS MARTINEZ JUAN-ALBERTO. Datos registrales. T 2533 , F 210, S 8, H SS 33925, I/A 1 (16.11.11).