Actos BORME de Medica Scientia Innovation Research Sl
07 de Noviembre de 2023Revocaciones. APODERAD.SOL: CORTES CASTAN JAVIER;CAMPOS CALLAO MARIA. Nombramientos. CONS.DEL.SOL:MAJ3 CAPITAL SL. Datos registrales. T 48870 , F 133, S 8, H B 423631, I/A 64 (30.10.23).
28 de Julio de 2023Nombramientos. APODERAD.SOL: ESPIGADO GUEDES DIEGO. Datos registrales. T 48650 , F 63, S 8, H B 423631, I/A 58(20.07.23).
Nombramientos. APOD.SOL/MAN: LLORENTE ALONSO GEMA. Datos registrales. T 48650 , F 64, S 8, H B 423631, I/A 59(20.07.23).
Nombramientos. APOD.SOL/MAN: CORTES CASTAN JAVIER. Datos registrales. T 48650 , F 65, S 8, H B 423631, I/A 60(20.07.23).
Nombramientos. APODERAD.SOL: ALVAREZ ANDRES JENNIFER. Datos registrales. T 48870 , F 132, S 8, H B 423631, I/A 61(20.07.23).
Nombramientos. APOD.SOL/MAN: RAMOS CASALS MARC. Datos registrales. T 48870 , F 132, S 8, H B 423631, I/A 62(20.07.23).
Revocaciones. APOD.SOL/MAN: CORTES CASTAN JAVIER. APODERAD.SOL: NIETO MARTINEZ ELVIRA. Datos registrales. T48870 , F 133, S 8, H B 423631, I/A 63 (20.07.23).
05 de Junio de 2023Revocaciones. PRESIDENTE: BROSETA DUPRE MANUEL. Nombramientos. CONSEJERO: MAJ3 CAPITAL SL. PRESIDENTE:MAJ3 CAPITAL SL. REPR.143 RRM: CAMPOS CALLAO MARIA. Datos registrales. T 48650 , F 63, S 8, H B 423631, I/A 57(29.05.23).
24 de Mayo de 2023Revocaciones. CONSEJERO: JIMENEZ IZQUIERDO JOSE RAMON. PRESIDENTE: JIMENEZ IZQUIERDO JOSE RAMON. V-SECNO CON: PAGES CARBALLEDA SANTIAGO. Nombramientos. V-SEC NO CON: CAMPELO GUTIERREZ MIRIAM. PRESIDENTE:BROSETA DUPRE MANUEL. Datos registrales. T 48650 , F 62, S 8, H B 423631, I/A 56 (17.05.23).
01 de Marzo de 2023Nombramientos. APODERAD.SOL: CAMPOS CALLAO MARIA. Datos registrales. T 48384 , F 145, S 8, H B 423631, I/A 55(22.02.23).
23 de Febrero de 2023Revocaciones. ADM.UNICO: CAMPOS CALLAO MARIA. Nombramientos. CONSEJERO: JIMENEZ IZQUIERDO JOSE RAMON.PRESIDENTE: JIMENEZ IZQUIERDO JOSE RAMON. CONSEJERO: BROSETA DUPRE MANUEL;CORTES CASTANIGNACIO;BRUNO LEMOS FERRARI. VICEPRESIDEN: BRUNO LEMOS FERRARI. CONSEJERO: RODRIGO FERREIRAMEDEIROS DA SILVA. SECR.NO CONS: ESPIGADO GUEDES DIEGO. V-SEC NO CON: PAGES CARBALLEDA SANTIAGO. Datosregistrales. T 48384 , F 140, S 8, H B 423631, I/A 53 (16.02.23).
Ampliaci贸n de capital. Capital: 140.184,00 Euros. Resultante Suscrito: 598.187,00 Euros. Modificaciones estatutarias.REFUNDICION DE ESTATUTOS SOCIALES EN FECHA 7 DE OCTUBRE DE 2022. Datos registrales. T 48384 , F 141, S 8, H B423631, I/A 54 (16.02.23).
04 de Octubre de 2022Revocaciones. APODERAD.SOL: GARCIA SANZ ALICIA;ZARAGOZA BLANES DUNA;CORTES GIRALDEZ ROLDAN;HERREROENDRINO CAROLINA;NIETO MARTINEZ ELVIRA;RUBIO DIAZ JOSE MANUEL. Datos registrales. T 48384 , F 137, S 8, H B423631, I/A 46 (22.09.22).
Nombramientos. APODERAD.SOL: NIETO MARTINEZ ELVIRA. Datos registrales. T 48384 , F 137, S 8, H B 423631, I/A 47(22.09.22).
Nombramientos. APODERAD.SOL: JIMENEZ MARQUEZ JOSE. Datos registrales. T 48384 , F 138, S 8, H B 423631, I/A 48(22.09.22).
Nombramientos. APODERAD.SOL: AMANDINE DENYS. Datos registrales. T 48384 , F 138, S 8, H B 423631, I/A 49 (22.09.22).
Nombramientos. APODERAD.SOL: CALABUIG BENDICHO LAURA. Datos registrales. T 48384 , F 139, S 8, H B 423631, I/A 50(22.09.22).
Nombramientos. APODERAD.SOL: SUSANA RICARDO VITORINO. Datos registrales. T 48384 , F 140, S 8, H B 423631, I/A 51(22.09.22).
Nombramientos. APODERAD.SOL: GARCIA SANZ ALICIA. Datos registrales. T 48384 , F 140, S 8, H B 423631, I/A 52 (22.09.22).
23 de Septiembre de 2022Cambio de domicilio social. AV DIAGONAL 211, PLANTA 27, TORRE GLORIES (BARCELONA). Datos registrales. T 48384 , F136, S 8, H B 423631, I/A 45 (14.09.22).
25 de Agosto de 2022Reelecciones. Adm. Unico: CAMPOS CALLAO MARIA. Datos registrales. T 10440, L 7721, F 35, S 8, H V 179999, I/A 25(18.08.22).
10 de Febrero de 2022Nombramientos. Auditor: MAZARS AUDITORES SLP. Datos registrales. T 10440, L 7721, F 25, S 8, H V 179999, I/A 24 ( 2.02.22).
16 de Junio de 2021Nombramientos. Apoderado: CAMPELO GUTIERREZ MIRIAM. Datos registrales. T 10440, L 7721, F 25, S 8, H V 179999, I/A 23 (9.06.21).
14 de Junio de 2021Revocaciones. Apoderado: PEREZ ABILLEIRA TOMAS. Apo.Sol.: PEREZ ABILLEIRA TOMAS. Apoderado: RIVA FRANCOISNICOLA. Datos registrales. T 10440, L 7721, F 24, S 8, H V 179999, I/A 18 ( 7.06.21).
Nombramientos. Apoderado: CORTES GIRALDEZ ROLDAN. Datos registrales. T 10440, L 7721, F 24, S 8, H V 179999, I/A 19 (7.06.21).
Nombramientos. Apoderado: HERRERO ENDRINO CAROLINA. Datos registrales. T 10440, L 7721, F 24, S 8, H V 179999, I/A 20( 7.06.21).
Nombramientos. Apoderado: NIETO MARTINEZ ELVIRA. Datos registrales. T 10440, L 7721, F 24, S 8, H V 179999, I/A 21 (7.06.21).
Nombramientos. Apoderado: RUBIO DIAZ JOSE MANUEL. Datos registrales. T 10440, L 7721, F 25, S 8, H V 179999, I/A 22 (7.06.21).
19 de Mayo de 2021Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 1.754,00 Euros. Resultante Suscrito: 556.358,00 Euros. Reducci贸n de capital. Importereducci贸n: 98.355,00 Euros. Resultante Suscrito: 458.003,00 Euros. Datos registrales. T 10440, L 7721, F 22, S 8, H V 179999, I/A16 (12.05.21).
Otros conceptos: Supresi贸n de las clases A y B de participaciones sociales y renumeraci贸n de las mismas. Datos registrales. T10440, L 7721, F 23, S 8, H V 179999, I/A 17 (12.05.21).
24 de Noviembre de 2020Revocaciones. Apoderado: MOREU GALUP ANGEL. Datos registrales. T 10440, L 7721, F 22, S 8, H V 179999, I/A 15 (17.11.20).
03 de Septiembre de 2020Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 45.396,00 Euros. Resultante Suscrito: 558.112,00 Euros. Modificaciones estatutarias.Art铆culo de los estatutos: ARTICULO 5. Capital social.-. El capital social, totalmente suscrito y desembolsado, es de quinientoscincuenta y ocho mil ciento doce euros (558.112 E) representado por quinientas cincuenta y ocho mil ciento doce (558.112)participaciones sociales, de un euro (1,00.-E). Datos registrales. T 10440, L 7721, F 21, S 8, H V 179999, I/A 14 (27.08.20).
10 de Febrero de 2020Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 1.754,00 Euros. Resultante Suscrito: 603.508,00 Euros. Modificaciones estatutarias.Art铆culo de los estatutos: ARTICULO 5潞.- CAPITAL SOCIAL.- El capital social, totalmente suscrito y desembolsado es de -603.508,00E- representado por seiscientas tres mil quinientas ocho participacones sociales, de un euro -1,00 E- de valor nominal cada una deellas. Las participaciones sociales. Datos registrales. T 10440, L 7721, F 19, S 8, H V 179999, I/A 12 ( 3.02.20).
Nombramientos. Apoderado: MOREU GALUP ANGEL. Datos registrales. T 10440, L 7721, F 20, S 8, H V 179999, I/A 13 (3.02.20).
24 de Diciembre de 2019Nombramientos. Apo.Sol.: CORTES CASTAN JAVIER;PEREZ ABILLEIRA TOMAS. Datos registrales. T 10440, L 7721, F 19, S 8,H V 179999, I/A 11 (17.12.19).
13 de Mayo de 2019Ceses/Dimisiones. Presidente: GARCIA BARBAL JAUME. Consejero: CAMPOS CALLAO DAVID;CUADRADO BENETSERGIO;GARCIA BARBAL JAUME. Secretario: FITO BAUCELLS ANTONI. Vicesecret.: LOZANO MORENO MARC.Nombramientos. Adm. Unico: CAMPOS CALLAO MARIA. Otros conceptos: Cambio del Organo de Administraci贸n: Consejo deadministraci贸n a Administrador 煤nico. Datos registrales. T 10440, L 7721, F 18, S 8, H V 179999, I/A 8 ( 6.05.19).
Nombramientos. Apoderado: LOZANO MORENO MARC. Datos registrales. T 10440, L 7721, F 18, S 8, H V 179999, I/A 9 (6.05.19).
Nombramientos. Apoderado: ZARAGOZA BLANES DUNA;PEREZ ABILLEIRA TOMAS. Datos registrales. T 10440, L 7721, F 18, S8, H V 179999, I/A 10 ( 6.05.19).
04 de Marzo de 2019Nombramientos. Apo.Man.Soli: CORTES CASTAN JAVIER. Apoderado: GARCIA SANZ ALICIA;RIVA FRANCOIS NICOLA.Modificaci贸n de poderes. Apo.Man.Soli: CAMPOS CALLAO MARIA;CAMPOS CALLAO MARIA. Datos registrales. T 10440, L7721, F 17, S 8, H V 179999, I/A 6 (25.02.19).
Ceses/Dimisiones. Consejero: GUTIERREZ DEL RIO JAVIER. Datos registrales. T 10440, L 7721, F 18, S 8, H V 179999, I/A 7(25.02.19).
14 de Febrero de 2019Revocaciones. Apo.Sol.: GIBERNAU BALCELLS ANNA;GIBERNAU BALCELLS ANNA. Apoderado: CAMA MARISCAL JOAN.Datos registrales. T 10440, L 7721, F 17, S 8, H V 179999, I/A 5 ( 7.02.19).
26 de Octubre de 2018Reelecciones. Auditor: PANARO AUDIT SLP. Datos registrales. T 10440, L 7721, F 16, S 8, H V 179999, I/A 4 (19.10.18).
20 de Septiembre de 2018Nombramientos. Consejero: GUTIERREZ DEL RIO JAVIER. Datos registrales. T 10440, L 7721, F 16, S 8, H V 179999, I/A 3(13.09.18).
05 de Febrero de 2018Cambio de domicilio social. C/ PORTA DEL MAR 6 3 (VALENCIA). Datos registrales. T 10440, L 7721, F 16, S 8, H V 179999, I/A2 (29.01.18).
18 de Diciembre de 2017Revocaciones. CONSEJERO: CAMPOS CALLAO MARIA. PRESIDENTE: CAMPOS CALLAO MARIA. Nombramientos.PRESIDENTE: GARCIA BARBAL JAUME. Ampliaci贸n de capital. Capital: 500.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 605.262,00 Euros.Datos registrales. T 45062 , F 59, S 8, H B 423631, I/A 20 ( 5.12.17).
25 de Agosto de 2017Nombramientos. CONSEJERO: CAMPOS CALLAO DAVID. Datos registrales. T 45062 , F 59, S 8, H B 423631, I/A 19 (17.08.17).
02 de Agosto de 2017Nombramientos. AUDIT.CUENT.: PANARO AUDIT SLP. Datos registrales. T 45062 , F 59, S 8, H B 423631, I/A 18 (26.07.17).
03 de Julio de 2017Nombramientos. APOD.SOL/MAN: CAMPOS CALLAO MARIA;GIBERNAU BALCELLS ANNA. Datos registrales. T 45062 , F 58, S8, H B 423631, I/A 17 (23.06.17).
25 de Abril de 2017Nombramientos. APODERAD.SOL: CAMA MARISCAL JOAN. Datos registrales. T 45062 , F 58, S 8, H B 423631, I/A 16(12.04.17).
25 de Octubre de 2016Nombramientos. AUDIT.CUENT.: PANARO AUDIT SLP. Datos registrales. T 45062 , F 58, S 8, H B 423631, I/A 15 (17.10.16).
25 de Mayo de 2016Nombramientos. APOD.SOL/MAN: CAMPOS CALLAO MARIA;GIBERNAU BALCELLS ANNA. Datos registrales. T 45062 , F 57, S8, H B 423631, I/A 14 (17.05.16).
25 de Febrero de 2016Revocaciones. CONSEJERO: MERCADAL DALMAU JOAN. VICEPRESIDEN: MERCADAL DALMAU JOAN. Datos registrales. T45062 , F 57, S 8, H B 423631, I/A 13 (18.02.16).
07 de Enero de 2016Revocaciones. APODERAD.SOL: MERCADAL DALMAU JOAN. Datos registrales. T 45062 , F 56, S 8, H B 423631, I/A 12(28.12.15).
23 de Diciembre de 2015Nombramientos. APODERAD.SOL: CAMPOS CALLAO MARIA. Datos registrales. T 45062 , F 56, S 8, H B 423631, I/A 11(16.12.15).
11 de Noviembre de 2015Revocaciones. CONSEJERO: CORTES CASTAN JAVIER;LLOMBART CUSSAC ANTONIO. PRESIDENTE: LLOMBART CUSSACANTONIO. CONSEJERO: CAMPOS CALLAO MARIA. VICEPRESIDEN: CAMPOS CALLAO MARIA. CONSEJERO: MERCADALDALMAU JOAN. Nombramientos. CONSEJERO: LLOMBART CUSSAC ANTONIO. PRESIDENTE: LLOMBART CUSSACANTONIO. CONSEJERO: CORTES CASTAN JAVIER;CAMPOS CALLAO MARIA. VICEPRESIDEN: CAMPOS CALLAO MARIA.CONSEJERO: MERCADAL DALMAU JOAN. Modificaciones estatutarias. ARTICULO 9: CONVOCATORIA DE LAS JUNTASGENERALES. Cambio de domicilio social. RB CATALUNYA,NUMERO 2-4, 2-D (BARCELONA). P谩gina web de la sociedad.Creaci贸n de la p谩gina web corporativa: www.medsir.org. Datos registrales. T 43298 , F 8, S 8, H B 423631, I/A 9 ( 2.11.15).
Revocaciones. CONSEJERO: LLOMBART CUSSAC ANTONIO. PRESIDENTE: LLOMBART CUSSAC ANTONIO. CONSEJERO:CORTES CASTAN JAVIER. VICEPRESIDEN: CAMPOS CALLAO MARIA. Nombramientos. CONSEJERO: CUADRADO BENETSERGIO;GARCIA BARBAL JAUME. VICEPRESIDEN: MERCADAL DALMAU JOAN. PRESIDENTE: CAMPOS CALLAO MARIA.Cambio de objeto social. LA REALIZACION DE TODO TIPO DE PROYECTOS DE INVESTIGACION RELACIONADOS CONCIENCIAS DE LA SALUD Y LA MEDICINA,EN CUALQUIER ESPECIALIDAD.LA IDEACION,DISE脩O,PUESTA EN MARCHA YGESTION DE PROYECTOS DE INVESTIGACION ... Datos registrales. T 43298 , F 9, S 8, H B 423631, I/A 10 ( 2.11.15).
25 de Mayo de 2015Revocaciones. SECRETARIO: CORTES CASTAN JAVIER. Nombramientos. SECR.NO CONS: FITO BAUCELLS ANTONI. V-SECNO CON: LOZANO MORENO MARC. Datos registrales. T 43298 , F 8, S 8, H B 423631, I/A 8 (18.05.15).
03 de Noviembre de 2014Nombramientos. CONSEJERO: MERCADAL DALMAU JOAN. Datos registrales. T 43298 , F 8, S 8, H B 423631, I/A 7 (24.10.14).
23 de Octubre de 2014Ampliaci贸n de capital. Capital: 5.262,00 Euros. Resultante Suscrito: 105.262,00 Euros. Modificaciones estatutarias. ARTICULO5. CREACION DE CLASES DE ACCIONES. Datos registrales. T 43298 , F 7, S 8, H B 423631, I/A 6 (16.10.14).
24 de Septiembre de 2014Nombramientos. APODERAD.SOL: MERCADAL DALMAU JOAN. Datos registrales. T 43298 , F 6, S 8, H B 423631, I/A 5(17.09.14).
29 de Mayo de 2014Cambio de objeto social. AMPLIAR A:LA IMPARTICION DE CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTOPROFESIONAL,EMPRESARIAL O PERSONAL,ASI COMO LA GESTION Y ORGANIZACION DE CURSOS,EVENTOS,SEMINARIOSY JORNADAS,TODO ELLO RELACIONADO CON LOS SERVICIOS ... Datos registrales. T 43298 , F 6, S 8, H B 423631, I/A 4(22.05.14).
05 de Septiembre de 2013Modificaciones estatutarias. ART.11.3:SISTEMA RETRIBUTIVO DEL ORGANO DE ADMINISTRACION SOCIAL. Cambio dedomicilio social. CL DOCTOR AIGUADER,88,PARC DE RECERCA BIOMEDICA (BARCELONA). Datos registrales. T 43298 , F 5,S 8, H B 423631, I/A 3 (27.08.13).
13 de Agosto de 2013Revocaciones. CONSEJERO: MERCADAL DALMAU JOAN. Datos registrales. T 43298 , F 5, S 8, H B 423631, I/A 2 ( 5.08.13).
07 de Agosto de 2012Constituci贸n. Comienzo de operaciones: 12.04.12. Objeto social: REALIZACION DE PROYECTOS DE INVESTIGACIONRELACIONADOS CON CIENCIAS DE LA SALUD,MEDICINA,EN CUALQUIER ESPECIALIDAD.IDEACION,DISE脩O,PUESTA ENMARCHA,GESTION DE PROYECTOS DE INVESTIGACION RELACIONADOS CON CIENCIAS DE SALUD,ETC. Domicilio: CLSIMON OLLER Num.2 P.4 PTA.2 (BARCELONA). Capital: 100.000,00 Euros. Nombramientos. CONSEJERO: MERCADALDALMAU JOAN;CORTES CASTAN JAVIER. SECRETARIO: CORTES CASTAN JAVIER. CONSEJERO: LLOMBART CUSSACANTONIO. PRESIDENTE: LLOMBART CUSSAC ANTONIO. CONSEJERO: CAMPOS CALLAO MARIA. VICEPRESIDEN: CAMPOSCALLAO MARIA. Datos registrales. T 43298 , F 1, S 8, H B 423631, I/A 1 (25.07.12).