Buscador CIF Logo

Actos BORME Medica Scientia Innovation Research Sl

驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Medica Scientia Innovation Research Sl

Actos BORME Medica Scientia Innovation Research Sl - B65778946

Tenemos registrados 64 Actos BORME del Registro Mercantil de Valencia para Medica Scientia Innovation Research Sl con CIF B65778946

馃敊 Perfil de Medica Scientia Innovation Research Sl
馃洅 Comprar listado completo de Empresas de Valencia

Actos BORME de Medica Scientia Innovation Research Sl

07 de Noviembre de 2023
Revocaciones. APODERAD.SOL: CORTES CASTAN JAVIER;CAMPOS CALLAO MARIA. Nombramientos. CONS.DEL.SOL:MAJ3 CAPITAL SL. Datos registrales. T 48870 , F 133, S 8, H B 423631, I/A 64 (30.10.23).

28 de Julio de 2023
Nombramientos. APODERAD.SOL: ESPIGADO GUEDES DIEGO. Datos registrales. T 48650 , F 63, S 8, H B 423631, I/A 58(20.07.23).

Nombramientos. APOD.SOL/MAN: LLORENTE ALONSO GEMA. Datos registrales. T 48650 , F 64, S 8, H B 423631, I/A 59(20.07.23).

Nombramientos. APOD.SOL/MAN: CORTES CASTAN JAVIER. Datos registrales. T 48650 , F 65, S 8, H B 423631, I/A 60(20.07.23).

Nombramientos. APODERAD.SOL: ALVAREZ ANDRES JENNIFER. Datos registrales. T 48870 , F 132, S 8, H B 423631, I/A 61(20.07.23).

Nombramientos. APOD.SOL/MAN: RAMOS CASALS MARC. Datos registrales. T 48870 , F 132, S 8, H B 423631, I/A 62(20.07.23).

Revocaciones. APOD.SOL/MAN: CORTES CASTAN JAVIER. APODERAD.SOL: NIETO MARTINEZ ELVIRA. Datos registrales. T48870 , F 133, S 8, H B 423631, I/A 63 (20.07.23).

05 de Junio de 2023
Revocaciones. PRESIDENTE: BROSETA DUPRE MANUEL. Nombramientos. CONSEJERO: MAJ3 CAPITAL SL. PRESIDENTE:MAJ3 CAPITAL SL. REPR.143 RRM: CAMPOS CALLAO MARIA. Datos registrales. T 48650 , F 63, S 8, H B 423631, I/A 57(29.05.23).

24 de Mayo de 2023
Revocaciones. CONSEJERO: JIMENEZ IZQUIERDO JOSE RAMON. PRESIDENTE: JIMENEZ IZQUIERDO JOSE RAMON. V-SECNO CON: PAGES CARBALLEDA SANTIAGO. Nombramientos. V-SEC NO CON: CAMPELO GUTIERREZ MIRIAM. PRESIDENTE:BROSETA DUPRE MANUEL. Datos registrales. T 48650 , F 62, S 8, H B 423631, I/A 56 (17.05.23).

01 de Marzo de 2023
Nombramientos. APODERAD.SOL: CAMPOS CALLAO MARIA. Datos registrales. T 48384 , F 145, S 8, H B 423631, I/A 55(22.02.23).

23 de Febrero de 2023
Revocaciones. ADM.UNICO: CAMPOS CALLAO MARIA. Nombramientos. CONSEJERO: JIMENEZ IZQUIERDO JOSE RAMON.PRESIDENTE: JIMENEZ IZQUIERDO JOSE RAMON. CONSEJERO: BROSETA DUPRE MANUEL;CORTES CASTANIGNACIO;BRUNO LEMOS FERRARI. VICEPRESIDEN: BRUNO LEMOS FERRARI. CONSEJERO: RODRIGO FERREIRAMEDEIROS DA SILVA. SECR.NO CONS: ESPIGADO GUEDES DIEGO. V-SEC NO CON: PAGES CARBALLEDA SANTIAGO. Datosregistrales. T 48384 , F 140, S 8, H B 423631, I/A 53 (16.02.23).

Ampliaci贸n de capital. Capital: 140.184,00 Euros. Resultante Suscrito: 598.187,00 Euros. Modificaciones estatutarias.REFUNDICION DE ESTATUTOS SOCIALES EN FECHA 7 DE OCTUBRE DE 2022. Datos registrales. T 48384 , F 141, S 8, H B423631, I/A 54 (16.02.23).

04 de Octubre de 2022
Revocaciones. APODERAD.SOL: GARCIA SANZ ALICIA;ZARAGOZA BLANES DUNA;CORTES GIRALDEZ ROLDAN;HERREROENDRINO CAROLINA;NIETO MARTINEZ ELVIRA;RUBIO DIAZ JOSE MANUEL. Datos registrales. T 48384 , F 137, S 8, H B423631, I/A 46 (22.09.22).

Nombramientos. APODERAD.SOL: NIETO MARTINEZ ELVIRA. Datos registrales. T 48384 , F 137, S 8, H B 423631, I/A 47(22.09.22).

Nombramientos. APODERAD.SOL: JIMENEZ MARQUEZ JOSE. Datos registrales. T 48384 , F 138, S 8, H B 423631, I/A 48(22.09.22).

Nombramientos. APODERAD.SOL: AMANDINE DENYS. Datos registrales. T 48384 , F 138, S 8, H B 423631, I/A 49 (22.09.22).

Nombramientos. APODERAD.SOL: CALABUIG BENDICHO LAURA. Datos registrales. T 48384 , F 139, S 8, H B 423631, I/A 50(22.09.22).

Nombramientos. APODERAD.SOL: SUSANA RICARDO VITORINO. Datos registrales. T 48384 , F 140, S 8, H B 423631, I/A 51(22.09.22).

Nombramientos. APODERAD.SOL: GARCIA SANZ ALICIA. Datos registrales. T 48384 , F 140, S 8, H B 423631, I/A 52 (22.09.22).

23 de Septiembre de 2022
Cambio de domicilio social. AV DIAGONAL 211, PLANTA 27, TORRE GLORIES (BARCELONA). Datos registrales. T 48384 , F136, S 8, H B 423631, I/A 45 (14.09.22).

25 de Agosto de 2022
Reelecciones. Adm. Unico: CAMPOS CALLAO MARIA. Datos registrales. T 10440, L 7721, F 35, S 8, H V 179999, I/A 25(18.08.22).

10 de Febrero de 2022
Nombramientos. Auditor: MAZARS AUDITORES SLP. Datos registrales. T 10440, L 7721, F 25, S 8, H V 179999, I/A 24 ( 2.02.22).

16 de Junio de 2021
Nombramientos. Apoderado: CAMPELO GUTIERREZ MIRIAM. Datos registrales. T 10440, L 7721, F 25, S 8, H V 179999, I/A 23 (9.06.21).

14 de Junio de 2021
Revocaciones. Apoderado: PEREZ ABILLEIRA TOMAS. Apo.Sol.: PEREZ ABILLEIRA TOMAS. Apoderado: RIVA FRANCOISNICOLA. Datos registrales. T 10440, L 7721, F 24, S 8, H V 179999, I/A 18 ( 7.06.21).

Nombramientos. Apoderado: CORTES GIRALDEZ ROLDAN. Datos registrales. T 10440, L 7721, F 24, S 8, H V 179999, I/A 19 (7.06.21).

Nombramientos. Apoderado: HERRERO ENDRINO CAROLINA. Datos registrales. T 10440, L 7721, F 24, S 8, H V 179999, I/A 20( 7.06.21).

Nombramientos. Apoderado: NIETO MARTINEZ ELVIRA. Datos registrales. T 10440, L 7721, F 24, S 8, H V 179999, I/A 21 (7.06.21).

Nombramientos. Apoderado: RUBIO DIAZ JOSE MANUEL. Datos registrales. T 10440, L 7721, F 25, S 8, H V 179999, I/A 22 (7.06.21).

19 de Mayo de 2021
Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 1.754,00 Euros. Resultante Suscrito: 556.358,00 Euros. Reducci贸n de capital. Importereducci贸n: 98.355,00 Euros. Resultante Suscrito: 458.003,00 Euros. Datos registrales. T 10440, L 7721, F 22, S 8, H V 179999, I/A16 (12.05.21).

Otros conceptos: Supresi贸n de las clases A y B de participaciones sociales y renumeraci贸n de las mismas. Datos registrales. T10440, L 7721, F 23, S 8, H V 179999, I/A 17 (12.05.21).

24 de Noviembre de 2020
Revocaciones. Apoderado: MOREU GALUP ANGEL. Datos registrales. T 10440, L 7721, F 22, S 8, H V 179999, I/A 15 (17.11.20).

03 de Septiembre de 2020
Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 45.396,00 Euros. Resultante Suscrito: 558.112,00 Euros. Modificaciones estatutarias.Art铆culo de los estatutos: ARTICULO 5. Capital social.-. El capital social, totalmente suscrito y desembolsado, es de quinientoscincuenta y ocho mil ciento doce euros (558.112 E) representado por quinientas cincuenta y ocho mil ciento doce (558.112)participaciones sociales, de un euro (1,00.-E). Datos registrales. T 10440, L 7721, F 21, S 8, H V 179999, I/A 14 (27.08.20).

10 de Febrero de 2020
Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 1.754,00 Euros. Resultante Suscrito: 603.508,00 Euros. Modificaciones estatutarias.Art铆culo de los estatutos: ARTICULO 5潞.- CAPITAL SOCIAL.- El capital social, totalmente suscrito y desembolsado es de -603.508,00E- representado por seiscientas tres mil quinientas ocho participacones sociales, de un euro -1,00 E- de valor nominal cada una deellas. Las participaciones sociales. Datos registrales. T 10440, L 7721, F 19, S 8, H V 179999, I/A 12 ( 3.02.20).

Nombramientos. Apoderado: MOREU GALUP ANGEL. Datos registrales. T 10440, L 7721, F 20, S 8, H V 179999, I/A 13 (3.02.20).

24 de Diciembre de 2019
Nombramientos. Apo.Sol.: CORTES CASTAN JAVIER;PEREZ ABILLEIRA TOMAS. Datos registrales. T 10440, L 7721, F 19, S 8,H V 179999, I/A 11 (17.12.19).

13 de Mayo de 2019
Ceses/Dimisiones. Presidente: GARCIA BARBAL JAUME. Consejero: CAMPOS CALLAO DAVID;CUADRADO BENETSERGIO;GARCIA BARBAL JAUME. Secretario: FITO BAUCELLS ANTONI. Vicesecret.: LOZANO MORENO MARC.Nombramientos. Adm. Unico: CAMPOS CALLAO MARIA. Otros conceptos: Cambio del Organo de Administraci贸n: Consejo deadministraci贸n a Administrador 煤nico. Datos registrales. T 10440, L 7721, F 18, S 8, H V 179999, I/A 8 ( 6.05.19).

Nombramientos. Apoderado: LOZANO MORENO MARC. Datos registrales. T 10440, L 7721, F 18, S 8, H V 179999, I/A 9 (6.05.19).

Nombramientos. Apoderado: ZARAGOZA BLANES DUNA;PEREZ ABILLEIRA TOMAS. Datos registrales. T 10440, L 7721, F 18, S8, H V 179999, I/A 10 ( 6.05.19).

04 de Marzo de 2019
Nombramientos. Apo.Man.Soli: CORTES CASTAN JAVIER. Apoderado: GARCIA SANZ ALICIA;RIVA FRANCOIS NICOLA.Modificaci贸n de poderes. Apo.Man.Soli: CAMPOS CALLAO MARIA;CAMPOS CALLAO MARIA. Datos registrales. T 10440, L7721, F 17, S 8, H V 179999, I/A 6 (25.02.19).

Ceses/Dimisiones. Consejero: GUTIERREZ DEL RIO JAVIER. Datos registrales. T 10440, L 7721, F 18, S 8, H V 179999, I/A 7(25.02.19).

14 de Febrero de 2019
Revocaciones. Apo.Sol.: GIBERNAU BALCELLS ANNA;GIBERNAU BALCELLS ANNA. Apoderado: CAMA MARISCAL JOAN.Datos registrales. T 10440, L 7721, F 17, S 8, H V 179999, I/A 5 ( 7.02.19).

26 de Octubre de 2018
Reelecciones. Auditor: PANARO AUDIT SLP. Datos registrales. T 10440, L 7721, F 16, S 8, H V 179999, I/A 4 (19.10.18).

20 de Septiembre de 2018
Nombramientos. Consejero: GUTIERREZ DEL RIO JAVIER. Datos registrales. T 10440, L 7721, F 16, S 8, H V 179999, I/A 3(13.09.18).

05 de Febrero de 2018
Cambio de domicilio social. C/ PORTA DEL MAR 6 3 (VALENCIA). Datos registrales. T 10440, L 7721, F 16, S 8, H V 179999, I/A2 (29.01.18).

18 de Diciembre de 2017
Revocaciones. CONSEJERO: CAMPOS CALLAO MARIA. PRESIDENTE: CAMPOS CALLAO MARIA. Nombramientos.PRESIDENTE: GARCIA BARBAL JAUME. Ampliaci贸n de capital. Capital: 500.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 605.262,00 Euros.Datos registrales. T 45062 , F 59, S 8, H B 423631, I/A 20 ( 5.12.17).

25 de Agosto de 2017
Nombramientos. CONSEJERO: CAMPOS CALLAO DAVID. Datos registrales. T 45062 , F 59, S 8, H B 423631, I/A 19 (17.08.17).

02 de Agosto de 2017
Nombramientos. AUDIT.CUENT.: PANARO AUDIT SLP. Datos registrales. T 45062 , F 59, S 8, H B 423631, I/A 18 (26.07.17).

03 de Julio de 2017
Nombramientos. APOD.SOL/MAN: CAMPOS CALLAO MARIA;GIBERNAU BALCELLS ANNA. Datos registrales. T 45062 , F 58, S8, H B 423631, I/A 17 (23.06.17).

25 de Abril de 2017
Nombramientos. APODERAD.SOL: CAMA MARISCAL JOAN. Datos registrales. T 45062 , F 58, S 8, H B 423631, I/A 16(12.04.17).

25 de Octubre de 2016
Nombramientos. AUDIT.CUENT.: PANARO AUDIT SLP. Datos registrales. T 45062 , F 58, S 8, H B 423631, I/A 15 (17.10.16).

25 de Mayo de 2016
Nombramientos. APOD.SOL/MAN: CAMPOS CALLAO MARIA;GIBERNAU BALCELLS ANNA. Datos registrales. T 45062 , F 57, S8, H B 423631, I/A 14 (17.05.16).

25 de Febrero de 2016
Revocaciones. CONSEJERO: MERCADAL DALMAU JOAN. VICEPRESIDEN: MERCADAL DALMAU JOAN. Datos registrales. T45062 , F 57, S 8, H B 423631, I/A 13 (18.02.16).

07 de Enero de 2016
Revocaciones. APODERAD.SOL: MERCADAL DALMAU JOAN. Datos registrales. T 45062 , F 56, S 8, H B 423631, I/A 12(28.12.15).

23 de Diciembre de 2015
Nombramientos. APODERAD.SOL: CAMPOS CALLAO MARIA. Datos registrales. T 45062 , F 56, S 8, H B 423631, I/A 11(16.12.15).

11 de Noviembre de 2015
Revocaciones. CONSEJERO: CORTES CASTAN JAVIER;LLOMBART CUSSAC ANTONIO. PRESIDENTE: LLOMBART CUSSACANTONIO. CONSEJERO: CAMPOS CALLAO MARIA. VICEPRESIDEN: CAMPOS CALLAO MARIA. CONSEJERO: MERCADALDALMAU JOAN. Nombramientos. CONSEJERO: LLOMBART CUSSAC ANTONIO. PRESIDENTE: LLOMBART CUSSACANTONIO. CONSEJERO: CORTES CASTAN JAVIER;CAMPOS CALLAO MARIA. VICEPRESIDEN: CAMPOS CALLAO MARIA.CONSEJERO: MERCADAL DALMAU JOAN. Modificaciones estatutarias. ARTICULO 9: CONVOCATORIA DE LAS JUNTASGENERALES. Cambio de domicilio social. RB CATALUNYA,NUMERO 2-4, 2-D (BARCELONA). P谩gina web de la sociedad.Creaci贸n de la p谩gina web corporativa: www.medsir.org. Datos registrales. T 43298 , F 8, S 8, H B 423631, I/A 9 ( 2.11.15).

Revocaciones. CONSEJERO: LLOMBART CUSSAC ANTONIO. PRESIDENTE: LLOMBART CUSSAC ANTONIO. CONSEJERO:CORTES CASTAN JAVIER. VICEPRESIDEN: CAMPOS CALLAO MARIA. Nombramientos. CONSEJERO: CUADRADO BENETSERGIO;GARCIA BARBAL JAUME. VICEPRESIDEN: MERCADAL DALMAU JOAN. PRESIDENTE: CAMPOS CALLAO MARIA.Cambio de objeto social. LA REALIZACION DE TODO TIPO DE PROYECTOS DE INVESTIGACION RELACIONADOS CONCIENCIAS DE LA SALUD Y LA MEDICINA,EN CUALQUIER ESPECIALIDAD.LA IDEACION,DISE脩O,PUESTA EN MARCHA YGESTION DE PROYECTOS DE INVESTIGACION ... Datos registrales. T 43298 , F 9, S 8, H B 423631, I/A 10 ( 2.11.15).

25 de Mayo de 2015
Revocaciones. SECRETARIO: CORTES CASTAN JAVIER. Nombramientos. SECR.NO CONS: FITO BAUCELLS ANTONI. V-SECNO CON: LOZANO MORENO MARC. Datos registrales. T 43298 , F 8, S 8, H B 423631, I/A 8 (18.05.15).

03 de Noviembre de 2014
Nombramientos. CONSEJERO: MERCADAL DALMAU JOAN. Datos registrales. T 43298 , F 8, S 8, H B 423631, I/A 7 (24.10.14).

23 de Octubre de 2014
Ampliaci贸n de capital. Capital: 5.262,00 Euros. Resultante Suscrito: 105.262,00 Euros. Modificaciones estatutarias. ARTICULO5. CREACION DE CLASES DE ACCIONES. Datos registrales. T 43298 , F 7, S 8, H B 423631, I/A 6 (16.10.14).

24 de Septiembre de 2014
Nombramientos. APODERAD.SOL: MERCADAL DALMAU JOAN. Datos registrales. T 43298 , F 6, S 8, H B 423631, I/A 5(17.09.14).

29 de Mayo de 2014
Cambio de objeto social. AMPLIAR A:LA IMPARTICION DE CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTOPROFESIONAL,EMPRESARIAL O PERSONAL,ASI COMO LA GESTION Y ORGANIZACION DE CURSOS,EVENTOS,SEMINARIOSY JORNADAS,TODO ELLO RELACIONADO CON LOS SERVICIOS ... Datos registrales. T 43298 , F 6, S 8, H B 423631, I/A 4(22.05.14).

05 de Septiembre de 2013
Modificaciones estatutarias. ART.11.3:SISTEMA RETRIBUTIVO DEL ORGANO DE ADMINISTRACION SOCIAL. Cambio dedomicilio social. CL DOCTOR AIGUADER,88,PARC DE RECERCA BIOMEDICA (BARCELONA). Datos registrales. T 43298 , F 5,S 8, H B 423631, I/A 3 (27.08.13).

13 de Agosto de 2013
Revocaciones. CONSEJERO: MERCADAL DALMAU JOAN. Datos registrales. T 43298 , F 5, S 8, H B 423631, I/A 2 ( 5.08.13).

07 de Agosto de 2012
Constituci贸n. Comienzo de operaciones: 12.04.12. Objeto social: REALIZACION DE PROYECTOS DE INVESTIGACIONRELACIONADOS CON CIENCIAS DE LA SALUD,MEDICINA,EN CUALQUIER ESPECIALIDAD.IDEACION,DISE脩O,PUESTA ENMARCHA,GESTION DE PROYECTOS DE INVESTIGACION RELACIONADOS CON CIENCIAS DE SALUD,ETC. Domicilio: CLSIMON OLLER Num.2 P.4 PTA.2 (BARCELONA). Capital: 100.000,00 Euros. Nombramientos. CONSEJERO: MERCADALDALMAU JOAN;CORTES CASTAN JAVIER. SECRETARIO: CORTES CASTAN JAVIER. CONSEJERO: LLOMBART CUSSACANTONIO. PRESIDENTE: LLOMBART CUSSAC ANTONIO. CONSEJERO: CAMPOS CALLAO MARIA. VICEPRESIDEN: CAMPOSCALLAO MARIA. Datos registrales. T 43298 , F 1, S 8, H B 423631, I/A 1 (25.07.12).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n