Buscador CIF Logo

Actos BORME Medicina Asturiana Sa

驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Medicina Asturiana Sa

Actos BORME Medicina Asturiana Sa - A33018292

Tenemos registrados 33 Actos BORME del Registro Mercantil de Asturias para Medicina Asturiana Sa con CIF A33018292

馃敊 Perfil de Medicina Asturiana Sa
馃洅 Comprar listado completo de Empresas de Asturias

Actos BORME de Medicina Asturiana Sa

29 de Diciembre de 2023
Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 4379 , F 11, S 8, H AS 6402, I/A 88(21.12.23).

07 de Septiembre de 2023
Nombramientos. Apo.Manc.: LLAVONA FERNANDEZ RICARDO. Apo.Sol.: LLAVONA FERNANDEZ RICARDO. Datos registrales.T 4379 , F 10, S 8, H AS 6402, I/A 87 (29.08.23).

08 de Febrero de 2023
Nombramientos. Apo.Sol.: MU脩IZ MU脩IZ JOSE ANTONIO;SAENZ DE SANTA MARIA PRIETO JOSE LUIS;PASTOR CABALLERO

07 de Febrero de 2023
Revocaciones. Apo.Manc.: GARCIA MENENDEZ MIGUEL. Apo.Sol.: GARCIA MENENDEZ MIGUEL. Nombramientos. Apo.Sol.:FERNANDEZ MENENDEZ LUIS MANUEL;ZALDIVAR ALONSO PEDRO;TIRADOS FERNANDEZ JESUS. Apo.Manc.: FERNANDEZMENENDEZ LUIS MANUEL;ZALDIVAR ALONSO PEDRO;TIRADOS FERNANDEZ JESUS. Datos registrales. T 4379 , F 9, S 8, HAS 6402, I/A 84 (30.01.23).

02 de Noviembre de 2022
Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 4379 , F 8, S 8, H AS 6402, I/A 82(24.10.22).

03 de Noviembre de 2021
Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 4379 , F 8, S 8, H AS 6402, I/A 81(25.10.21).

30 de Julio de 2021
Ceses/Dimisiones. Consejero: RABANAL GARCIA JAIME. Datos registrales. T 4379 , F 8, S 8, H AS 6402, I/A 80 (23.07.21).

29 de Enero de 2021
Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 4379 , F 8, S 8, H AS 6402, I/A 78(21.01.21).

09 de Enero de 2020
Fusi贸n por absorci贸n. Sociedades absorbidas: SCANNER ASTURIAS SA. RESONANCIA MAGNETICA DEL PRINCIPADO DEASTURIAS SL. PET CENTRO MEDICO DE ASTURIAS SL. Datos registrales. T 4221 , F 225, S 8, H AS 6402, I/A 77 (30.12.19).

02 de Septiembre de 2019
Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 4221 , F 224, S 8, H AS 6402, I/A75 (22.08.19).

Ampliaci贸n de capital. Suscrito: 1.150.854,90 Euros. Desembolsado: 1.150.854,90 Euros. Resultante Suscrito: 5.274.135,60 Euros.Resultante Desembolsado: 5.274.135,60 Euros. Modificaciones estatutarias. Art铆culo de los estatutos: 5. Capital social.-. Datosregistrales. T 4221 , F 224, S 8, H AS 6402, I/A 76 (23.08.19).

11 de Enero de 2019
Otros conceptos: Fallecido el apoderado de la sociedad Don Eduardo Carbajo Avenda帽o el 16 de enero de 2015. Datosregistrales. T 4221 , F 223, S 8, H AS 6402, I/A 74 ( 2.01.19).

11 de Diciembre de 2018
Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 4221 , F 223, S 8, H AS 6402, I/A73 (30.11.18).

06 de Agosto de 2018
Nombramientos. Consejero: RABANAL GARCIA JAIME. Datos registrales. T 4221 , F 223, S 8, H AS 6402, I/A 72 (27.07.18).

19 de Junio de 2018
Revocaciones. Apo.Sol.: FERNANDEZ MENENDEZ LUIS MANUEL. Apo.Manc.: FERNANDEZ MENENDEZ LUIS MANUEL.Apo.Sol.: SILVA RICO FRANCISCO. Apo.Manc.: SILVA RICO FRANCISCO. Apo.Sol.: NORNIELLA MARTINEZ JOSE ADOLFO.Apo.Manc.: NORNIELLA MARTINEZ JOSE ADOLFO. Apo.Sol.: LABRADA JIMENEZ FRANCISCO JAVIER. Apo.Manc.: LABRADAJIMENEZ FRANCISCO JAVIER. Apoderado: GARCIA MENENDEZ MIGUEL. Apo.Sol.: GONZALEZ CARRILES FRANCISCO JAVIER.Apo.Manc.: GONZALEZ CARRILES FRANCISCO JAVIER;FERNANDEZ MENENDEZ LUIS MANUEL;SILVA RICOFRANCISCO;NORNIELLA MARTINEZ JOSE ADOLFO;LABRADA JIMENEZ FRANCISCO JAVIER. Nombramientos. Apoderado:FERNANDEZ MENENDEZ LUIS MANUEL. Datos registrales. T 4221 , F 222, S 8, H AS 6402, I/A 71 (12.06.18).

09 de Mayo de 2018
Ceses/Dimisiones. SecreNoConsj: GONZALEZ APARICIO JESUS. Nombramientos. SecreNoConsj: SAENZ DE SANTA MARIAPRIETO JOSE LUIS. Datos registrales. T 4221 , F 222, S 8, H AS 6402, I/A 70 (26.04.18).

31 de Enero de 2018
Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 4221 , F 222, S 8, H AS 6402, I/A69 (23.01.18).

25 de Julio de 2017
Ceses/Dimisiones. Consejero: RICHARD RODRIGUEZ JOSE MARIA. Vicepresid.: RICHARD RODRIGUEZ JOSE MARIA.Reelecciones. Consejero: ANTU脩A ZAPICO JOSE MANUEL;CORPORACION MASAVEU SA;MASAVEU MEDICINA SL;CANBARINVERSIONES SL;RICHARD GRANDIO SA;MASAVEU INMOBILIARIA SA;POLICLINICO CENTRO MEDICO DE SEGUROSSA;RIOVEGUIN SL. Otros conceptos: FIJACION EN 8 EL NUMERO DE MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION.Datos registrales. T 4221 , F 222, S 8, H AS 6402, I/A 67 (17.07.17).

21 de Diciembre de 2016
Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 4221 , F 222, S 8, H AS 6402, I/A66 (12.12.16).

30 de Junio de 2016
Nombramientos. Apo.Sol.: GARCIA MENENDEZ MIGUEL. Apo.Manc.: GARCIA MENENDEZ MIGUEL. Datos registrales. T 3611 ,F 213, S 8, H AS 6402, I/A 65 (20.06.16).

16 de Diciembre de 2015
Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 3611 , F 213, S 8, H AS 6402, I/A64 ( 4.12.15).

28 de Agosto de 2015
Modificaciones estatutarias. Art铆culo de los estatutos: 2. Objeto.-. Art铆culo de los estatutos: 3. Domicilio.-. Otros conceptos:Modificaci贸n y refundici贸n de Estatutos. Cambio de domicilio social. AVDA RICHARD GRANDIO S/N - FUENTESILA-LATORES(CE (OVIEDO). Cambio de objeto social. CNAE 8610. a) la prstaci贸n de servicios m茅dico quir煤rgicos en general, aplicables a todotipo de enfermedades humanas, con los medios diagn贸sticos y terap茅uticos apropiados, as铆 como la docencia sobre los mismos, todoello a traves de los correspondientes profesionales dotados con la titulaci贸n adec. Datos registrales. T 3611 , F 206, S 8, H AS 6402,I/A 62 (18.08.15).

24 de Marzo de 2015
Nombramientos. Apo.Sol.: GONZALEZ CARRILES FRANCISCO JAVIER. Apo.Manc.: GONZALEZ CARRILES FRANCISCOJAVIER;FERNANDEZ MENENDEZ LUIS MANUEL;SILVA RICO FRANCISCO;NORNIELLA MARTINEZ JOSE ADOLFO;LABRADAJIMENEZ FRANCISCO JAVIER. Datos registrales. T 3611 , F 205, S 8, H AS 6402, I/A 59 (16.03.15).

Nombramientos. Apoderado: GARCIA MENENDEZ MIGUEL. Datos registrales. T 3611 , F 206, S 8, H AS 6402, I/A 60 (16.03.15).

30 de Diciembre de 2014
Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 3611 , F 205, S 8, H AS 6402, I/A58 (19.12.14).

27 de Agosto de 2014
Nombramientos. Apo.Sol.: FERNANDEZ MENENDEZ LUIS MANUEL. Apo.Manc.: FERNANDEZ MENENDEZ LUIS MANUEL.Apo.Sol.: SILVA RICO FRANCISCO. Apo.Manc.: SILVA RICO FRANCISCO. Apo.Sol.: NORNIELLA MARTINEZ JOSE ADOLFO.Apo.Manc.: NORNIELLA MARTINEZ JOSE ADOLFO. Apo.Sol.: LABRADA JIMENEZ FRANCISCO JAVIER. Apo.Manc.: LABRADAJIMENEZ FRANCISCO JAVIER. Datos registrales. T 3611 , F 205, S 8, H AS 6402, I/A 57 (20.08.14).

21 de Marzo de 2012
Nombramientos. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 3611 , F 204, S 8, H AS 6402,I/A 56 ( 6.03.12).

22 de Noviembre de 2011
Revocaciones. Presidente: CANBAR INVERSIONES SL. Consejero: CARBAJO AVENDA脩O EDUARDO;MELCHOR FONSECACELESTINO;MENENDEZ PRADO JOSE;ALONSO LOPEZ LUIS. Nombramientos. Consejero: PROPIEDADES URBANASSOCIEDAD ANONIMA;POLICLINICO CENTRO MEDICO DE SEGUROS SA;RIOVEGUIN SL. Presidente: SOCIEDAD ANONIMATUDELA VEGUIN. Vicepresid.: RICHARD RODRIGUEZ JOSE MARIA. Reelecciones. Consejero: ANTU脩A ZAPICO JOSEMANUEL;SOCIEDAD ANONIMA TUDELA VEGUIN;RICHARD RODRIGUEZ JOSE MARIA;MASAVEU DE INVESTIGACIONES YDESARROLLO SL;CANBAR INVERSIONES SL;RICHARD GRANDIO SA. Modificaciones estatutarias. 18. Administraci贸n yRepresentacion.-. Datos registrales. T 3611 , F 204, S 8, H AS 6402, I/A 55 (11.11.11).

06 de Abril de 2011
Reelecciones. Auditor: FELIX FERNANDEZ DIAZ Y ONAINDIA AUDITORES SC. Datos registrales. T 3611 , F 203, S 8, H AS6402, I/A 51 (25.03.11).

Reelecciones. Auditor: FELIX FERNANDEZ DIAZ Y ONAINDIA AUDITORES SC. Datos registrales. T 3611 , F 203, S 8, H AS6402, I/A 52 (25.03.11).

16 de Septiembre de 2010
Otros conceptos: RATIFICACION POR LA JUNTA DEL CONSEJERO DESIGNADO POR COOPTACION "RICHARD GRANDIOS.A.". Datos registrales. T 3611 , F 203, S 8, H AS 6402, I/A 50 ( 6.09.10).

16 de Marzo de 2010
Nombramientos. Apoderado: MU脩IZ MU脩IZ JOSE ANTONIO. Datos registrales. T 3611 , F 202, S 8, H AS 6402, I/A 49 ( 3.03.10).

11 de Diciembre de 2009
Ceses/Dimisiones. Con.Delegado: RICHARD GRANDIO JOSE MARIA. Consejero: RICHARD GRANDIO JOSE MARIA.Nombramientos. Consejero: RICHARD GRANDIO SA. Datos registrales. T 3611 , F 202, S 8, H AS 6402, I/A 48 (30.11.09).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n