Actos BORME de Medicina Asturiana Sa
29 de Diciembre de 2023Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 4379 , F 11, S 8, H AS 6402, I/A 88(21.12.23).
07 de Septiembre de 2023Nombramientos. Apo.Manc.: LLAVONA FERNANDEZ RICARDO. Apo.Sol.: LLAVONA FERNANDEZ RICARDO. Datos registrales.T 4379 , F 10, S 8, H AS 6402, I/A 87 (29.08.23).
08 de Febrero de 2023Nombramientos. Apo.Sol.: MU脩IZ MU脩IZ JOSE ANTONIO;SAENZ DE SANTA MARIA PRIETO JOSE LUIS;PASTOR CABALLERO
07 de Febrero de 2023Revocaciones. Apo.Manc.: GARCIA MENENDEZ MIGUEL. Apo.Sol.: GARCIA MENENDEZ MIGUEL. Nombramientos. Apo.Sol.:FERNANDEZ MENENDEZ LUIS MANUEL;ZALDIVAR ALONSO PEDRO;TIRADOS FERNANDEZ JESUS. Apo.Manc.: FERNANDEZMENENDEZ LUIS MANUEL;ZALDIVAR ALONSO PEDRO;TIRADOS FERNANDEZ JESUS. Datos registrales. T 4379 , F 9, S 8, HAS 6402, I/A 84 (30.01.23).
02 de Noviembre de 2022Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 4379 , F 8, S 8, H AS 6402, I/A 82(24.10.22).
03 de Noviembre de 2021Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 4379 , F 8, S 8, H AS 6402, I/A 81(25.10.21).
30 de Julio de 2021Ceses/Dimisiones. Consejero: RABANAL GARCIA JAIME. Datos registrales. T 4379 , F 8, S 8, H AS 6402, I/A 80 (23.07.21).
29 de Enero de 2021Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 4379 , F 8, S 8, H AS 6402, I/A 78(21.01.21).
09 de Enero de 2020Fusi贸n por absorci贸n. Sociedades absorbidas: SCANNER ASTURIAS SA. RESONANCIA MAGNETICA DEL PRINCIPADO DEASTURIAS SL. PET CENTRO MEDICO DE ASTURIAS SL. Datos registrales. T 4221 , F 225, S 8, H AS 6402, I/A 77 (30.12.19).
02 de Septiembre de 2019Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 4221 , F 224, S 8, H AS 6402, I/A75 (22.08.19).
Ampliaci贸n de capital. Suscrito: 1.150.854,90 Euros. Desembolsado: 1.150.854,90 Euros. Resultante Suscrito: 5.274.135,60 Euros.Resultante Desembolsado: 5.274.135,60 Euros. Modificaciones estatutarias. Art铆culo de los estatutos: 5. Capital social.-. Datosregistrales. T 4221 , F 224, S 8, H AS 6402, I/A 76 (23.08.19).
11 de Enero de 2019Otros conceptos: Fallecido el apoderado de la sociedad Don Eduardo Carbajo Avenda帽o el 16 de enero de 2015. Datosregistrales. T 4221 , F 223, S 8, H AS 6402, I/A 74 ( 2.01.19).
11 de Diciembre de 2018Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 4221 , F 223, S 8, H AS 6402, I/A73 (30.11.18).
06 de Agosto de 2018Nombramientos. Consejero: RABANAL GARCIA JAIME. Datos registrales. T 4221 , F 223, S 8, H AS 6402, I/A 72 (27.07.18).
19 de Junio de 2018Revocaciones. Apo.Sol.: FERNANDEZ MENENDEZ LUIS MANUEL. Apo.Manc.: FERNANDEZ MENENDEZ LUIS MANUEL.Apo.Sol.: SILVA RICO FRANCISCO. Apo.Manc.: SILVA RICO FRANCISCO. Apo.Sol.: NORNIELLA MARTINEZ JOSE ADOLFO.Apo.Manc.: NORNIELLA MARTINEZ JOSE ADOLFO. Apo.Sol.: LABRADA JIMENEZ FRANCISCO JAVIER. Apo.Manc.: LABRADAJIMENEZ FRANCISCO JAVIER. Apoderado: GARCIA MENENDEZ MIGUEL. Apo.Sol.: GONZALEZ CARRILES FRANCISCO JAVIER.Apo.Manc.: GONZALEZ CARRILES FRANCISCO JAVIER;FERNANDEZ MENENDEZ LUIS MANUEL;SILVA RICOFRANCISCO;NORNIELLA MARTINEZ JOSE ADOLFO;LABRADA JIMENEZ FRANCISCO JAVIER. Nombramientos. Apoderado:FERNANDEZ MENENDEZ LUIS MANUEL. Datos registrales. T 4221 , F 222, S 8, H AS 6402, I/A 71 (12.06.18).
09 de Mayo de 2018Ceses/Dimisiones. SecreNoConsj: GONZALEZ APARICIO JESUS. Nombramientos. SecreNoConsj: SAENZ DE SANTA MARIAPRIETO JOSE LUIS. Datos registrales. T 4221 , F 222, S 8, H AS 6402, I/A 70 (26.04.18).
31 de Enero de 2018Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 4221 , F 222, S 8, H AS 6402, I/A69 (23.01.18).
25 de Julio de 2017Ceses/Dimisiones. Consejero: RICHARD RODRIGUEZ JOSE MARIA. Vicepresid.: RICHARD RODRIGUEZ JOSE MARIA.Reelecciones. Consejero: ANTU脩A ZAPICO JOSE MANUEL;CORPORACION MASAVEU SA;MASAVEU MEDICINA SL;CANBARINVERSIONES SL;RICHARD GRANDIO SA;MASAVEU INMOBILIARIA SA;POLICLINICO CENTRO MEDICO DE SEGUROSSA;RIOVEGUIN SL. Otros conceptos: FIJACION EN 8 EL NUMERO DE MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION.Datos registrales. T 4221 , F 222, S 8, H AS 6402, I/A 67 (17.07.17).
21 de Diciembre de 2016Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 4221 , F 222, S 8, H AS 6402, I/A66 (12.12.16).
30 de Junio de 2016Nombramientos. Apo.Sol.: GARCIA MENENDEZ MIGUEL. Apo.Manc.: GARCIA MENENDEZ MIGUEL. Datos registrales. T 3611 ,F 213, S 8, H AS 6402, I/A 65 (20.06.16).
16 de Diciembre de 2015Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 3611 , F 213, S 8, H AS 6402, I/A64 ( 4.12.15).
28 de Agosto de 2015Modificaciones estatutarias. Art铆culo de los estatutos: 2. Objeto.-. Art铆culo de los estatutos: 3. Domicilio.-. Otros conceptos:Modificaci贸n y refundici贸n de Estatutos. Cambio de domicilio social. AVDA RICHARD GRANDIO S/N - FUENTESILA-LATORES(CE (OVIEDO). Cambio de objeto social. CNAE 8610. a) la prstaci贸n de servicios m茅dico quir煤rgicos en general, aplicables a todotipo de enfermedades humanas, con los medios diagn贸sticos y terap茅uticos apropiados, as铆 como la docencia sobre los mismos, todoello a traves de los correspondientes profesionales dotados con la titulaci贸n adec. Datos registrales. T 3611 , F 206, S 8, H AS 6402,I/A 62 (18.08.15).
24 de Marzo de 2015Nombramientos. Apo.Sol.: GONZALEZ CARRILES FRANCISCO JAVIER. Apo.Manc.: GONZALEZ CARRILES FRANCISCOJAVIER;FERNANDEZ MENENDEZ LUIS MANUEL;SILVA RICO FRANCISCO;NORNIELLA MARTINEZ JOSE ADOLFO;LABRADAJIMENEZ FRANCISCO JAVIER. Datos registrales. T 3611 , F 205, S 8, H AS 6402, I/A 59 (16.03.15).
Nombramientos. Apoderado: GARCIA MENENDEZ MIGUEL. Datos registrales. T 3611 , F 206, S 8, H AS 6402, I/A 60 (16.03.15).
30 de Diciembre de 2014Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 3611 , F 205, S 8, H AS 6402, I/A58 (19.12.14).
27 de Agosto de 2014Nombramientos. Apo.Sol.: FERNANDEZ MENENDEZ LUIS MANUEL. Apo.Manc.: FERNANDEZ MENENDEZ LUIS MANUEL.Apo.Sol.: SILVA RICO FRANCISCO. Apo.Manc.: SILVA RICO FRANCISCO. Apo.Sol.: NORNIELLA MARTINEZ JOSE ADOLFO.Apo.Manc.: NORNIELLA MARTINEZ JOSE ADOLFO. Apo.Sol.: LABRADA JIMENEZ FRANCISCO JAVIER. Apo.Manc.: LABRADAJIMENEZ FRANCISCO JAVIER. Datos registrales. T 3611 , F 205, S 8, H AS 6402, I/A 57 (20.08.14).
21 de Marzo de 2012Nombramientos. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 3611 , F 204, S 8, H AS 6402,I/A 56 ( 6.03.12).
22 de Noviembre de 2011Revocaciones. Presidente: CANBAR INVERSIONES SL. Consejero: CARBAJO AVENDA脩O EDUARDO;MELCHOR FONSECACELESTINO;MENENDEZ PRADO JOSE;ALONSO LOPEZ LUIS. Nombramientos. Consejero: PROPIEDADES URBANASSOCIEDAD ANONIMA;POLICLINICO CENTRO MEDICO DE SEGUROS SA;RIOVEGUIN SL. Presidente: SOCIEDAD ANONIMATUDELA VEGUIN. Vicepresid.: RICHARD RODRIGUEZ JOSE MARIA. Reelecciones. Consejero: ANTU脩A ZAPICO JOSEMANUEL;SOCIEDAD ANONIMA TUDELA VEGUIN;RICHARD RODRIGUEZ JOSE MARIA;MASAVEU DE INVESTIGACIONES YDESARROLLO SL;CANBAR INVERSIONES SL;RICHARD GRANDIO SA. Modificaciones estatutarias. 18. Administraci贸n yRepresentacion.-. Datos registrales. T 3611 , F 204, S 8, H AS 6402, I/A 55 (11.11.11).
06 de Abril de 2011Reelecciones. Auditor: FELIX FERNANDEZ DIAZ Y ONAINDIA AUDITORES SC. Datos registrales. T 3611 , F 203, S 8, H AS6402, I/A 51 (25.03.11).
Reelecciones. Auditor: FELIX FERNANDEZ DIAZ Y ONAINDIA AUDITORES SC. Datos registrales. T 3611 , F 203, S 8, H AS6402, I/A 52 (25.03.11).
16 de Septiembre de 2010Otros conceptos: RATIFICACION POR LA JUNTA DEL CONSEJERO DESIGNADO POR COOPTACION "RICHARD GRANDIOS.A.". Datos registrales. T 3611 , F 203, S 8, H AS 6402, I/A 50 ( 6.09.10).
16 de Marzo de 2010Nombramientos. Apoderado: MU脩IZ MU脩IZ JOSE ANTONIO. Datos registrales. T 3611 , F 202, S 8, H AS 6402, I/A 49 ( 3.03.10).
11 de Diciembre de 2009Ceses/Dimisiones. Con.Delegado: RICHARD GRANDIO JOSE MARIA. Consejero: RICHARD GRANDIO JOSE MARIA.Nombramientos. Consejero: RICHARD GRANDIO SA. Datos registrales. T 3611 , F 202, S 8, H AS 6402, I/A 48 (30.11.09).