Buscador CIF Logo

Actos BORME Medicion Avanzada De Contadores Sa

驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Medicion Avanzada De Contadores Sa

Actos BORME Medicion Avanzada De Contadores Sa - A96674460

Tenemos registrados 25 Actos BORME del Registro Mercantil de Valencia para Medicion Avanzada De Contadores Sa con CIF A96674460

馃敊 Perfil de Medicion Avanzada De Contadores Sa
馃洅 Comprar listado completo de Empresas de Valencia

Actos BORME de Medicion Avanzada De Contadores Sa

21 de Septiembre de 2023
Cambio de objeto social. 1.- La Sociedad tiene por objeto social: A) La gesti贸n y explotaci贸n de los siguientes servicios: a)Abastecimiento de agua potable a poblaciones. b) Saneamiento, evacuaci贸n y depuraci贸n de aguas residuales. c) Suministro de aguapara usos agr铆colas o industriales. d) Construcci贸n, conservaci贸n y ex. Datos registrales. T 7398, L 4699, F 45, S 8, H V 57193, I/A42 (14.09.23).

20 de Julio de 2023
Reelecciones. Adm. Unico: CALABUIG GIMENO EUGENIO. Datos registrales. T 7398, L 4699, F 44, S 8, H V 57193, I/A 41(12.07.23).

02 de Enero de 2023
Revocaciones. Apo.Sol.: MARQUES ALONSO ALFREDO;RODRIGUEZ FORTIS HECTOR. Nombramientos. Apo.Sol.: AYZAPRATS MANUEL;RODRIGUEZ FORTIS HECTOR. Datos registrales. T 7398, L 4699, F 44, S 8, H V 57193, I/A 39 (23.12.22).

23 de Agosto de 2022
Nombramientos. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 7398, L 4699, F 43, S 8, H V 57193, I/A 38 (16.08.22).

14 de Julio de 2022
Nombramientos. Apoderado: MICO ALBUIXECH SOFIA. Datos registrales. T 7398, L 4699, F 42, S 8, H V 57193, I/A 37 ( 7.07.22).

01 de Abril de 2022
Nombramientos. Apo.Manc.: MAESTRE PICON JUAN FRANCISCO;FAYOS MI脩ANA GLORIA;SANCHO IRANZO HELIODORO.Datos registrales. T 7398, L 4699, F 42, S 8, H V 57193, I/A 35 (25.03.22).

Revocaciones. Apoderado: MAESTRE PICON JUAN FRANCISCO. Nombramientos. Apoderado: MAESTRE PICON JUANFRANCISCO. Datos registrales. T 7398, L 4699, F 42, S 8, H V 57193, I/A 36 (25.03.22).

28 de Enero de 2021
Nombramientos. Apoderado: MAESTRE PICON JUAN FRANCISCO. Datos registrales. T 7398, L 4699, F 42, S 8, H V 57193, I/A34 (21.01.21).

08 de Enero de 2021
Revocaciones. Apo.Sol.: PEREZ PALOMAR JUAN JOSE;FAYOS MI脩ANA GLORIA;SANCHO IRANZO HELIODORO.Nombramientos. Apo.Sol.: MACIAN CERVERA JAVIER;FAYOS MI脩ANA GLORIA;SANCHO IRANZO HELIODORO. Datosregistrales. T 7398, L 4699, F 9, S 8, H V 57193, I/A 31 (30.12.20).

Revocaciones. Apo.Man.Soli: MARTINEZ MICO JUAN JOSE;MELCHOR IBA脩EZ AGUSTIN;PEREZ PALOMAR JUANJOSE;FAJARDO MONTA脩ANA VICENTE. Nombramientos. Apo.Manc.: MARTINEZ MICO JUAN JOSE;MELCHOR IBA脩EZAGUSTIN;FAJARDO MONTA脩ANA VICENTE;MACIAN CERVERA JAVIER. Datos registrales. T 7398, L 4699, F 9, S 8, H V 57193,I/A 32 (30.12.20).

Nombramientos. Apo.Sol.: CLAVEL PADRO JOSE MARIA;SANCHIS LLEDO FERNANDO JOSE;LASERNA GUZMANSOLEDAD;CHAFER MI脩ANA REMEDIOS. Datos registrales. T 7398, L 4699, F 41, S 8, H V 57193, I/A 33 (30.12.20).

08 de Julio de 2020
Revocaciones. Apo.Manc.: MARTINEZ MICO JUAN JOSE;SANCHEZ MOLINO ENRIQUE;PEREZ PALOMAR JUANJOSE;FAJARDO MONTA脩ANA VICENTE;RAMOS APARICI SEVERINO. Nombramientos. Apo.Man.Soli: MARTINEZ MICO JUANJOSE;MELCHOR IBA脩EZ AGUSTIN;PEREZ PALOMAR JUAN JOSE;FAJARDO MONTA脩ANA VICENTE. Datos registrales. T 7398,L 4699, F 7, S 8, H V 57193, I/A 30 ( 1.07.20).

22 de Noviembre de 2019
Nombramientos. Apo.Sol.: MARQUES ALONSO ALFREDO;RODRIGUEZ FORTIS HECTOR. Datos registrales. T 7398, L 4699, F6, S 8, H V 57193, I/A 27 (15.11.19).

Nombramientos. Apo.Sol.: PEREZ PALOMAR JUAN JOSE;FAYOS MI脩ANA GLORIA;SANCHO IRANZO HELIODORO. Datosregistrales. T 7398, L 4699, F 7, S 8, H V 57193, I/A 28 (15.11.19).

Nombramientos. Apoderado: FAJARDO MONTA脩ANA VICENTE. Datos registrales. T 7398, L 4699, F 7, S 8, H V 57193, I/A 29(15.11.19).

07 de Agosto de 2018
Reelecciones. Adm. Unico: CALABUIG GIMENO EUGENIO. Datos registrales. T 7398, L 4699, F 6, S 8, H V 57193, I/A 26(31.07.18).

01 de Marzo de 2018
Revocaciones. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 7398, L 4699, F 6, S 8, H V 57193, I/A 25 (22.02.18).

13 de Enero de 2017
Revocaciones. Apo.Manc.: BELLIDO BOADA RAMON. Datos registrales. T 7398, L 4699, F 6, S 8, H V 57193, I/A 24 ( 5.01.17).

23 de Diciembre de 2015
Nombramientos. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 7398, L 4699, F 6, S 8, H V 57193, I/A 23 (16.12.15).

28 de Abril de 2015
Nombramientos. Apo.Manc.: RAMOS APARICI SEVERINO. Datos registrales. T 7398, L 4699, F 6, S 8, H V 57193, I/A 22(21.04.15).

13 de Marzo de 2015
Revocaciones. Apoderado: ZORRILLA SORIANO FRANCISCO LUIS. Nombramientos. Apo.Manc.: MARTINEZ MICO JUANJOSE;SANCHEZ MOLINO ENRIQUE;PEREZ PALOMAR JUAN JOSE;FAJARDO MONTA脩ANA VICENTE;BELLIDO BOADA RAMON.Datos registrales. T 7398, L 4699, F 4, S 8, H V 57193, I/A 21 ( 6.03.15).

23 de Febrero de 2015
Nombramientos. Apoderado: MAESTRE PICON JUAN FRANCISCO. Datos registrales. T 7398, L 4699, F 4, S 8, H V 57193, I/A 20(16.02.15).

24 de Julio de 2014
Nombramientos. Apo.Sol.: GARCIA COMIN DIONISIO. Datos registrales. T 7398, L 4699, F 2, S 8, H V 57193, I/A 19 (17.07.14).

01 de Julio de 2013
Reelecciones. Adm. Unico: CALABUIG GIMENO EUGENIO. Datos registrales. T 7398, L 4699, F 2, S 8, H V 57193, I/A 18(24.06.13).

07 de Junio de 2011
Nombramientos. Apo.Sol.: DELGADO IZQUIERDO JOSE LUIS;ESCUIN MU脩OZ CRISTINA;MARQUES ALONSO ALFREDO.Datos registrales. T 7398, L 4699, F 2, S 8, H V 57193, I/A 17 (27.05.11).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n