Buscador CIF Logo

Actos BORME Medidas Ambientales Sl

¿Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la información de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Medidas Ambientales Sl

Actos BORME Medidas Ambientales Sl - B81456618

Tenemos registrados 18 Actos BORME del Registro Mercantil de Burgos para Medidas Ambientales Sl con CIF B81456618

🔙 Perfil de Medidas Ambientales Sl
🛒 Comprar listado completo de Empresas de Burgos

Actos BORME de Medidas Ambientales Sl

04 de Agosto de 2023
Ceses/Dimisiones. Presidente: PEREZ SANCHO JUAN RAMON. SecreNoConsj: DIAZ MARROQUIN FERNANDO.Nombramientos. Apo.Sol.: CHAMORRO GARIJO JOSE ANTONIO. SecreNoConsj: BERMUDEZ LANE ALEX. Presidente: GUERRASAIZ FRANCISCO JAVIER. Apo.Sol.: PEREZ SANCHO JUAN RAMON;CHAMORRO GARIJO JOSE ANTONIO;GARCIA PERULLESEMILIO;MARTIN CACHO ANA MARIA. Datos registrales. T 799, L 590, F 223, S 8, H BU 8844, I/A 30 (28.07.23).

24 de Noviembre de 2022
Revocaciones. Apo.Man.Soli: MARTIN CACHO ANA MARIA. Apo.Manc.: OTAMENDI CARRILLO ERASMO. Nombramientos.Apo.Man.Soli: MARTIN CACHO ANA MARIA. Apo.Manc.: SANCHEZ ALVAREZ FRANCISCO JOSE;ALFAYATE RODRIGUEZMARIANO. Datos registrales. T 782, L 573, F 148, S 8, H BU 8844, I/A 29 (18.11.22).

24 de Septiembre de 2021
Nombramientos. Auditor: GRANT THORNTON SLP. Datos registrales. T 782, L 573, F 147, S 8, H BU 8844, I/A 28 (17.09.21).

15 de Julio de 2021
Revocaciones. Apoderado: MARTIN CACHO ANA MARIA. Nombramientos. Apo.Man.Soli: MARTIN CACHO ANA MARIA.Apo.Manc.: OTAMENDI CARRILLO ERASMO. Datos registrales. T 739, L 530, F 20, S 8, H BU 8844, I/A 27 ( 9.07.21).

26 de Marzo de 2021
Ceses/Dimisiones. Consejero: TORRALBO ESTRADA JOSE RAMON;FERNANDEZ GONZALEZ RENE;PEREZ SANCHO JUANRAMON;ALVAREZ MEZQUIRIZ MARIA JOSE. Presidente: TORRALBO ESTRADA JOSE RAMON. SecreNoConsj: VALERO ARTOLACARLOS. Nombramientos. Consejero: PEREZ SANCHO JUAN RAMON;GARCIA PERULLES EMILIO;GUERRA SAIZ FRANCISCOJAVIER;CHAMORRO GARIJO JOSE ANTONIO. Presidente: PEREZ SANCHO JUAN RAMON. SecreNoConsj: DIAZ MARROQUINFERNANDO. Datos registrales. T 739, L 530, F 14, S 8, H BU 8844, I/A 24 (19.03.21).

Modificaciones estatutarias. MODIFICADA LA REDACCION DE TODOS LOS ESTATUTOS SOCIALES.. Datos registrales. T 739,L 530, F 15, S 8, H BU 8844, I/A 25 (19.03.21).

Revocaciones. Apo.Man.Soli: MARTIN CACHO ANA MARIA. Apo.Sol.: TORRALBO ESTRADA JOSE RAMON;FERNANDEZGONZALEZ RENE. Apo.Man.Soli: BILBAO REY JOSE LUIS;PEREZ GARIJO JUAN;SUAREZ GONZALEZ ISIDRO;GARCIA MARTINJUAN Nombramientos. Apoderado: MARTIN CACHO ANA MARIA. Datos registrales. T 739, L 530, F 18, S 8, H BU 8844, I/A 26(19.03.21).

01 de Agosto de 2018
Reelecciones. Consejero: TORRALBO ESTRADA JOSE RAMON;FERNANDEZ GONZALEZ RENE. Presidente: TORRALBOESTRADA JOSE RAMON. Datos registrales. T 739, L 530, F 14, S 8, H BU 8844, I/A 23 (26.07.18).

04 de Enero de 2018
Revocaciones. Apoderado: DEL VALLE IÑIGUEZ BEGOÑA;SANCHEZ DIAZ MARIA BELEN. Apo.Sol.: HURTADO ENCINARJULIAN. Nombramientos. Apoderado: ARROYO SOUTO MANUEL. Apo.Man.Soli: BILBAO REY JOSE LUIS;DEL VALLE IÑIGUEZBEGOÑA;SANCHEZ DIAZ MARIA BELEN;PEREZ GARIJO JUAN;DE LA HOZ NOMBELA FRANCISCO;SUAREZ GONZALEZISIDRO;ARROYO SOUTO MANUEL;GARCIA MARTIN JUAN. Datos registrales. T 715, L 506, F 18, S 8, H BU 8844, I/A 22(28.12.17).

20 de Julio de 2016
Nombramientos. Consejero: ALVAREZ MEZQUIRIZ MARIA JOSE. Datos registrales. T 560, L 351, F 86, S 8, H BU 8844, I/A 20(13.07.16).

Nombramientos. Apoderado: GARCIA PERULLES EMILIO. Datos registrales. T 560, L 351, F 87, S 8, H BU 8844, I/A 21(13.07.16).

03 de Mayo de 2016
Ceses/Dimisiones. Consejero: ARCE ALONSO EMILIO. Secretario: GUTIERREZ ROZAS FERNANDEZ JOSE MARIA.Cancelaciones de oficio de nombramientos. Consejero: ALVAREZ MEZQUIRIZ MARIA JOSE. Revocaciones. Apoderado: ARCEALONSO EMILIO. Nombramientos. Consejero: PEREZ SANCHO JUAN RAMON. Apoderado: PEREZ SANCHO JUAN RAMON.SecreNoConsj: VALERO ARTOLA CARLOS. Datos registrales. T 560, L 351, F 84, S 8, H BU 8844, I/A 19 (26.04.16).

28 de Abril de 2015
Nombramientos. Apo.Sol.: HURTADO ENCINAR JULIAN. Datos registrales. T 560, L 351, F 84, S 8, H BU 8844, I/A 18 (22.04.15).

05 de Septiembre de 2013
Nombramientos. Consejero: ALVAREZ MEZQUIRIZ MARIA JOSE. Datos registrales. T 560, L 351, F 82, S 8, H BU 8844, I/A 16(29.08.13).

Ceses/Dimisiones. Presidente: OLASO LOPEZ FRANCISCO JAVIER. Consejero: OLASO LOPEZ FRANCISCO JAVIER;CONDEEZQUERRA JULIO. Revocaciones. Apoderado: OLASO LOPEZ FRANCISCO JAVIER;CONDE EZQUERRA JULIO.Nombramientos. Consejero: TORRALBO ESTRADA JOSE RAMON. Apo.Sol.: TORRALBO ESTRADA JOSE RAMON. Consejero:FERNANDEZ GONZALEZ RENE. Presidente: TORRALBO ESTRADA JOSE RAMON. Apo.Sol.: FERNANDEZ GONZALEZ RENE.Datos registrales. T 560, L 351, F 82, S 8, H BU 8844, I/A 17 (29.08.13).

26 de Julio de 2011
Cancelaciones de oficio de nombramientos. Consejero: ALVAREZ MEZQUIRIZ MARIA JOSE. Reelecciones. Presidente: OLASOLOPEZ FRANCISCO JAVIER. Consejero: OLASO LOPEZ FRANCISCO JAVIER;CONDE EZQUERRA JULIO. Datos registrales. T560, L 351, F 82, S 8, H BU 8844, I/A 15 (14.07.11).

05 de Mayo de 2011
Ceses/Dimisiones. Consejero: RODRIGUEZ BAQUERO JAVIER. Nombramientos. Consejero: ARCE ALONSO EMILIO. Datosregistrales. T 560, L 351, F 80, S 8, H BU 8844, I/A 13 (25.04.11).

Revocaciones. Apo.Sol.: RODRIGUEZ BAQUERO JAVIER. Nombramientos. Apoderado: ARCE ALONSO EMILIO. Datosregistrales. T 560, L 351, F 80, S 8, H BU 8844, I/A 14 (25.04.11).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades analíticas, de personalización, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnología. Si acepta o continúa navegando, consideramos que está de acuerdo con su uso. Mas información