Buscador CIF Logo

Actos BORME Medin 1 Sa

¿Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la información de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Medin 1 Sa

Actos BORME Medin 1 Sa - A58611278

Tenemos registrados 14 Actos BORME del Registro Mercantil de Barcelona para Medin 1 Sa con CIF A58611278

🔙 Perfil de Medin 1 Sa
🛒 Comprar listado completo de Empresas de Barcelona

Actos BORME de Medin 1 Sa

08 de Noviembre de 2022
Nombramientos. AUDIT.CUENT.: ETL & AOB AUDITORES SL. Datos registrales. T 30218 , F 118, S 8, H B 47492, I/A 27(31.10.22).

27 de Octubre de 2020
Nombramientos. APODERAD.SOL: JIMENEZ CERVERA MIGUEL. Datos registrales. T 30218 , F 117, S 8, H B 47492, I/A 26(16.10.20).

03 de Octubre de 2019
Nombramientos. AUDIT.CUENT.: UNIAUDIT OLIVER CAMPS SL. Datos registrales. T 30218 , F 117, S 8, H B 47492, I/A 25(25.09.19).

13 de Junio de 2019
Nombramientos. ADM.SOLIDAR.: PEREIRAS VAZQUEZ ESTHER;JIMENEZ PEREIRAS DACHA. Datos registrales. T 30218 , F117, S 8, H B 47492, I/A 24 ( 4.06.19).

25 de Octubre de 2016
Nombramientos. AUDIT.CUENT.: UNIAUDIT OLIVER CAMPS SL. Datos registrales. T 30218 , F 117, S 8, H B 47492, I/A 23(17.10.16).

07 de Octubre de 2015
Nombramientos. APODERAD.SOL: JIMENEZ CERVERA MIGUEL. Datos registrales. T 30218 , F 116, S 8, H B 47492, I/A 22(29.09.15).

06 de Agosto de 2015
Modificaciones estatutarias. ARTICULO VIGESIMO OCTAVO: SISTEMA RETRIBUTIVO DEL ORGANO DE ADMINISTRACIONSOCIAL. Datos registrales. T 30218 , F 116, S 8, H B 47492, I/A 21 (30.07.15).

26 de Mayo de 2014
Nombramientos. AUDIT.CUENT.: OLIVER CAMPS AUDITORS I CONSULTORS SL. Datos registrales. T 30218 , F 116, S 8, H B47492, I/A 20 (16.05.14).

02 de Septiembre de 2013
Revocaciones. CONSEJERO: JIMENEZ CERVERA MIGUEL. PRESIDENTE: JIMENEZ CERVERA MIGUEL. CONS. DELEG.:JIMENEZ CERVERA MIGUEL. CONSEJERO: PEREIRAS VAZQUEZ ESTHER. SECRETARIO: PEREIRAS VAZQUEZ ESTHER.CONS. DELEG.: PEREIRAS VAZQUEZ ESTHER. CONSEJERO: JIMENEZ PEREIRAS DACHA. CONS. DELEG.: JIMENEZPEREIRAS DACHA. Nombramientos. ADM.SOLIDAR.: PEREIRAS VAZQUEZ ESTHER;JIMENEZ PEREIRAS DACHA.Modificaciones estatutarias. MODIFICACION ARTS.14,23,26,DEJANDO SIN CONTENIDO EL ART.27 BIS:CAMBIO DE REGIMENADMINISTRATIVO. Datos registrales. T 30218 , F 115, S 8, H B 47492, I/A 19 (22.08.13).

15 de Abril de 2013
Nombramientos. CONSEJERO: JIMENEZ CERVERA MIGUEL. PRESIDENTE: JIMENEZ CERVERA MIGUEL. CONS. DELEG.:JIMENEZ CERVERA MIGUEL. CONSEJERO: PEREIRAS VAZQUEZ ESTHER. SECRETARIO: PEREIRAS VAZQUEZ ESTHER.CONS. DELEG.: PEREIRAS VAZQUEZ ESTHER. CONSEJERO: JIMENEZ PEREIRAS DACHA. CONS. DELEG.: JIMENEZPEREIRAS DACHA. Datos registrales. T 30218 , F 115, S 8, H B 47492, I/A 18 ( 5.04.13).

21 de Noviembre de 2011
Cambio de objeto social. AMPLIAR A: ACTIVIDADES DE CONSULTORIA,ASESORAMIENTO E INFORMACION,TANTODEPERSONAS FISICAS COMO JURIDICAS,COMPRENDIENDO TODO TIPO DE GESTION,TRAMITACION Y ASESORAMIENTOEN MATERIA LABORAL,FISCAL,CONTABLE,TENEDURIA... Datos registrales. T 30218 , F 115, S 8, H B 47492, I/A 17 ( 9.11.11).

28 de Febrero de 2011
Nombramientos. APODERADO: CORTADELLAS TORRUELLA PEDRO. Datos registrales. T 30218 , F 114, S 8, H B 47492, I/A 16(15.02.11).

19 de Octubre de 2010
Nombramientos. AUDIT.CUENT.: OLIVER Y CAMPS AUDITORES ASOCIADOS SA. Datos registrales. T 30218 , F 114, S 8, H B47492, I/A 15 ( 6.10.10).

05 de Marzo de 2010
Otros conceptos: RECTIFICACION DE LA INSCRIPCION 12 EN CUANTO A LA FORMA DE ACTUACION DE LOS CONSEJEROSDELEGADOS,SIENDO LA MISMA LA FORMA DE ACTUACION DE INDISTINTA. Datos registrales. T 30218 , F 114, S 8, H B47492, I/A 14 (22.02.10).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades analíticas, de personalización, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnología. Si acepta o continúa navegando, consideramos que está de acuerdo con su uso. Mas información