Actos BORME de Medina Garvey Comercial Sl
22 de Noviembre de 2023Reducción de capital. Importe reducción: 1.250.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 580.000,00 Euros. Modificaciones estatutarias.Artículo de los estatutos: 6. Capital social.-. Datos registrales. T 6060 , F 218, S 8, H SE 51710, I/A 18 (13.11.23).
25 de Junio de 2021Ampliación de capital. Capital: 530.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 1.830.000,00 Euros. Modificaciones estatutarias. Artículode los estatutos: 6. Capital social.-. Datos registrales. T 6060 , F 218, S 8, H SE 51710, I/A 17 (15.06.21).
24 de Febrero de 2021Ampliación de capital. Capital: 800.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 1.300.000,00 Euros. Modificaciones estatutarias. Artículode los estatutos: 6. Capital social.-. Datos registrales. T 6060 , F 159, S 8, H SE 51710, I/A 16 (12.02.21).
18 de Diciembre de 2020Nombramientos. Apoderado: BERNAL QUINTERO JUAN LUIS. Datos registrales. T 6060 , F 159, S 8, H SE 51710, I/A 14(10.12.20).
Nombramientos. Apoderado: BORRERO GOIZUETA IGNACIO. Datos registrales. T 6060 , F 159, S 8, H SE 51710, I/A 15(11.12.20).
10 de Julio de 2020Otros conceptos: "MEDINA GARVEY, S.A." designa como nuevo representante persona física a Don Joaquín Piñar Goizueta, conD.N.I. número 28.623.399-Z, para el ejercicio del cargo de Administradora única. Datos registrales. T 6060 , F 158, S 8, H SE 51710,I/A 13 ( 3.07.20).
22 de Marzo de 2019Ceses/Dimisiones. Consejero: CONRADI RAMIREZ LUIS;CONRADI RAMIREZ MERCEDES;LA TORRE DEL ALJARAFESL;ALYRAID SL;COCA BARRIONUEVO MIGUEL JOSE. Presidente: ALYRAID SL. Con.Delegado: ALYRAID SL. Vicepresid.:CONRADI RAMIREZ MERCEDES. Secretario: CONRADI RAMIREZ LUIS. Nombramientos. Adm. Unico: MEDINA GARVEY SA.Modificaciones estatutarias. 1. Denominación social.- Se modifican la totalidad de los Estatutos Sociales, cuyo nuevo textocomprende los artículos 1º al 36º, inclusive.- . Otros conceptos: Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración aAdministrador único. Datos registrales. T 3642 , F 77, S 8, H SE 51710, I/A 12 (12.03.19).
22 de Septiembre de 2016Ceses/Dimisiones. Consejero: MEDINA MEDINA BLANCA;MEDINA CONRADI CASILDA. Nombramientos. Consejero: COCABARRIONUEVO MIGUEL JOSE. Reelecciones. Presidente: ALYRAID SL. Con.Delegado: ALYRAID SL. Vicepresid.: CONRADIRAMIREZ MERCEDES. Secretario: CONRADI RAMIREZ LUIS. Datos registrales. T 3642 , F 76, S 8, H SE 51710, I/A 11 (13.09.16).
26 de Junio de 2015Nombramientos. Apoderado: BORRERO GOIZUETA IGNACIO. Datos registrales. T 3642 , F 75, S 8, H SE 51710, I/A 10(18.06.15).
24 de Diciembre de 2014Nombramientos. Auditor: RUBIO MEMBRIVE Y GISBERT SOCIEDAD LIMITADA PROFESI. Datos registrales. T 3642 , F 75, S 8,H SE 51710, I/A 9 (12.12.14).
19 de Enero de 2012Reelecciones. Auditor: RUBIO MEMBRIVE Y GISBERT SOCIEDAD LIMITADA PROFESI. Datos registrales. T 3642 , F 75, S 8, HSE 51710, I/A 8 ( 9.01.12).
14 de Junio de 2011Ceses/Dimisiones. Consejero: MEDINA FERNANDEZ DE CORDOBA LUIS. Presidente: MEDINA FERNANDEZ DE CORDOBALUIS. Consejero: BORRERO PASCUAL IGNACIO. Con.Delegado: BORRERO PASCUAL IGNACIO. Vicepresid.: MEDINA MEDINABLANCA. Nombramientos. Consejero: MEDINA CONRADI CASILDA. Presidente: ALYRAID SL. Consejero: ALYRAID SL.Vicepresid.: CONRADI RAMIREZ MERCEDES. Con.Delegado: ALYRAID SL. Apoderado: CONRADI RAMIREZ MERCEDES. Datosregistrales. T 3642 , F 73, S 8, H SE 51710, I/A 7 (25.05.11).
01 de Diciembre de 2009Nombramientos. Apoderado: PIÑAR GOIZUETA JOAQUIN. Datos registrales. T 3642 , F 73, S 8, H SE 51710, I/A 6 (20.11.09).