Buscador CIF Logo

Actos BORME Medina Garvey Electricidad Sl

¿Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la información de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Medina Garvey Electricidad Sl

Actos BORME Medina Garvey Electricidad Sl - B91632190

Tenemos registrados 17 Actos BORME del Registro Mercantil de Sevilla para Medina Garvey Electricidad Sl con CIF B91632190

🔙 Perfil de Medina Garvey Electricidad Sl
🛒 Comprar listado completo de Empresas de Sevilla

Actos BORME de Medina Garvey Electricidad Sl

22 de Noviembre de 2023
Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: MEDINA GARVEY SA. Nombramientos. Adm. Unico: PIÑAR GOIZUETA JOAQUIN. Datosregistrales. T 6913 , F 102, S 8, H SE 74147, I/A 23 (14.11.23).

26 de Agosto de 2021
Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 6913 , F 102, S 8, H SE 74147, I/A 22 (13.08.21).

18 de Diciembre de 2020
Nombramientos. Apoderado: BERNAL QUINTERO JUAN LUIS. Datos registrales. T 6913 , F 101, S 8, H SE 74147, I/A 20(10.12.20).

Nombramientos. Apoderado: BORRERO GOIZUETA IGNACIO. Datos registrales. T 6913 , F 101, S 8, H SE 74147, I/A 21(11.12.20).

19 de Octubre de 2020
Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 4875 , F 149, S 8, H SE 74147, I/A 19 ( 8.10.20).

01 de Abril de 2019
Ceses/Dimisiones. SecreNoConsj: CONRADI RAMIREZ LUIS. Consejero: ALYRAID SL. Presidente: ALYRAID SL. Consejero:CONRADI RAMIREZ MERCEDES. Vicepresid.: CONRADI RAMIREZ MERCEDES. Consejero: LA TORRE DEL ALJARAFE SL;COCABARRIONUEVO MIGUEL JOSE. Con.Delegado: ALYRAID SL. Nombramientos. Adm. Unico: MEDINA GARVEY SA.Modificaciones estatutarias. Se modifican en su integridad los Estatutos Sociales refundiéndolos en un texto que comprende losartículos 1º al 36º, inclusive.- . Otros conceptos: Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administradorúnico. Datos registrales. T 4875 , F 146, S 8, H SE 74147, I/A 18 (19.03.19).

27 de Diciembre de 2017
Nombramientos. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 4875 , F 146, S 8, H SE 74147, I/A 17 (13.10.17).

27 de Abril de 2017
Modificaciones estatutarias. Artículo de los estatutos: MODIFICACION DEL ARTICULO 2º DE LOS ESTATUTOS SOCIALES.Ampliacion del objeto social. el transporte y la distribución de energía eléctrica, así como construir, mantener y operar lasinstalaciones de transporte y distribución destinadas a situar la energía en los puntos de consumo, con sujeción, en todo caso, a lasprescripciones de la legislación aplicable en cada momento al Sector. Datos registrales. T 4875 , F 145, S 8, H SE 74147, I/A 16(20.04.17).

27 de Enero de 2017
Modificaciones estatutarias. Artículo de los estatutos: 2. Objeto social.-. Cambio de objeto social. ejercicio, con carácterexclusivo, de la actividad de distribución de energía eléctrica. Datos registrales. T 4875 , F 145, S 8, H SE 74147, I/A 15 (18.01.17).

23 de Agosto de 2016
Ceses/Dimisiones. Con.Delegado: IGNACIO BORRERO PASCUAL. Consejero: MEDINA CONRADI CASILDA;ALYRAID SL.Presidente: ALYRAID SL. Con.Delegado: ALYRAID SL. Consejero: LA TORRE DEL ALJARAFE SL;CONRADI RAMIREZ MERCEDES.Vicepresid.: CONRADI RAMIREZ MERCEDES. Secretario: CONRADI RAMIREZ LUIS. Consejero: MEDINA MEDINABLANCA;CONRADI RAMIREZ LUIS. Nombramientos. Consejero: ALYRAID SL. Presidente: ALYRAID SL. Consejero: CONRADIRAMIREZ MERCEDES. Vicepresid.: CONRADI RAMIREZ MERCEDES. Consejero: LA TORRE DEL ALJARAFE SL;COCABARRIONUEVO MIGUEL JOSE. SecreNoConsj: CONRADI RAMIREZ LUIS. Con.Delegado: ALYRAID SL. Datos registrales. T 4875, F 144, S 8, H SE 74147, I/A 14 (10.08.16).

26 de Junio de 2015
Nombramientos. Apoderado: BORRERO GOIZUETA IGNACIO. Datos registrales. T 4875 , F 143, S 8, H SE 74147, I/A 13(18.06.15).

24 de Diciembre de 2014
Nombramientos. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 4875 , F 143, S 8, H SE 74147, I/A 12 (12.12.14).

12 de Diciembre de 2012
Reelecciones. Auditor: RUBIO MEMBRIVE Y GISBERT SOCIEDAD LIMITADA PROFESI. Datos registrales. T 4875 , F 143, S 8, HSE 74147, I/A 11 ( 3.12.12).

04 de Abril de 2012
Nombramientos. Apoderado: CONRADI RAMIREZ MERCEDES. Reelecciones. Consejero: CONRADI RAMIREZ MERCEDES.Vicepresid.: CONRADI RAMIREZ MERCEDES. Secretario: CONRADI RAMIREZ LUIS. Consejero: MEDINA MEDINABLANCA;CONRADI RAMIREZ LUIS. Datos registrales. T 4875 , F 142, S 8, H SE 74147, I/A 10 (20.03.12).

09 de Junio de 2011
Ceses/Dimisiones. Consejero: MEDINA FERNANDEZ DE CORDOBA LUIS. Con.Delegado: MEDINA FERNANDEZ DE CORDOBALUIS. Presidente: MEDINA FERNANDEZ DE CORDOBA LUIS. Consejero: BORRERO PASCUAL IGNACIO. Vicepresid.: MEDINAMEDINA BLANCA. Nombramientos. Consejero: MEDINA CONRADI CASILDA;ALYRAID SL. Presidente: ALYRAID SL. Vicepresid.:CONRADI RAMIREZ MERCEDES. Con.Delegado: ALYRAID SL. Apoderado: CONRADI RAMIREZ MERCEDES. Reelecciones.Secretario: CONRADI RAMIREZ LUIS. Consejero: LA TORRE DEL ALJARAFE SL. Datos registrales. T 4875 , F 140, S 8, H SE74147, I/A 8 (31.05.11).

Nombramientos. Auditor: RUBIO MEMBRIVE Y GISBERT SOCIEDAD LIMITADA PROFESI. Datos registrales. T 4875 , F 142, S 8,H SE 74147, I/A 9 (31.05.11).

30 de Enero de 2009
Nombramientos. Apoderado: HIDROCANTABRICO ENERGIA S.A. Datos registrales. T 4875 , F 139, S 8, H SE 74147, I/A 7(20.01.09).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades analíticas, de personalización, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnología. Si acepta o continúa navegando, consideramos que está de acuerdo con su uso. Mas información