Buscador CIF Logo

Actos BORME Mediterranea De Tecnologias Sl

驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Mediterranea De Tecnologias Sl

Actos BORME Mediterranea De Tecnologias Sl - B54469242

Tenemos registrados 14 Actos BORME del Registro Mercantil de Alicante para Mediterranea De Tecnologias Sl con CIF B54469242

馃敊 Perfil de Mediterranea De Tecnologias Sl
馃洅 Comprar listado completo de Empresas de Alicante

Actos BORME de Mediterranea De Tecnologias Sl

13 de Febrero de 2023
Ceses/Dimisiones. Liquidador: CORPORACION EMPRESARIAL VECTALIA SA. Adm. Unico: CORPORACION EMPRESARIALVECTALIA SA. Nombramientos. Liquidador: CORPORACION EMPRESARIAL VECTALIA SA. Disoluci贸n. Voluntaria. Extinci贸n.Datos registrales. T 3694 , F 207, S 8, H A 121326, I/A 14 ( 2.02.23).

03 de Mayo de 2022
Cambio de objeto social. la integraci贸n laboral y social, asistencia y servicios sociales para discapacitados f铆sicos, ps铆quicos y/osensoriales, con finalidad de asegurar un empleo remunerado y digno, as铆 como la realizaci贸n de un ajuste personal y social mediantela realizaci贸n de un trabajo productivo, de acuerdo con lo. Datos registrales. T 3694 , F 207, S 8, H A 121326, I/A 13 (22.04.22).

29 de Abril de 2022
Revocaciones. Apo.Sol.: SOLDEVILLA RUBIERA ALFREDO. Apo.Manc.: SOLDEVILLA RUBIERA ALFREDO. Apo.Sol.: BARCELOBONET ELENA. Apo.Manc.: BARCELO BONET ELENA. Apo.Sol.: MONLLOR CUENCA FRANCISCO. Apo.Manc.: MONLLORCUENCA FRANCISCO. Nombramientos. Apo.Sol.: VALERA ALCALDE ARANTZAZU. Apo.Manc.: VALERA ALCALDEARANTZAZU. Apo.Sol.: LOPEZ BUENO ALBERTO AGUSTIN. Apo.Manc.: LOPEZ BUENO ALBERTO AGUSTIN. Apo.Sol.: FILLOLORTEGA ALEJANDRO. Apo.Manc.: FILLOL ORTEGA ALEJANDRO. Apo.Sol.: FERRANDIZ PEREZ SERGIO. Apo.Manc.:FERRANDIZ PEREZ SERGIO. Datos registrales. T 3694 , F 205, S 8, H A 121326, I/A 12 (19.04.22).

31 de Diciembre de 2018
Revocaciones. Apo.Sol.: CEBRIAN PUERTAS ALEJANDRO. Datos registrales. T 3694 , F 205, S 8, H A 121326, I/A 11 (21.12.18).

02 de Diciembre de 2014
Nombramientos. Apoderado: ROMILLO FIDALGO JOSE LUIS. Datos registrales. T 3694 , F 205, S 8, H A 121326, I/A 10(25.11.14).

09 de Abril de 2014
Revocaciones. Apo.Manc.: MARTIN GULLON ENRIQUE RAMON. Apo.Sol.: MARTIN GULLON ENRIQUE RAMON. Datosregistrales. T 3694 , F 205, S 8, H A 121326, I/A 9 (31.03.14).

25 de Junio de 2013
Revocaciones. Apo.Manc.: LOPEZ BUENO ALBERTO AGUSTIN. Apo.Sol.: LOPEZ BUENO ALBERTO AGUSTIN. Nombramientos.Apo.Sol.: MONLLOR CUENCA FRANCISCO. Apo.Manc.: MONLLOR CUENCA FRANCISCO. Datos registrales. T 3452 , F 77, S 8,H A 121326, I/A 8 (18.06.13).

09 de Mayo de 2012
Nombramientos. Apo.Sol.: MARTIN GULLON ENRIQUE RAMON. Apo.Manc.: MARTIN GULLON ENRIQUE RAMON. Datosregistrales. T 3452 , F 77, S 8, H A 121326, I/A 7 (26.04.12).

07 de Mayo de 2012
Revocaciones. Apo.Sol.: TRIGUEROS SELLES JOSE FRANCISCO. Apo.Manc.: TRIGUEROS SELLES JOSE FRANCISCO. Datosregistrales. T 3452 , F 76, S 8, H A 121326, I/A 6 (23.04.12).

11 de Agosto de 2011
Nombramientos. Apoderado: ROMILLO FIDALGO JOSE LUIS. Datos registrales. T 3452 , F 76, S 8, H A 121326, I/A 5 ( 2.08.11).

09 de Febrero de 2011
Nombramientos. Apo.Sol.: TRIGUEROS SELLES JOSE FRANCISCO;SOLDEVILLA RUBIERA ALFREDO. Apo.Manc.: TRIGUEROSSELLES JOSE FRANCISCO;SOLDEVILLA RUBIERA ALFREDO. Apo.Sol.: LOPEZ BUENO ALBERTO AGUSTIN. Apo.Manc.: LOPEZBUENO ALBERTO AGUSTIN. Apo.Sol.: CEBRIAN PUERTAS ALEJANDRO;BARCELO BONET ELENA. Apo.Manc.: BARCELOBONET ELENA. Datos registrales. T 3452 , F 23, S 8, H A 121326, I/A 4 (31.01.11).

08 de Febrero de 2011
Ceses/Dimisiones. Consejero: MORENO DARBONNENS ENRIQUE ANGEL;CABALLERO FRANCO MIGUELFRANCISCO;AUTOBUSES PLAYA DE SAN JUAN SA;ARIAS PAREDES ANTONIO;BURGALETA HERNANDO TOMAS.Con.Delegado: AUTOBUSES PLAYA DE SAN JUAN SA. SecreNoConsj: PACHECO CASTELLANOS JUAN ANTONIO. VsecrNoConsj:GONZALEZ MARTIN SANTIAGO. Nombramientos. Adm. Unico: AUTOBUSES PLAYA DE SAN JUAN SA. Modificacionesestatutarias. Cambio del Organo de Administraci贸n: Consejo de administraci贸n a Administrador 煤nico. Cambio de domicilio social.C/ APARISI GUIJARRO 14 1 (ALICANTE). Datos registrales. T 3452 , F 23, S 8, H A 121326, I/A 3 (28.01.11).

27 de Enero de 2011
Declaraci贸n de unipersonalidad. Socio 煤nico: AUTOBUSES PLAYA DE SAN JUAN SA. Ceses/Dimisiones. Consejero: GOMEZMAGANTO JOSE CARLOS. Presidente: GOMEZ MAGANTO JOSE CARLOS. Datos registrales. T 3452 , F 23, S 8, H A 121326, I/A2 (17.01.11).

19 de Mayo de 2010
Constituci贸n. Comienzo de operaciones: 7.01.10. Objeto social: 1.- El desarrollo, dise帽o, fabricaci贸n, instalaci贸n, compra, venta,suministro, importaci贸n, exportaci贸n, alquiler, mantenimiento, distribuci贸n, representaci贸n, comercializaci贸n y explotaci贸n de redes,sistemas y servicios de datos y telecomunicaciones e Internet en general, as铆 como el dise帽o, inve. Domicilio: C/ MAISONNAVE 18 1(ALICANTE). Capital: 200.000,00 Euros. Nombramientos. Consejero: GOMEZ MAGANTO JOSE CARLOS;MORENODARBONNENS ENRIQUE ANGEL;CABALLERO FRANCO MIGUEL FRANCISCO;AUTOBUSES PLAYA DE SAN JUAN SA;ARIASPAREDES ANTONIO;BURGALETA HERNANDO TOMAS. Presidente: GOMEZ MAGANTO JOSE CARLOS. Con.Delegado:AUTOBUSES PLAYA DE SAN JUAN SA. SecreNoConsj: PACHECO CASTELLANOS JUAN ANTONIO. VsecrNoConsj: GONZALEZMARTIN SANTIAGO. Datos registrales. T 3452 , F 21, S 8, H A 121326, I/A 1 ( 7.05.10).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n