Actos BORME de Mediterraneo Global Services 2010 Sa
22 de Mayo de 2019Extinci贸n. Datos registrales. T 3560 , F 124, S 8, H A 123682, I/A 23 (13.05.19).
30 de Enero de 2019Nombramientos. Apo.Sol.: VILANOVA GARCIA GISELA;MATEOS SOLIS ALBERTO;RIUS TALLARDA MIREIA;LOPEZ PRIETOMARIA;RINCON MARIN JON;FERNANDEZ PACIN OLATZ. Datos registrales. T 3560 , F 123, S 8, H A 123682, I/A 22 (22.01.19).
31 de Diciembre de 2018Nombramientos. Apo.Sol.: GOMEZ VALLES CARLOS IGNACIO;ISLA SANZ CAROLINA;GOMEZ VALLES JUANANTONIO;PALACIOS FORTEA DAVID;VALERO SARRION JOAQUIN;PEREZ DE LA TORRE MANUEL;VILLANUEVA PEREZREBECA;GARCIA VELEZ LAURA;GUTIERREZ GONZALEZ-CALATAYUD JOSE LUIS;MORENO BARRANCO JUAN. Datosregistrales. T 3560 , F 123, S 8, H A 123682, I/A 21 (20.12.18).
13 de Diciembre de 2018Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: GLOBAL ONE MANAGEMENT VENTURE SL. Nombramientos. Consejero: SKYLINE VENTURES
16 de Agosto de 2018Sociedad unipersonal. Cambio de identidad del socio 煤nico: GLOBAL ONE MANAGEMENT VENTURE SL. Ceses/Dimisiones.Consejero: GOMEZ DEL RIO SANZ MANUEL;ALFONSO PALOP JOSE FRANCISCO;FELIPE CABEZA CARLOS. Con.Delegado:GOMEZ DEL RIO SANZ MANUEL. Presidente: GOMEZ DEL RIO SANZ MANUEL. Secretario: ALFONSO PALOP JOSE FRANCISCO.Revocaciones. Apo.Manc.: VICENTE AMOROS JUAN JESUS;AMIROLA CAMPA JUAN. Nombramientos. Adm. Unico: GLOBALONE MANAGEMENT VENTURE SL. Modificaciones estatutarias. ARTICULO 7潞B. Acciones. ARTICULO 14潞.- Organo deAdministraci贸n. ARTICULO 15潞.- Plazo duraci贸n 贸rgano de administraci贸n. ARTICULO 16潞. Retribuci贸n. Otros conceptos: Cambiodel Organo de Administraci贸n: Consejo de administraci贸n a Administrador 煤nico. Datos registrales. T 3560 , F 57, S 8, H A 123682,I/A 19 ( 7.08.18).
02 de Agosto de 2018Nombramientos. Apo.Sol.: SELLES PACHECO BEATRIZ;REYES CERDA JOSE ANTONIO;RODRIGUEZ SANCHEZOSCAR;MORENO MARTINEZ MARIA LUISA;JUAN BORDEJE MARIA CECILIA;CARBONELL ZARAGOZA ANA MARIA;SANCHEZCONESA MANUEL LORENZO;BUSTAMANTE VICO MATILDE ALICIA;CISCAR MARTINEZ EVA;BELLO GARCIA DE GAMARRALUIS MIGUEL;MARTIN DIEZ MARIA PILAR;GARCIA DE LA REINA VELASCO MARIA DEL CARMEN;DOMINGUEZ GUILLENTANIA;MAYO TORRES JOSE;GARCIA OCHEDA MONICA;TORREGROSA GIMENEZ VERONICA;MORENO BARRANCOJUAN;QUESADA RUIZ ANA MARIA. Datos registrales. T 3560 , F 57, S 8, H A 123682, I/A 18 (25.07.18).
19 de Julio de 2018Cambio de objeto social. la intermediaci贸n en la prestaci贸n de servicios de gesti贸n administrativa, legal, contable y laboral.- Laadquisici贸n, tenencia de acciones o participaciones sociales en empresas no cotizadas de naturaleza no inmobiliaria, financiera nirelacionadas con la actividad aseguradora. Datos registrales. T 3560 , F 57, S 8, H A 123682, I/A 17 (11.07.18).
07 de Agosto de 2017Ceses/Dimisiones. Con.Delegado: GOMEZ DEL RIO SANZ MANUEL. Nombramientos. Con.Delegado: GOMEZ DEL RIO SANZMANUEL. Reelecciones. Consejero: GOMEZ DEL RIO SANZ MANUEL. Presidente: GOMEZ DEL RIO SANZ MANUEL. Datosregistrales. T 3560 , F 56, S 8, H A 123682, I/A 16 (31.07.17).
20 de Julio de 2017Nombramientos. Auditor: BDO AUDITORES SLP. Datos registrales. T 3560 , F 56, S 8, H A 123682, I/A 15 (12.07.17).
31 de Mayo de 2017Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 3560 , F 56, S 8, H A 123682, I/A14 (23.05.17).
09 de Febrero de 2017Ceses/Dimisiones. Consejero: AMIROLA GOMEZ IGNACIO. SecreNoConsj: ALFONSO PALOP JOSE FRANCISCO. Vicepresid.:AMIROLA GOMEZ IGNACIO. Nombramientos. Consejero: ALFONSO PALOP JOSE FRANCISCO. Secretario: ALFONSO PALOPJOSE FRANCISCO. Datos registrales. T 3560 , F 56, S 8, H A 123682, I/A 13 ( 2.02.17).
23 de Enero de 2017Ceses/Dimisiones. Consejero: VICENTE AMOROS JUAN JESUS. Presidente: VICENTE AMOROS JUAN JESUS. Nombramientos.Presidente: GOMEZ DEL RIO SANZ MANUEL. Consejero: FELIPE CABEZA CARLOS. Datos registrales. T 3560 , F 56, S 8, H A123682, I/A 12 (13.01.17).
19 de Enero de 2017Ampliaci贸n de capital. Suscrito: 72.400,00 Euros. Desembolsado: 72.400,00 Euros. Resultante Suscrito: 850.000,00 Euros.Resultante Desembolsado: 850.000,00 Euros. Datos registrales. T 3494 , F 137, S 8, H A 123682, I/A 11 (11.01.17).
16 de Enero de 2017Nombramientos. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 3494 , F 137, S 8, H A 123682,I/A 10 ( 5.01.17).
23 de Diciembre de 2014Cambio de objeto social. Gesti贸n administrativa, legal, contable y laboral.- La adquisici贸n, tenencia de acciones o participacionessociales en empresas no cotizadas de naturaleza no inmobiliaria, financiera ni relacionadas con la actividad aseguradora. Datosregistrales. T 3494 , F 137, S 8, H A 123682, I/A 9 (15.12.14).