Actos BORME de Mediterraneo Servicios De Gestion Integral Sa
28 de Agosto de 2023Nombramientos. Apo.Sol.: DE PRADO FERNANDEZ LUIS;GALAN MARTINEZ MARIA;OCHOA OLIVA ELENA MARIA. Datosregistrales. T 4540 , F 71, S 8, H A 2156, I/A 64 (18.08.23).
20 de Junio de 2023Nombramientos. Apoderado: MONTORO GONZALEZ MARINA. Datos registrales. T 4540 , F 71, S 8, H A 2156, I/A 63 (12.06.23).
19 de Abril de 2023Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: FELIPE CABEZA CARLOS. Nombramientos. Adm. Unico: MEDITERRANEO GLOBAL SERVICES2010 SL. Datos registrales. T 4540 , F 71, S 8, H A 2156, I/A 62 (11.04.23).
14 de Febrero de 2023Nombramientos. Apo.Sol.: SALA BALLESTER INMACULADA;GARCIA VELEZ LAURA. Datos registrales. T 4540 , F 71, S 8, H A2156, I/A 61 ( 6.02.23).
06 de Febrero de 2023Ceses/Dimisiones. Adm. Mancom.: QUILES FENOLL FRANCISCO JOSE;FELIPE CABEZA CARLOS. Nombramientos. Adm.Unico: FELIPE CABEZA CARLOS. Modificaciones estatutarias. ARTICULO 14潞.- La gesti贸n y representaci贸n de la sociedad.Otros conceptos: Cambio del Organo de Administraci贸n: Administradores mancomunados a Administrador 煤nico. Datos registrales.T 4176 , F 86, S 8, H A 2156, I/A 60 (27.01.23).
03 de Febrero de 2023Reelecciones. Auditor: BDO AUDITORES SLP. Datos registrales. T 4176 , F 86, S 8, H A 2156, I/A 59 (26.01.23).
02 de Febrero de 2023Reelecciones. Auditor: BDO AUDITORES SLP. Datos registrales. T 4176 , F 86, S 8, H A 2156, I/A 58 (25.01.23).
21 de Enero de 2022Nombramientos. Apo.Sol.: CASTEJON MARTINEZ ANDRES;BARROSO GONZALEZ FRANCISCA. Datos registrales. T 4176 , F86, S 8, H A 2156, I/A 57 (13.01.22).
13 de Enero de 2022Nombramientos. Apo.Sol.: SAEZ MALDONADO JOSE;DE CASTRO NOCHON MANUEL. Datos registrales. T 4176 , F 85, S 8, H A2156, I/A 56 ( 5.01.22).
19 de Mayo de 2021Revocaciones. Apo.Sol.: BUSTAMANTE VICO MATILDE ALICIA. Datos registrales. T 4176 , F 83, S 8, H A 2156, I/A 55 (12.05.21).
16 de Marzo de 2021Revocaciones. Apo.Man.Soli: CASTEJON MARTINEZ ANDRES;FELIPE CABEZA CARLOS. Apo.Manc.: CASTEJON MARTINEZANDRES;FELIPE CABEZA CARLOS. Apo.Sol.: BARROSO GONZALEZ FRANCISCA;FABA SANCHEZ JUAN MIGUEL. Apo.Manc.:BARROSO GONZALEZ FRANCISCA;FABA SANCHEZ JUAN MIGUEL;CASTEJON MARTINEZ ANDRES;FELIPE CABEZACARLOS;BARROSO GONZALEZ FRANCISCA;FELIPE CABEZA CARLOS. Apo.Sol.: QUILES FENOLL FRANCISCO JOSE;FELIPECABEZA CARLOS. Nombramientos. Apo.Man.Soli: FELIPE CABEZA CARLOS;QUILES FENOLL FRANCISCO JOSE;TORRUBIAMANTOPOULOU ALEJANDRO Datos registrales. T 4176 , F 83, S 8, H A 2156, I/A 54 ( 4.03.21).
22 de Mayo de 2020Nombramientos. Apo.Sol.: TORREGROSA GIMENEZ VERONICA;GARCIA OCHEDA MONICA;MEYER STEPHANIE. Datosregistrales. T 4176 , F 83, S 8, H A 2156, I/A 53 (11.05.20).
23 de Agosto de 2019Nombramientos. Apo.Sol.: HERNANDEZ MORA ANGEL JUAN;VOGEL STEPHANIE ANNELIESE BRIGITTE. Datos registrales. T4176 , F 82, S 8, H A 2156, I/A 52 (14.08.19).
22 de Mayo de 2019Sociedad unipersonal. Cambio de identidad del socio 煤nico: MEDITERRANEO GLOBAL SERVICES 2010 SL. Datos registrales.T 4176 , F 82, S 8, H A 2156, I/A 51 (14.05.19).
26 de Diciembre de 2018Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: GLOBAL ONE MANAGEMENT VENTURE SL. Nombramientos. Adm. Mancom.: QUILES FENOLLFRANCISCO JOSE;FELIPE CABEZA CARLOS. Apo.Sol.: QUILES FENOLL FRANCISCO JOSE;FELIPE CABEZA CARLOS.Modificaciones estatutarias. Art铆culo 12潞.- Funcionamiento junta general. Art铆culo 14潞.- Gesti贸n y representaci贸n de la sociedad.Otros conceptos: Cambio del Organo de Administraci贸n: Administrador 煤nico a Administradores mancomunados. Datos registrales.T 3898 , F 183, S 8, H A 2156, I/A 50 (17.12.18).
16 de Agosto de 2018Ceses/Dimisiones. Consejero: GOMEZ DEL RIO SANZ MANUEL;ALFONSO PALOP JOSE FRANCISCO;FELIPE CABEZACARLOS. Presidente: GOMEZ DEL RIO SANZ MANUEL. Con.Delegado: GOMEZ DEL RIO SANZ MANUEL. Secretario: ALFONSOPALOP JOSE FRANCISCO. Revocaciones. Apo.Sol.: BARNES FERNANDEZ MARTA;GUILLAMON GASCU脩ANA JAVIERFRANCISCO;CARDONA LLINARES RICARDO FELIPE;IZQUIERDO TOLEDO MARIA ELENA;ROMERO ESCUDERO EDUARDOJAVIER;CLIMENT MONERRIS VICENTE JOSE. Apo.Manc.: MANZANO RAJA PEDRO. Nombramientos. Adm. Unico: GLOBALONE MANAGEMENT VENTURE SL. Otros conceptos: Cambio del Organo de Administraci贸n: Consejo de administraci贸n aAdministrador 煤nico. Modificada de la totalidad de los Estatutos Sociales. Datos registrales. T 3898 , F 183, S 8, H A 2156, I/A 49 (7.08.18).
18 de Julio de 2018Cambio de objeto social. La administraci贸n de Comunidades de Propietarios y la intermediaci贸n en la prestaci贸n de servicios degesti贸n administrativa, legal, contable y fiscal a comunidades de propietarios, as铆 como a los propietarios que lo integran. Datosregistrales. T 3898 , F 183, S 8, H A 2156, I/A 48 (10.07.18).
20 de Noviembre de 2017Fusi贸n por absorci贸n. Sociedades absorbidas: AFINCO SL. ADMINISTRACION MADRILE脩A DE FINCAS SL. Datos registrales. T3898 , F 59, S 8, H A 2156, I/A 47 (10.11.17).
27 de Septiembre de 2017Nombramientos. Apo.Sol.: MAYO TORRES JOSE;JUAN BORDEJE MARIA CECILIA;BELLO GARCIA DE GAMARRA LUIS MIGUEL.Datos registrales. T 3898 , F 58, S 8, H A 2156, I/A 46 (19.09.17).
07 de Agosto de 2017Ceses/Dimisiones. Con.Delegado: GOMEZ DEL RIO SANZ MANUEL. Nombramientos. Con.Delegado: GOMEZ DEL RIO SANZMANUEL. Reelecciones. Consejero: GOMEZ DEL RIO SANZ MANUEL. Presidente: GOMEZ DEL RIO SANZ MANUEL. Datosregistrales. T 3898 , F 58, S 8, H A 2156, I/A 45 (28.07.17).
21 de Julio de 2017Nombramientos. Auditor: BDO AUDITORES SLP. Datos registrales. T 3898 , F 58, S 8, H A 2156, I/A 44 (12.07.17).
12 de Junio de 2017Nombramientos. Apoderado: DOMINGUEZ GUILLEN TANIA. Datos registrales. T 3898 , F 58, S 8, H A 2156, I/A 43 ( 5.06.17).
31 de Mayo de 2017Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 3898 , F 58, S 8, H A 2156, I/A 41(23.05.17).
10 de Febrero de 2017Ceses/Dimisiones. Consejero: AMIROLA GOMEZ IGNACIO. SecreNoConsj: ALFONSO PALOP JOSE FRANCISCO. Vicepresid.:AMIROLA GOMEZ IGNACIO. Nombramientos. Consejero: ALFONSO PALOP JOSE FRANCISCO. Secretario: ALFONSO PALOPJOSE FRANCISCO. Datos registrales. T 3898 , F 57, S 8, H A 2156, I/A 40 ( 1.02.17).
29 de Noviembre de 2016Ceses/Dimisiones. Consejero: VICENTE AMOROS JUAN JESUS. Presidente: VICENTE AMOROS JUAN JESUS. Nombramientos.Consejero: FELIPE CABEZA CARLOS. Presidente: GOMEZ DEL RIO SANZ MANUEL. Reelecciones. Vicepresid.: AMIROLAGOMEZ IGNACIO. Datos registrales. T 3898 , F 57, S 8, H A 2156, I/A 39 (21.11.16).
12 de Julio de 2016Revocaciones. Apo.Manc.: MANZANO RAJA PEDRO. Apo.Man.Soli: MANZANO RAJA PEDRO. Datos registrales. T 3898 , F 57, S8, H A 2156, I/A 38 ( 4.07.16).
26 de Noviembre de 2015Nombramientos. Apo.Sol.: BUSTAMANTE VICO MATILDE ALICIA;CARBONELL ZARAGOZA ANA MARIA;NARANJO JIMENEZANGELA;CISCAR MARTINEZ EVA;MORENO MARTINEZ MARIA LUISA;GARCIA DE LA REINA VELASCO MARIA DELCARMEN;PEREZ DE LA TORRE MANUEL;SANCHEZ CONESA MANUEL LORENZO;RODRIGUEZ SANCHEZ OSCAR;MARTINDIEZ MARIA PILAR. Datos registrales. T 3898 , F 57, S 8, H A 2156, I/A 37 (18.11.15).
19 de Noviembre de 2015Nombramientos. Apo.Sol.: BARROSO GONZALEZ FRANCISCA;FABA SANCHEZ JUAN MIGUEL. Apo.Manc.: BARROSOGONZALEZ FRANCISCA;FABA SANCHEZ JUAN MIGUEL;CASTEJON MARTINEZ ANDRES;MANZANO RAJA PEDRO;FELIPECABEZA CARLOS;BARROSO GONZALEZ FRANCISCA;FELIPE CABEZA CARLOS. Datos registrales. T 2120 , F 74, S 8, H A2156, I/A 36 (11.11.15).