Actos BORME de Medybla Aljarafe Sl
13 de Marzo de 2019Ceses/Dimisiones. Consejero: ALYRAID SL;CONRADI RAMIREZ MERCEDES;LA TORRE DEL ALJARAFE SL;CONRADI RAMIREZLUIS;COCA BARRIONUEVO MIGUEL JOSE. Presidente: ALYRAID SL. Con.Delegado: ALYRAID SL. Vicepresid.: CONRADIRAMIREZ MERCEDES. Secretario: CONRADI RAMIREZ LUIS. Revocaciones. Apoderado: CONRADI RAMIREZ MERCEDES.Disoluci贸n. Fusion. Extinci贸n. Datos registrales. T 3282 , F 38, S 8, H SE 44715, I/A 11 ( 5.03.19).
23 de Octubre de 2018Sociedad unipersonal. Cambio de identidad del socio 煤nico: INMOBILIARIA LUIS MEDINA SA. Datos registrales. T 3282 , F 38,S 8, H SE 44715, I/A 10 (11.10.18).
22 de Septiembre de 2016Ceses/Dimisiones. Consejero: MEDINA MEDINA BLANCA;MEDINA CONRADI CASILDA. Nombramientos. Consejero: COCABARRIONUEVO MIGUEL JOSE. Reelecciones. Presidente: ALYRAID SL. Con.Delegado: ALYRAID SL. Vicepresid.: CONRADIRAMIREZ MERCEDES. Secretario: CONRADI RAMIREZ LUIS. Datos registrales. T 3282 , F 36, S 8, H SE 44715, I/A 9 (13.09.16).
20 de Enero de 2016Nombramientos. Auditor: RUBIO MEMBRIVE Y GISBERT SOCIEDAD LIMITADA PROFESI. Datos registrales. T 3282 , F 36, S 8,H SE 44715, I/A 8 ( 8.01.16).
15 de Enero de 2016Ceses/Dimisiones. Adm. Solid.: IGNACIO BORRERO PASCUAL. Datos registrales. T 3282 , F 34, S 8, H SE 44715, I/A 5(23.09.15).
Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: IGNACIO BORRERO PASCUAL. Nombramientos. Apoderado: CONRADI RAMIREZ MERCEDES.Consejero: ALYRAID SL;CONRADI RAMIREZ MERCEDES;MEDINA MEDINA BLANCA;LA TORRE DEL ALJARAFE SL;MEDINACONRADI CASILDA;CONRADI RAMIREZ LUIS. Presidente: ALYRAID SL. Vicepresid.: CONRADI RAMIREZ MERCEDES. Secretario:CONRADI RAMIREZ LUIS. Con.Delegado: ALYRAID SL. Otros conceptos: Cambio del Organo de Administraci贸n: Administrador煤nico a Consejo de administraci贸n. Datos registrales. T 3282 , F 35, S 8, H SE 44715, I/A 7 ( 8.01.16).
05 de Octubre de 2015Ceses/Dimisiones. Adm. Solid.: GONZALEZ CORTES JOSE ANTONIO. Datos registrales. T 3282 , F 34, S 8, H SE 44715, I/A 4(23.09.15).
Nombramientos. Adm. Unico: IGNACIO BORRERO PASCUAL. Modificaciones estatutarias. Art铆culo de los estatutos: 4.Domicilio.-. Cambio del Organo de Administraci贸n: Administradores solidarios a Administrador 煤nico. Cambio de domicilio social. C/PARROCO VICENTE MOYA 14 (PILAS). Datos registrales. T 3282 , F 34, S 8, H SE 44715, I/A 5 (23.09.15).
Declaraci贸n de unipersonalidad. Socio 煤nico: MEDINA GARVEY SA. Datos registrales. T 3282 , F 35, S 8, H SE 44715, I/A 6(23.09.15).
08 de Junio de 2010Ampliaci贸n de capital. Capital: 1.447.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 1.572.500,00 Euros. Modificaciones estatutarias.Art铆culo de los estatutos: 5. Capital.-. Datos registrales. T 3282 , F 33, S 8, H SE 44715, I/A 3 (19.05.10).