Actos BORME de Mefasent Sl
05 de Junio de 2019Ceses/Dimisiones. Liquidador: LOPEZ LOPEZ MANUEL JORGE. Adm. Unico: LOPEZ LOPEZ MANUEL JORGE. Nombramientos.Liquidador: LOPEZ LOPEZ MANUEL JORGE. Disoluci贸n. Voluntaria. Extinci贸n. Datos registrales. T 4084 , F 209, S 8, H A157828, I/A 3 (28.05.19).
29 de Diciembre de 2017Cambio de domicilio social. AVDA MARIBEL LOPEZ PEREZ OJEDA 78 Esc.2 4潞 D (SANTA POLA). Datos registrales. T 4084 , F209, S 8, H A 157828, I/A 2 (19.12.17).
22 de Mayo de 2017Modificaciones estatutarias. ARTICULO 37.- SISTEMA RETRIBUTIVO DEL ORGANO DE ADMINISTRACION SOCIAL. Datosregistrales. T 34867 , F 160, S 8, H B 252733, I/A 9 (11.05.17).
04 de Febrero de 2014Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 310,00 Euros. Resultante Suscrito: 2.720,00 Euros. Ampliaci贸n de capital. Capital:280,00 Euros. Resultante Suscrito: 3.000,00 Euros. Datos registrales. T 34867 , F 159, S 8, H B 252733, I/A 8 (28.01.14).
03 de Enero de 2014Cambio de domicilio social. CL DOCTOR ULLES Num.12 P.BJ (TERRASSA). Datos registrales. T 34867 , F 159, S 8, H B252733, I/A 7 (24.12.13).
16 de Febrero de 2012Modificaciones estatutarias. ART. 38 : FIJACION DEL INICIO Y CIERRE DEL EJERCICIO SOCIAL, INICIANDOSE EL DIA 1 DESEPTIEMBRE Y FINALIZANDO EL 31 DE AGOSTO DE CADA A脩O. Datos registrales. T 34867 , F 158, S 8, H B 252733, I/A 6 (7.02.12).
14 de Julio de 2010Cambio de domicilio social. PS 22 DE JULIOL Num.430 P.1 PTA.3 (TERRASSA). Datos registrales. T 34867 , F 158, S 8, H B252733, I/A 5 ( 2.07.10).
05 de Febrero de 2009Revocaciones. ADMINISTR.: GARCIA ORELLANA RAFAEL. Nombramientos. ADM.UNICO: LOPEZ LOPEZ MANUEL JORGE.Datos registrales. T 34867 , F 158, S 8, H B 252733, I/A 4 (26.01.09).