Actos BORME de Megatech Industries Orense Sl
28 de Marzo de 2023Cambio de domicilio social. PQUE EMPRESARIAL 11 - VIAL PRINCIPAL (PEREIRO DE AGUIAR (O)). Datos registrales. T 935 ,F 130, S 8, H OR 7858, I/A 70 (10.03.23).
25 de Enero de 2023Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 935 , F 130, S 8, H OR 7858, I/A 69(12.01.23).
10 de Agosto de 2022Revocaciones. Apo.Sol.: SILVIO MERFERT MARKUS. Datos registrales. T 935 , F 130, S 8, H OR 7858, I/A 68 ( 2.08.22).
31 de Diciembre de 2021Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 892 , F 88, S 8, H OR 7858, I/A 67(17.12.21).
29 de Marzo de 2021Revocaciones. Apo.Manc.: VARELA PIÑEIRO ANA ISABEL. Nombramientos. Apo.Manc.: VARELA PIÑEIRO ANA ISABEL.Apo.Sol.: VARELA PIÑEIRO ANA ISABEL. Datos registrales. T 892 , F 87, S 8, H OR 7858, I/A 63 (22.03.21).
Nombramientos. Apo.Sol.: SILVIO MERFERT MARKUS;GUY PAMIES PASCAL. Datos registrales. T 892 , F 87, S 8, H OR 7858,I/A 64 (22.03.21).
Nombramientos. Apo.Manc.: MENDEZ PEREZ SARA. Datos registrales. T 892 , F 88, S 8, H OR 7858, I/A 65 (22.03.21).
Revocaciones. Apo.Manc.: GOMEZ PALACIO BORJA. Nombramientos. Apo.Manc.: GONZALEZ MONDRAGON ALVARO. Datosregistrales. T 892 , F 88, S 8, H OR 7858, I/A 66 (22.03.21).
22 de Enero de 2021Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 892 , F 86, S 8, H OR 7858, I/A 62 (7.01.21).
29 de Enero de 2020Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 892 , F 86, S 8, H OR 7858, I/A 61(17.01.20).
29 de Noviembre de 2019Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: GARCIA ALMUIÑA RUBEN. Nombramientos. Adm. Unico: MEGATECH INDUSTRIESPENINSULA IBERICA SOCIEDAD LIM. Datos registrales. T 892 , F 86, S 8, H OR 7858, I/A 60 (22.11.19).
03 de Octubre de 2019Revocaciones. Apo.Sol.: DO NASCIMENTO FANTINI MARIA ISABEL. Apo.Manc.: DO NASCIMENTO FANTINI MARIA ISABEL.Datos registrales. T 892 , F 85, S 8, H OR 7858, I/A 59 (24.09.19).
05 de Abril de 2019Nombramientos. Apo.Manc.: GOMEZ PALACIO BORJA. Datos registrales. T 892 , F 85, S 8, H OR 7858, I/A 58 (28.03.19).
21 de Enero de 2019Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 892 , F 85, S 8, H OR 7858, I/A 57 (9.01.19).
12 de Enero de 2018Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 892 , F 85, S 8, H OR 7858, I/A 56(29.12.17).
19 de Diciembre de 2017Revocaciones. Apo.Sol.: LARRASOAÑA ALCALDE DANIEL. Apo.Manc.: LARRASOAÑA ALCALDE DANIEL. Apo.Sol.: VIDALTORRERO MARIA DOLORES. Apo.Manc.: VIDAL TORRERO MARIA DOLORES. Datos registrales. T 852 , F 63, S 8, H OR 7858,I/A 54 (11.12.17).
Nombramientos. Apo.Manc.: DO NASCIMENTO FANTINI MARIA ISABEL. Apo.Sol.: DO NASCIMENTO FANTINI MARIA ISABEL.Datos registrales. T 852 , F 63, S 8, H OR 7858, I/A 55 (11.12.17).
31 de Enero de 2017Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 852 , F 63, S 8, H OR 7858, I/A 53(12.01.17).
02 de Enero de 2017Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: GESSLER MAXIMILIAN. Nombramientos. Adm. Unico: GARCIA ALMUIÑA RUBEN. Datosregistrales. T 852 , F 62, S 8, H OR 7858, I/A 52 (19.12.16).
07 de Octubre de 2016Nombramientos. Apo.Man.Soli: GALINDO ASTOBIETA JOSE MIGUEL. Datos registrales. T 852 , F 62, S 8, H OR 7858, I/A 51(28.09.16).
16 de Marzo de 2016Sociedad unipersonal. Cambio de identidad del socio único: MEGATECH INDUSTRIES PENINSULA IBERICA SOCIEDAD LIM.Datos registrales. T 852 , F 61, S 8, H OR 7858, I/A 50 ( 4.03.16).
07 de Marzo de 2016Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 852 , F 61, S 8, H OR 7858, I/A 49(25.02.16).
29 de Octubre de 2015Nombramientos. Apo.Manc.: VICINAY FERNANDEZ JOSE IGNACIO. Apo.Sol.: VICINAY FERNANDEZ JOSE IGNACIO. Datosregistrales. T 852 , F 60, S 8, H OR 7858, I/A 48 (20.10.15).
20 de Agosto de 2015Sociedad unipersonal. Cambio de identidad del socio único: MEGATECH INDUSTRIES AG. Datos registrales. T 852 , F 60, S 8,H OR 7858, I/A 45 ( 7.08.15).
Reelecciones. Adm. Unico: GESSLER MAXIMILIAN. Datos registrales. T 852 , F 60, S 8, H OR 7858, I/A 46 ( 7.08.15).
Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 852 , F 60, S 8, H OR 7858, I/A 47 (7.08.15).
22 de Mayo de 2015Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 852 , F 59, S 8, H OR 7858, I/A 44 (8.05.15).
17 de Julio de 2014Nombramientos. Apo.Manc.: VARELA PIÑEIRO ANA ISABEL. Datos registrales. T 841 , F 12, S 8, H OR 7858, I/A 39 ( 4.07.14).
Nombramientos. Apo.Manc.: VIDAL TORRERO MARIA DOLORES. Datos registrales. T 841 , F 13, S 8, H OR 7858, I/A 40 (4.07.14).
Nombramientos. Apo.Sol.: LARRASOAÑA ALCALDE DANIEL;GALINDO ASTOBIETA JOSE MIGUEL. Datos registrales. T 852 , F59, S 8, H OR 7858, I/A 41 ( 4.07.14).
Revocaciones. Apo.Manc.: PALENZUELA ARBILLA LUIS. Datos registrales. T 852 , F 59, S 8, H OR 7858, I/A 42 ( 4.07.14).
Revocaciones. Apo.Manc.: GESSLER MAXIMILIAN;TELLERIA BASAÑEZ JAVIER;VICENTE JIMENEZ JOSE;DEL VAL PECIÑAFERNANDO;GESSLER MAXIMILIAN. Apo.Sol.: FRUHBECK OLMEDO GUILLERMO;AGUINACO MORENO JORGE. Apoderado: DELVAL PECIÑA FERNANDO. Datos registrales. T 852 , F 59, S 8, H OR 7858, I/A 43 ( 4.07.14).
27 de Junio de 2014Fe de erratas: Se rectifica el error involuntario que se produjo en la escritura de poder autorizada por el Notario de Bilbao, Don JavierVinader Carracedo con fecha 28 de agosto de 2013, con el nº 637 de protocolo, por cuanto el poder se confiere a favor de DONDANIEL LARRASOÑA ALCALDE. Datos registrales. T 841 , F 12, S 8, H OR 7858, I/A 38 (16.06.14).
22 de Mayo de 2014Ceses/Dimisiones. Auditor: FICESA TREUHAND SA. Nombramientos. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORESSL. Datos registrales. T 841 , F 12, S 8, H OR 7858, I/A 37 ( 6.05.14).
20 de Diciembre de 2013Revocaciones. Apo.Manc.: SERRANO AGUIRRE ELENA. Nombramientos. Apo.Manc.: GALINDO ASTOBIETA JOSE MIGUEL.Datos registrales. T 841 , F 11, S 8, H OR 7858, I/A 36 ( 9.12.13).
06 de Noviembre de 2013Revocaciones. Apo.Manc.: EZKURRA GARAI XABIER. Nombramientos. Apo.Manc.: ALCALDE LARRASOAÑA DANIEL. Datosregistrales. T 841 , F 11, S 8, H OR 7858, I/A 35 (28.10.13).
30 de Agosto de 2013Otros conceptos: Modificado el artículo 19 de los estatutos sociales en cuanto a que el cargo de administrador pasará a serretribuido. Datos registrales. T 841 , F 10, S 8, H OR 7858, I/A 32 (20.08.13).
Sociedad unipersonal. Cambio de identidad del socio único: MEGATECH BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT MBH. Datosregistrales. T 841 , F 10, S 8, H OR 7858, I/A 33 (20.08.13).
Revocaciones. Apo.Manc.: DEL VAL PECIÑA FERNANDO. Nombramientos. Apo.Manc.: PALENZUELA ARBILLA LUIS. Datosregistrales. T 841 , F 10, S 8, H OR 7858, I/A 34 (20.08.13).
02 de Agosto de 2013Otros conceptos: Introducción del Artículo 7 BIS relativo a la prenda de participaciones sociales, correspondiendo al acreedorpignoraticio los derechos políticos y económicos desde las notificaciones al deudor pignoraticio y a la sociedad de incumplimientoconforme los requisitos del artículo 1.872 del Código Civil. Datos registrales. T 770 , F 147, S 8, H OR 7858, I/A 31 (19.07.13).
20 de Marzo de 2012Nombramientos. Apo.Manc.: EZKURRA GARAI XABIER. Datos registrales. T 770 , F 147, S 8, H OR 7858, I/A 30 ( 2.03.12).
30 de Noviembre de 2010Revocaciones. Apo.Manc.: TELLERIA BASAÑEZ JAVIER. Nombramientos. Apo.Manc.: SERRANO AGUIRRE ELENA. Apoderado:DEL VAL PECIÑA FERNANDO. Datos registrales. T 770 , F 146, S 8, H OR 7858, I/A 29 (19.11.10).
03 de Agosto de 2010Reelecciones. Auditor: FICESA TREUHAND SA. Datos registrales. T 770 , F 146, S 8, H OR 7858, I/A 28 (20.07.10).