Buscador CIF Logo

Actos BORME Mendivil Sa

驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Mendivil Sa

Actos BORME Mendivil Sa - A29037280

Tenemos registrados 26 Actos BORME del Registro Mercantil de Sevilla para Mendivil Sa con CIF A29037280

馃敊 Perfil de Mendivil Sa
馃洅 Comprar listado completo de Empresas de Sevilla

Actos BORME de Mendivil Sa

30 de Agosto de 2023
Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 6511 , F 34, S 8, H SE114387, I/A 17 (11.08.23).

17 de Abril de 2023
Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 6511 , F 34, S 8, H SE114387, I/A 16 (10.04.23).

10 de Enero de 2022
Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 6511 , F 34, S 8, H SE114387, I/A 15 ( 3.01.22).

17 de Agosto de 2021
Ceses/Dimisiones. Consejero: HERNANDEZ MATEO DE PORRAS PEDRO ALBERTO. Nombramientos. Consejero: SEGOVIAMATEOS DE PORRAS ALVARO. Datos registrales. T 6511 , F 33, S 8, H SE114387, I/A 14 ( 4.08.21).

08 de Octubre de 2020
Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 6511 , F 33, S 8, H SE114387, I/A 13 (29.09.20).

12 de Marzo de 2020
Modificaciones estatutarias. Art铆culo de los estatutos: 3. Domicilio social y web corporativa.-. Cambio de domicilio social. AVDASAN FRANCISCO JAVIER 24 - MODULO VEINTICINCO, (SEVILLA). Datos registrales. T 6511 , F 33, S 8, H SE114387, I/A 12 (3.03.20).

07 de Enero de 2020
Ceses/Dimisiones. Consejero: HERNANDEZ MATEO DE PORRAS PEDRO;HERNANDEZ MARTIN SEGISMUNDO;HERNANDEZGUTIERREZ JOSE MANUEL;HERNANDEZ MOYA JUAN ANTONIO;HERNANDEZ GOMEZ SEGISMUNDO. Presidente:HERNANDEZ GOMEZ SEGISMUNDO. Vicepresid.: HERNANDEZ MARTIN SEGISMUNDO. Secretario: HERNANDEZ MOYA JUANANTONIO. Nombramientos. Consejero: HERNANDEZ GOMEZ SEGISMUNDO;HERNANDEZ MARTINSEGISMUNDO;HERNANDEZ MATEO DE PORRAS PEDRO ALBERTO;HERNANDEZ MOYA JUAN ANTONIO. Presidente:HERNANDEZ GOMEZ SEGISMUNDO. Secretario: HERNANDEZ MOYA JUAN ANTONIO. Modificaciones estatutarias. 28.Duraci贸n del cargo.- . Datos registrales. T 6511 , F 32, S 8, H SE114387, I/A 11 (23.12.19).

08 de Febrero de 2019
Modificaciones estatutarias. 30. RETRIBUCION DEL CARGO.- . Datos registrales. T 6511 , F 31, S 8, H SE114387, I/A 10(28.01.19).

28 de Enero de 2019
Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 43.946,72 Euros. Resultante Suscrito: 51.208,28 Euros. Ampliaci贸n de capital. Suscrito:9.286,13 Euros. Desembolsado: 9.286,13 Euros. Resultante Suscrito: 60.494,41 Euros. Resultante Desembolsado: 60.494,41 Euros.Modificaciones estatutarias. Art铆culo de los estatutos: 5. Capital social.-. Datos registrales. T 6511 , F 31, S 8, H SE114387, I/A 9(17.01.19).

23 de Agosto de 2018
Nombramientos. Apo.Sol.: HERNANDEZ MOYA ISABEL;HERNANDEZ GOMEZ ROCIO. Datos registrales. T 6511 , F 30, S 8, HSE114387, I/A 8 (16.08.18).

07 de Junio de 2018
Ceses/Dimisiones. Consejero: HERNANDEZ GARCIA AURORA;QUESADA QUESADA MANUEL;COLOMER HERNANDEZ JOSEMARIA;HERNANDEZ GARCIA BALDOMERO ANGEL. Secretario: QUESADA QUESADA MANUEL. Vicepresid.: COLOMERHERNANDEZ JOSE MARIA. Presidente: HERNANDEZ MARTIN SEGISMUNDO. Vicesecret.: HERNANDEZ GOMEZ SEGISMUNDO.Revocaciones. Apoderado: HERNANDEZ GARCIA AURORA. Nombramientos. Presidente: HERNANDEZ GOMEZ SEGISMUNDO.Vicepresid.: HERNANDEZ MARTIN SEGISMUNDO. Secretario: HERNANDEZ MOYA JUAN ANTONIO. Datos registrales. T 6511 , F29, S 8, H SE114387, I/A 7 (23.05.18).

16 de Marzo de 2018
Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 3.726,27 Euros. Resultante Suscrito: 56.374,94 Euros. Ampliaci贸n de capital. Suscrito:38.780,06 Euros. Desembolsado: 38.780,06 Euros. Resultante Suscrito: 95.155,00 Euros. Resultante Desembolsado: 95.155,00 Euros.Modificaciones estatutarias. Art铆culo de los estatutos: 5. Capital social.-. Art铆culo de los estatutos: 2. Objeto social.-. Cambio deobjeto social. A) La distribuci贸n, programaci贸n, promoci贸n, gesti贸n y exhibici贸n cinematogr谩fica: B) La creaci贸n, preparaci贸n yejecuci贸n de espect谩culos p煤blicos y actividades culturales, l煤dicas, recreativas y de ocio: C) La explotaci贸n de restaurantes, bares,cafeter铆as, establecimientos, tiendas y expedidur铆as. Fusi贸n por absorci贸n. Sociedades absorbidas: HERCI SA. SEGISMUNDOHERNANDEZ SA. MULTICINES EL ARCANGEL SL. MULTICINES SANT BOI SL. UNION CINE CIUDAD SL. OCIREST SL. CINEMESAMPOSTA 2000 SL. MULTICINES ARAGON SOCIEDAD LIMITADA. MULTICINES DEL ESTE SL. CINEMES LES BRUIXESSOCIEDAD LIMITADA. CINE ECHEGARAY SA. BIPAMO SA. CINE ATLANTIDA SA. CINE ANDALUCIA SA. CINE VICTORIA SA.CINE ASTORIA SA. CEUTA MULTICINES SL. CINES DE JEREZ SA. Datos registrales. T 6400 , F 79, S 8, H SE114387, I/A 6 (7.03.18).

13 de Febrero de 2018
Nombramientos. Apoderado: HERNANDEZ MARTIN SEGISMUNDO. Datos registrales. T 6400 , F 78, S 8, H SE114387, I/A 5 (5.02.18).

Otros conceptos: CANCELACION ANOTACION PREVENTIVA LETRA A DE IMPUGNACION DE ACUERDOS SOCIALES. Datosregistrales. T 6400 , F 78, S 8, H SE114387, I/A B ( 5.02.18).

15 de Diciembre de 2017
Nombramientos. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 6400 , F 77, S 8, H SE114387, I/A 4 ( 5.12.17).

18 de Julio de 2017
Modificaciones estatutarias. Art铆culo de los estatutos: 3. Domicilio, sucursales, agencias y delegaciones.-. Cambio de domiciliosocial. ALAM DE HERCULES 9-10 - C.P. 41.002 (SEVILLA). Datos registrales. T 6400 , F 77, S 8, H SE114387, I/A 2 ( 7.07.17).

28 de Junio de 2017
Otros conceptos: Anotaci贸n preventiva de la Demanda de Impugnaci贸n de Acuerdos Sociales, adoptados por el Consejo deAdministraci贸n en su Reuni贸n de 7 de octubre de 2.016, relativos a la ampliaci贸n de poderes de la Sociedad conferidos a DonSegismundo Hern谩ndez Mart铆n.- Datos registrales. T 5631, L 4538, F 186, S 8, H MA 25300, I/A A (16.06.17).

30 de Julio de 2015
Nombramientos. Vicepresid.: COLOMER HERNANDEZ JOSE MARIA. Vicesecret.: HERNANDEZ GOMEZ SEGISMUNDO.Reelecciones. Consejero: HERNANDEZ MOYA JUAN ANTONIO;HERNANDEZ GOMEZ SEGISMUNDO;HERNANDEZ GARCIAAURORA;QUESADA QUESADA MANUEL;HERNANDEZ GARCIA BALDOMERO ANGEL;HERNANDEZ MATEO DE PORRASPEDRO. Secretario: QUESADA QUESADA MANUEL. Presidente: HERNANDEZ MARTIN SEGISMUNDO. Consejero: HERNANDEZMARTIN SEGISMUNDO;COLOMER HERNANDEZ JOSE MARIA;HERNANDEZ GUTIERREZ JOSE MANUEL. Otros conceptos:Modificaci贸n del r茅gimen de transmisi贸n de las participaciones sociales.- Datos registrales. T 1860, L 773, F 14, S 8, H MA 25300, I/A24 (22.07.15).

03 de Julio de 2014
Nombramientos. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 1860, L 773, F 12, S 8, H MA 25300, I/A 21 (24.06.14).

Ceses/Dimisiones. Presidente: HERNANDEZ GARCIA AURORA. Nombramientos. Presidente: HERNANDEZ MOYA JUANANTONIO. Apoderado: HERNANDEZ MARTIN SEGISMUNDO. Datos registrales. T 1860, L 773, F 12, S 8, H MA 25300, I/A 22(24.06.14).

Ceses/Dimisiones. Presidente: HERNANDEZ MOYA JUAN ANTONIO. Nombramientos. Presidente: HERNANDEZ MARTINSEGISMUNDO. Datos registrales. T 1860, L 773, F 13, S 8, H MA 25300, I/A 23 (24.06.14).

14 de Marzo de 2014
Fe de erratas: Se rectifica la inscripci贸n 18&, en cuanto al nombramiento de Consejeroque en la misma se efectuaba, siendo elcorrecto: DON SEGISMUNDOHERNANDEZ MARTIN, con D.N.I. n煤mero 27.316.815-Z. M谩laga, a 6 de Marzo de 2014.- Datosregistrales. T 1860, L 773, F 12, S 8, H MA 25300, I/A 20 ( 6.03.14).

07 de Diciembre de 2010
Ceses/Dimisiones. Consejero: HERNANDEZ GARCIA JOSE MANUEL. Reelecciones. Consejero: HERNANDEZ GOMEZSEGISMUNDO. Datos registrales. T 1860, L 773, F 12, S 8, H MA 25300, I/A 18 (23.11.10).

Nombramientos. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 1860, L 773, F 12, S 8, H MA 25300, I/A 19 (23.11.10).

20 de Enero de 2010
Ceses/Dimisiones. Consejero: HERNANDEZ GOMEZ SEGISMUNDO. Con.Delegado: HERNANDEZ GOMEZ SEGISMUNDO.Vicesecret.: HERNANDEZ GOMEZ SEGISMUNDO. Consejero: HERNANDEZ GUTIERREZ MARIA ISABEL. Vicepresid.:HERNANDEZ GUTIERREZ MARIA ISABEL. Consejero: HERNANDEZ GARCIA AURORA;HERNANDEZ GARCIA MARIA DELROSARIO;HERNANDEZ GARCIA JOSE MANUEL;HERNANDEZ GARCIA JUAN ANTONIO. Presidente: HERNANDEZ GARCIA JOSEMANUEL. Consejero: HERNANDEZ MATEO DE PORRAS PEDRO ALBERTO. Secretario: HERNANDEZ MATEO DE PORRASPEDRO ALBERTO. Nombramientos. Consejero: HERNANDEZ GARCIA JOSE MANUEL;HERNANDEZ MOYA JUANANTONIO;HERNANDEZ GOMEZ SEGISMUNDO;HERNANDEZ GUTIERREZ MARIA ISABEL;HERNANDEZ GARCIAAURORA;QUESADA QUESADA MANUEL;COLOMER HERNANDEZ IGNACIO;HERNANDEZ GARCIA BALDOMEROANGEL;HERNANDEZ MATEO DE PORRAS PEDRO. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Presidente: HERNANDEZ GARCIA AURORA.Vicepresid.: HERNANDEZ GUTIERREZ MARIA ISABEL. Secretario: QUESADA QUESADA MANUEL. Datos registrales. T 1860, L773, F 11, S 8, H MA 25300, I/A 17 ( 5.01.10).

27 de Julio de 2009
Nombramientos. Secretario: HERNANDEZ MATEO DE PORRAS PEDRO ALBERTO. Datos registrales. T 1860, L 773, F 11, S 8, HMA 25300, I/A 16 (13.07.09).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n