Actos BORME de Mercadona Sa
22 de Diciembre de 2023Revocaciones. Apo.Sol.: GISBERT CUÑAT VICENTE. Apoderado: RODRIGUEZ PASTRANA MARIA LOURDES. Apo.Sol.:RODRIGUEZ PASTRANA MARIA LOURDES. Nombramientos. Apoderado: MARTIN CASADO JOSE CARLOS. Datos registrales.T 11334, L 8612, F 137, S 8, H V 5581, I/A 416 (15.12.23).
20 de Diciembre de 2023Revocaciones. Apo.Sol.: GISBERT CUÑAT VICENTE. Apoderado: RODRIGUEZ PASTRANA MARIA LOURDES. Datos registrales.T 11334, L 8612, F 136, S 8, H V 5581, I/A 414 (13.12.23).
Revocaciones. Apo.Sol.: RODRIGUEZ PASTRANA MARIA LOURDES;GISBERT CUÑAT VICENTE. Nombramientos. Apoderado:TORRES CALATAYUD ADELA. Datos registrales. T 11334, L 8612, F 136, S 8, H V 5581, I/A 415 (13.12.23).
03 de Noviembre de 2023Revocaciones. Apo.Sol.: ALVAREZ VALCARCE ANGEL NIKE. Datos registrales. T 11334, L 8612, F 136, S 8, H V 5581, I/A 412(25.10.23).
Revocaciones. Apoderado: FERNANDEZ VILAS CARMEN. Datos registrales. T 11334, L 8612, F 136, S 8, H V 5581, I/A 413(25.10.23).
26 de Octubre de 2023Nombramientos. Apo.Sol.: GAZOLAZ FIDALGO FRANCISCO JAVIER. Apoderado: PEÑAFIEL GONZALEZ MARIA DEL PILAR.Datos registrales. T 11334, L 8612, F 135, S 8, H V 5581, I/A 411 (19.10.23).
13 de Octubre de 2023Revocaciones. Apo.Sol.: CHIERICATTI SANDRA GABRIELA PAULINA. Datos registrales. T 11334, L 8612, F 135, S 8, H V 5581,I/A 410 ( 5.10.23).
04 de Octubre de 2023Nombramientos. Apoderado: LUIS CAMARA SARADEY. Datos registrales. T 11334, L 8612, F 134, S 8, H V 5581, I/A 408(27.09.23).
Revocaciones. Apo.Sol.: ALVAREZ VALCARCE ANGEL NIKE. Datos registrales. T 11334, L 8612, F 135, S 8, H V 5581, I/A 409(27.09.23).
19 de Septiembre de 2023Nombramientos. Apo.Sol.: LUIS CAMARA SARADEY;GUILLEN JULIA JOAQUIN. Datos registrales. T 11334, L 8612, F 134, S 8, HV 5581, I/A 407 (12.09.23).
07 de Junio de 2023Revocaciones. Apo.Sol.: PIZA MARTIN ELENA;PEREZ-GANDARAS CARRETERO JACOBO. Datos registrales. T 11334, L 8612,F 133, S 8, H V 5581, I/A 403 (31.05.23).
27 de Abril de 2023Revocaciones. Apo.Sol.: VILLALBA MAGRANER PAU. Apoderado: VILLALBA MAGRANER PAU. Apo.Sol.: VILLALBA MAGRANERPAU. Datos registrales. T 11334, L 8612, F 133, S 8, H V 5581, I/A 402 (20.04.23).
26 de Abril de 2023Nombramientos. Con.Delegado: INMO ALAMEDA SL. Otros conceptos: El representante persona física del consejero delegado, lamercantil INMO ALAMEDA, S.L., es D. JUAN JOSE ROIG ALFONSO, con DNI 19.442.897-P. Datos registrales. T 11334, L 8612, F132, S 8, H V 5581, I/A 400 (19.04.23).
Revocaciones. Apoderado: PORTALES GIL JOSE ELIAS. Datos registrales. T 11334, L 8612, F 133, S 8, H V 5581, I/A 401(19.04.23).
14 de Abril de 2023Ceses/Dimisiones. Consejero: INMO ALAMEDA SL;HERRECHA INVERSIONES SL;GOMEZ GOMEZ RAFAEL. Con.Delegado:INMO ALAMEDA SL. Nombramientos. Consejero: INMO ALAMEDA SL;HERRECHA INVERSIONES SL;GOMEZ GOMEZ RAFAEL.Otros conceptos: La sociedad "INMO ALAMEDA SL" designa como persona física representante a DON JUAN JOSE ROIGALFONSO. La sociedad "HERRECHA INVERSIONES SL" designa como persona física representante a DOÑA DESAMPARADOSROIG HERRERO. Datos registrales. T 11334, L 8612, F 132, S 8, H V 5581, I/A 399 ( 5.04.23).
31 de Marzo de 2023Revocaciones. Apoderado: PORTALES GIL JOSE ELIAS. Datos registrales. T 10597, L 7878, F 139, S 8, H V 5581, I/A 397(24.03.23).
Revocaciones. Apoderado: PORTO DEL POZO BORJA. Datos registrales. T 11334, L 8612, F 132, S 8, H V 5581, I/A 398(24.03.23).
27 de Marzo de 2023Revocaciones. Apo.Sol.: CANO SUAREZ RAUL;PEREZ GALLARDO FEDERICO JOSE. Nombramientos. Apoderado: PLANELLSCOSTA FRANCISCA. Datos registrales. T 10597, L 7878, F 139, S 8, H V 5581, I/A 396 (17.03.23).
09 de Marzo de 2023Nombramientos. Apoderado: CEÑA CASAS MIRIAN. Datos registrales. T 10597, L 7878, F 138, S 8, H V 5581, I/A 393 ( 2.03.23).
Nombramientos. Apo.Sol.: MARCO TAMARIT HECTOR VICENTE;EVANGELISTA MOLINOS SALVADOR MANUEL. Datosregistrales. T 10597, L 7878, F 138, S 8, H V 5581, I/A 394 ( 2.03.23).
Revocaciones. Apoderado: MEGIAS GONZALEZ DIONISIO;FERREIRO SILVA FRANCISCO. Datos registrales. T 10597, L 7878, F138, S 8, H V 5581, I/A 395 ( 2.03.23).
03 de Marzo de 2023Revocaciones. Apo.Sol.: CORTIZAS SANCHEZ PATRICIA. Nombramientos. Apo.Sol.: CANO SUAREZ RAUL;PEREZ GALLARDOFEDERICO JOSE. Datos registrales. T 10597, L 7878, F 137, S 8, H V 5581, I/A 392 (24.02.23).
30 de Enero de 2023Revocaciones. Apo.Sol.: FERREIRO SILVA FRANCISCO. Datos registrales. T 10597, L 7878, F 137, S 8, H V 5581, I/A 390(23.01.23).
Revocaciones. Apoderado: ROSELLO SOLER FRANCESC. Nombramientos. Apoderado: FERNANDEZ FERNANDEZ LAURA.Datos registrales. T 10597, L 7878, F 137, S 8, H V 5581, I/A 391 (23.01.23).
27 de Diciembre de 2022Revocaciones. Apo.Sol.: MEGIAS GONZALEZ DIONISIO. Nombramientos. Apoderado: ARROYO RODRIGUEZ SAMUEL. Datosregistrales. T 10597, L 7878, F 136, S 8, H V 5581, I/A 389 (19.12.22).
13 de Diciembre de 2022Revocaciones. Apoderado: CASANS PASCUAL RAMON. Apo.Sol.: MARTINEZ ESCRIBANO MARIA DEL CARMEN.Nombramientos. Apoderado: COMPANY CASTELLO ARTURO. Datos registrales. T 10597, L 7878, F 136, S 8, H V 5581, I/A 388 (2.12.22).
29 de Noviembre de 2022Nombramientos. Apoderado: PAGAN LOZANO RUBEN. Datos registrales. T 10597, L 7878, F 135, S 8, H V 5581, I/A 386(22.11.22).
Nombramientos. Apoderado: CAVA FERNANDEZ DANIEL. Datos registrales. T 10597, L 7878, F 135, S 8, H V 5581, I/A 387(22.11.22).
25 de Octubre de 2022Revocaciones. Apo.Sol.: MARTINEZ ESCRIBANO MARIA DEL CARMEN. Datos registrales. T 10597, L 7878, F 135, S 8, H V5581, I/A 385 (18.10.22).
27 de Septiembre de 2022Nombramientos. Apoderado: MUÑOZ CALVENTE MARGARITA. Datos registrales. T 10597, L 7878, F 134, S 8, H V 5581, I/A 384(20.09.22).
19 de Septiembre de 2022Fe de erratas: error en la fecha de nombramiento que es 02/09/2022 y no 02/09/2023,. Datos registrales. T 10597, L 7878, F 134, S8, H V 5581, I/A 383 ( 5.09.22).
12 de Septiembre de 2022Revocaciones. Apo.Sol.: CASANS PASCUAL RAMON. Nombramientos. Apoderado: COMPANY CASTELLO ARTURO. Datosregistrales. T 10597, L 7878, F 134, S 8, H V 5581, I/A 383 ( 5.09.22).
05 de Julio de 2022Revocaciones. Apo.Sol.: GARCIA RODRIGUEZ ISRAEL. Nombramientos. Apo.Sol.: ARIZA RUIZ JOSE;ORTIZ SOLIS ALFONSO.Datos registrales. T 10597, L 7878, F 133, S 8, H V 5581, I/A 380 (28.06.22).
Nombramientos. Apoderado: INDIANO MUÑOZ MARIO. Datos registrales. T 10597, L 7878, F 133, S 8, H V 5581, I/A 381(28.06.22).
Revocaciones. Apoderado: JIMENEZ GARCIA FRANCISCO JOSE. Datos registrales. T 10597, L 7878, F 134, S 8, H V 5581, I/A382 (28.06.22).
13 de Junio de 2022Nombramientos. Apo.Sol.: INDIANO MUÑOZ MARIO;ORTIZ SOLIS ALFONSO. Datos registrales. T 10597, L 7878, F 132, S 8, H V5581, I/A 379 ( 3.06.22).
03 de Junio de 2022Revocaciones. Apo.Sol.: GARCIA RODRIGUEZ ISRAEL. Nombramientos. Apoderado: CASTELLS PALOMARES MARIA JOSE.Datos registrales. T 10597, L 7878, F 132, S 8, H V 5581, I/A 378 (27.05.22).
20 de Mayo de 2022Nombramientos. Apoderado: HERNANDEZ BOLIN HECTOR ALEJANDRO. Datos registrales. T 10597, L 7878, F 132, S 8, H V5581, I/A 377 (12.05.22).
05 de Abril de 2022Reelecciones. Consejero: ROIG HERRERO HORTENSIA;ROIG HERRERO CAROLINA;PORTOVAN SOCIEDAD LIMITADA.Secretario: ROIG HERRERO CAROLINA. MiCoAudi: ROIG HERRERO CAROLINA. SeCoAudi: ROIG HERRERO CAROLINA. Otrosconceptos: Como consecuencia de la renuncia de Doña Desamparados Roig Herrero a su cargo de consejera, presentada ante elconsejo de administración en su reunión de 1 de julio de 2021, objeto de la inscripción 357ª, se FIJA en NUEVE el número demiembros del consejo de administración. Datos registrales. T 10597, L 7878, F 131, S 8, H V 5581, I/A 376 (29.03.22).
01 de Abril de 2022Nombramientos. Apoderado: ARIZA RUIZ JOSE. Datos registrales. T 10597, L 7878, F 131, S 8, H V 5581, I/A 375 (25.03.22).
24 de Febrero de 2022Fe de erratas: Rectificada referencia 05491452021 BORME 242 de fecha 21/12/21 en cuanto a la identidad de la apoderado quedebe ser Dª PILAR TERESA SANZ RUBIO y no D. Javier Herrero Sobrino como por error consta. Datos registrales. T 10597, L 7878,F 129, S 8, H V 5581, I/A 368 (13.12.21).
Otros conceptos: Rectificada inscripción 368ª en cuanto al DNI/NIF de la apoderada así como rectificada igualmente la referencia05491452021 BORME 242 de fecha 21/12/21 en cuanto a la identidad de la apoderado que debe ser Dª PILAR TERESA SANZ RUBIOy no D. Javier Herrero Sobrino como por error consta. Datos registrales. T 10597, L 7878, F 131, S 8, H V 5581, I/A 374 (17.02.22).
08 de Febrero de 2022Nombramientos. Apo.Sol.: ZHOU DONGHAI;TORRES MATA CRISTINA. Datos registrales. T 10597, L 7878, F 130, S 8, H V 5581,I/A 373 ( 1.02.22).
24 de Diciembre de 2021Revocaciones. Apo.Sol.: MAGUREGUI SOMARRIBA JOANA. Datos registrales. T 10597, L 7878, F 130, S 8, H V 5581, I/A 372(17.12.21).
21 de Diciembre de 2021Nombramientos. Apoderado: HERRERO SOBRINO JAVIER. Datos registrales. T 10597, L 7878, F 129, S 8, H V 5581, I/A 368(13.12.21).
Nombramientos. Apo.Sol.: TORRES MATA CRISTINA;GARCIA TORTOSA RUTH;LOPEZ VILLANUEVA RAFAELHILARIO;GUILLEM JULIA JOAQUIN;BONDIA LLUESMA MARIA AMPARO. Datos registrales. T 10597, L 7878, F 129, S 8, H V5581, I/A 369 (13.12.21).
Nombramientos. Apoderado: LOPEZ SANCHA JOSE. Datos registrales. T 10597, L 7878, F 130, S 8, H V 5581, I/A 370 (13.12.21).
Nombramientos. Apoderado: ORTIZ IZQUIERDO ADOLFO. Datos registrales. T 10597, L 7878, F 130, S 8, H V 5581, I/A 371(13.12.21).
10 de Diciembre de 2021Nombramientos. Apoderado: ORTIZ IZQUIERDO ADOLFO. Datos registrales. T 10597, L 7878, F 128, S 8, H V 5581, I/A 367 (1.12.21).
30 de Noviembre de 2021Revocaciones. Apoderado: DEZFOLI ARJOMANDI MELIKA. Datos registrales. T 10597, L 7878, F 128, S 8, H V 5581, I/A 366(23.11.21).
17 de Noviembre de 2021Revocaciones. Apoderado: CORRALIZA CALDERON PEDRO. Datos registrales. T 10597, L 7878, F 128, S 8, H V 5581, I/A 365(10.11.21).
25 de Octubre de 2021Revocaciones. Apoderado: SUERO RUANO LORENA. Datos registrales. T 10597, L 7878, F 128, S 8, H V 5581, I/A 364(18.10.21).
08 de Octubre de 2021Nombramientos. Apoderado: ROSELLO SOLER FRANCESC. Datos registrales. T 10597, L 7878, F 127, S 8, H V 5581, I/A 363 (1.10.21).
21 de Septiembre de 2021Nombramientos. Apoderado: JIMENEZ GARCIA FRANCISCO JOSE;ROSELLO SOLER FRANCESC. Apo.Sol.: SAURISANTARRUFINA JOSE MANUEL;FERNANDO FIGUEROA PASTOR. Apoderado: RODRIGUEZ PASTRANA MARIA LOURDES.Datos registrales. T 10597, L 7878, F 127, S 8, H V 5581, I/A 362 (14.09.21).
13 de Septiembre de 2021Nombramientos. Apo.Sol.: GUILLEN JULIA JOAQUIN;BONDIA LLUESMA MARIA AMPARO. Datos registrales. T 10597, L 7878, F126, S 8, H V 5581, I/A 360 ( 7.09.21).
Nombramientos. Apo.Sol.: GUILLEN JULIA JOAQUIN;BONDIA LLUESMA MARIA AMPARO. Datos registrales. T 10597, L 7878, F127, S 8, H V 5581, I/A 361 ( 7.09.21).
04 de Agosto de 2021Ceses/Dimisiones. Consejero: ROIG HERRERO DESAMPARADOS. Datos registrales. T 10597, L 7878, F 126, S 8, H V 5581, I/A357 (28.07.21).
Otros conceptos: Dña. Desamparados Roig Herrero, con DNI-NIF número 29.195.742- W, ha sido designada como persona físicarepresentante de la mercantil "HERRECHA INVERSIONES, S.L." en el desempeño del cargo de Consejero de la sociedad"MERCADONA SA" en sustitución de doña Hortensia María Herrero Chacón. Datos registrales. T 10597, L 7878, F 126, S 8, H V5581, I/A 263 M (28.07.21).
Revocaciones. Apo.Sol.: RUIZ ORTIZ JOSE FRANCISCO. Datos registrales. T 10597, L 7878, F 126, S 8, H V 5581, I/A 358(28.07.21).
Revocaciones. Apo.Sol.: RUIZ ORTIZ JOSE FRANCISCO. Datos registrales. T 10597, L 7878, F 126, S 8, H V 5581, I/A 359(28.07.21).
05 de Julio de 2021Nombramientos. Apoderado: ESTEVAO MARTINS JORGE MIGUEL. Datos registrales. T 10597, L 7878, F 126, S 8, H V 5581, I/A356 (28.06.21).
14 de Mayo de 2021Revocaciones. Apo.Sol.: PRIETO GARCIA LUIS MIGUEL. Nombramientos. Apo.Sol.: GARCIA GONZALEZ ROSARIO;CANOVALLE JUAN JESUS;MARTINEZ TORRES LUIS. Datos registrales. T 10597, L 7878, F 123, S 8, H V 5581, I/A 353 ( 7.05.21).
Revocaciones. Apoderado: PRIETO GARCIA LUIS MIGUEL. Nombramientos. Apo.Sol.: GARCIA GONZALEZ ROSARIO;CANOVALLE JUAN JESUS. Datos registrales. T 10597, L 7878, F 123, S 8, H V 5581, I/A 354 ( 7.05.21).
Revocaciones. Apo.Sol.: PRIETO GARCIA LUIS MIGUEL. Apoderado: GUTIERREZ JIMENEZ JOSE;GUTIERREZ JIMENEZ JOSE.Datos registrales. T 10597, L 7878, F 123, S 8, H V 5581, I/A 355 ( 7.05.21).
11 de Mayo de 2021Nombramientos. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Reelecciones. Consejero: ROIG ALFONSO JUAN JOSE. Presidente: ROIGALFONSO JUAN JOSE. Consejero: HERRERO CHACON HORTENSIA MARIA. Vicepresid.: HERRERO CHACON HORTENSIAMARIA. Datos registrales. T 10597, L 7878, F 123, S 8, H V 5581, I/A 351 ( 4.05.21).
Modificaciones estatutarias. "Artículo 5: Capital Social. " . "Artículo 12: Junta Universal..". : "Artículo 16 bis: Depósito de las cuentasanuales.".. Otros conceptos: RECLASIFICACION Y RENUMERACION DE LAS ACCIONES. Datos registrales. T 10597, L 7878, F123, S 8, H V 5581, I/A 352 ( 4.05.21).
27 de Abril de 2021Revocaciones. Apoderado: DIAZ VILA PAULA ALEJANDRA. Datos registrales. T 10597, L 7878, F 123, S 8, H V 5581, I/A 350(20.04.21).
16 de Abril de 2021Nombramientos. Apoderado: PEREZ RODRIGUEZ SILVIA. Datos registrales. T 10597, L 7878, F 123, S 8, H V 5581, I/A 349 (9.04.21).
29 de Marzo de 2021Revocaciones. Apo.Sol.: GUTIERREZ JIMENEZ JOSE. Nombramientos. Apoderado: PACHECO SANCHEZ RAUL. Datosregistrales. T 10597, L 7878, F 120, S 8, H V 5581, I/A 348 (22.03.21).
22 de Marzo de 2021Nombramientos. Apoderado: AGUADO FERNANDEZ ROSA MARIA. Datos registrales. T 10597, L 7878, F 120, S 8, H V 5581, I/A343 (12.03.21).
Nombramientos. Apo.Sol.: MUÑOZ CALVENTE MARGARITA;RODRIGUEZ PASTRANA MARIA LOURDES. Datos registrales. T10597, L 7878, F 120, S 8, H V 5581, I/A 344 (12.03.21).
Nombramientos. Apo.Sol.: FORNER HERRANZ ENRIQUE;GISBERT CUÑAT VICENTE. Datos registrales. T 10597, L 7878, F 120,S 8, H V 5581, I/A 345 (12.03.21).
Nombramientos. Apoderado: MARCO TAMARIT HECTOR VICENTE. Datos registrales. T 10597, L 7878, F 120, S 8, H V 5581, I/A346 (12.03.21).
Nombramientos. Apoderado: HERRERO SOBRINO JAVIER. Datos registrales. T 10597, L 7878, F 120, S 8, H V 5581, I/A 347(12.03.21).
16 de Marzo de 2021Revocaciones. Apo.Sol.: MEIJIDE GUTIERREZ CARLOS JAVIER. Apoderado: CASTILLA ALONSO ESTRELLA. Nombramientos.Apoderado: FERREIRO SILVA FRANCISCO. Datos registrales. T 10597, L 7878, F 120, S 8, H V 5581, I/A 342 ( 9.03.21).
03 de Marzo de 2021Revocaciones. Apo.Sol.: CASTILLA ALONSO ESTRELLA. Nombramientos. Apo.Sol.: GAETJENS SMITH CELIA;FERREIROSILVA FRANCISCO;PIZA MARTIN ELENA;LLOP MEDINA JOSE ANGEL. Datos registrales. T 10597, L 7878, F 119, S 8, H V 5581,I/A 340 (24.02.21).
08 de Febrero de 2021Revocaciones. Apo.Sol.: MEIJIDE GUTIERREZ CARLOS JAVIER. Datos registrales. T 10597, L 7878, F 119, S 8, H V 5581, I/A339 ( 1.02.21).
11 de Enero de 2021Revocaciones. Apoderado: FERNANDEZ JIMENEZ JOSE ANTONIO. Datos registrales. T 10597, L 7878, F 119, S 8, H V 5581, I/A338 (31.12.20).
31 de Diciembre de 2020Nombramientos. Apoderado: CID LEON DAVID. Modificación de poderes. Apoderado: BERROCAL MUÑOZ RAFAEL. Datosregistrales. T 10597, L 7878, F 119, S 8, H V 5581, I/A 337 (23.12.20).
30 de Diciembre de 2020Revocaciones. Apo.Sol.: GERMAN MONGE JUAN ANTONIO. Apoderado: GERMAN MONGE JUAN ANTONIO. Datos registrales.T 10597, L 7878, F 116, S 8, H V 5581, I/A 334 (22.12.20).
Revocaciones. Apo.Sol.: BERROCAL MUÑOZ RAFAEL;GONZALEZ AMORIN ARIANA. Datos registrales. T 10597, L 7878, F 116,S 8, H V 5581, I/A 335 (22.12.20).
Nombramientos. Apoderado: TORRES MATA CRISTINA. Datos registrales. T 10597, L 7878, F 116, S 8, H V 5581, I/A 336(22.12.20).
27 de Noviembre de 2020Nombramientos. Apoderado: SOTO RUBIO ANTONIO. Datos registrales. T 10597, L 7878, F 116, S 8, H V 5581, I/A 332(23.11.20).
17 de Noviembre de 2020Nombramientos. Apo.Sol.: GONZALEZ BERNABEU MIGUEL ANGEL;ALONSO SANSANO NURIA;ANGLES HUGUET JOSEPMARIA;LOPEZ MOTILLA DAVID;MORENO SAMOS RAFAEL. Datos registrales. T 10597, L 7878, F 116, S 8, H V 5581, I/A 331 (9.11.20).
04 de Noviembre de 2020Nombramientos. Apo.Sol.: SOTO RUBIO ANTONIO;MAGUREGUI SOMARRIBA JOANA. Datos registrales. T 10597, L 7878, F116, S 8, H V 5581, I/A 330 (27.10.20).
18 de Septiembre de 2020Revocaciones. Apo.Sol.: FERNANDEZ JIMENEZ JOSE ANTONIO. Apoderado: REYES RICO ANTONIO. Datos registrales. T10597, L 7878, F 116, S 8, H V 5581, I/A 329 (11.09.20).
01 de Septiembre de 2020Nombramientos. Apoderado: BERISTAIN URRESTI IÑIGO. Datos registrales. T 10597, L 7878, F 116, S 8, H V 5581, I/A 328(25.08.20).
25 de Agosto de 2020Nombramientos. Apoderado: BERISTAIN URRESTI IÑIGO. Datos registrales. T 10597, L 7878, F 116, S 8, H V 5581, I/A 327(18.08.20).
31 de Julio de 2020Revocaciones. Apoderado: MIQUEL BOIX MARIA ANGELES;MIQUEL BOIX MARIA ANGELES. Datos registrales. T 10597, L7878, F 115, S 8, H V 5581, I/A 325 (24.07.20).
Nombramientos. Apo.Sol.: EVANGELISTA MOLINOS SALVADOR MANUEL;PEREZ RODRIGUEZ SILVIA;MARCO TAMARITHECTOR VICENTE. Datos registrales. T 10597, L 7878, F 115, S 8, H V 5581, I/A 326 (24.07.20).
15 de Julio de 2020Ceses/Dimisiones. PreCoAudi: GOMEZ GOMEZ RAFAEL. Nombramientos. PreCoAudi: ROIG HERRERO JUANA CLARA. Datosregistrales. T 10597, L 7878, F 115, S 8, H V 5581, I/A 324 ( 8.07.20).
07 de Julio de 2020Revocaciones. Apo.Sol.: RUIZ CAMPOS MARIA TRINIDAD;MIQUEL BOIX MARIA ANGELES. Nombramientos. Apo.Sol.: VIDALCANABAL JUAN ANTONIO;QUILIS NAVARRO ESTHER;MONASTERIO BARRICARTE SONIA. Datos registrales. T 10597, L 7878,F 114, S 8, H V 5581, I/A 323 (30.06.20).
23 de Junio de 2020Revocaciones. Apoderado: HERNANDEZ FLORES CAROLINA. Apo.Sol.: RUIZ CAMPOS MARIA TRINIDAD. Nombramientos.Apoderado: AGUILERA RODRIGUEZ CARMEN. Datos registrales. T 10597, L 7878, F 114, S 8, H V 5581, I/A 322 (16.06.20).
26 de Mayo de 2020Revocaciones. Apo.Sol.: HERNANDEZ FLORES CAROLINA. Nombramientos. Apo.Sol.: LORENZO CANTALEJOJOSEP;AGUILERA RODRIGUEZ CARMEN. Datos registrales. T 10597, L 7878, F 113, S 8, H V 5581, I/A 321 (19.05.20).
28 de Abril de 2020Reelecciones. Consejero: ROIG HERRERO JUANA CLARA. Auditor: DELOITTE SL. MiCoAudi: ROIG HERRERO JUANA CLARA.Datos registrales. T 10597, L 7878, F 113, S 8, H V 5581, I/A 320 (21.04.20).
31 de Marzo de 2020Nombramientos. Apoderado: PORTO DEL POZO BORJA. Datos registrales. T 10597, L 7878, F 112, S 8, H V 5581, I/A 318(24.03.20).
Nombramientos. Apoderado: PAGAN LOZANO RUBEN. Datos registrales. T 10597, L 7878, F 113, S 8, H V 5581, I/A 319(24.03.20).
03 de Marzo de 2020Nombramientos. Apoderado: PAGAN LOZANO RUBEN. Datos registrales. T 10597, L 7878, F 112, S 8, H V 5581, I/A 317(25.02.20).
14 de Febrero de 2020Nombramientos. Apo.Sol.: EVANGELISTA MOLINOS SALVADOR MANUEL;PEREZ RODRIGUEZ SILVIA;TORRES MATACRISTINA. Datos registrales. T 10597, L 7878, F 110, S 8, H V 5581, I/A 313 ( 7.02.20).
Revocaciones. Apoderado: BERNALTE PEREZ VICENTE. Datos registrales. T 10597, L 7878, F 111, S 8, H V 5581, I/A 314 (7.02.20).
Nombramientos. Apoderado: REYES RICO ANTONIO. Datos registrales. T 10597, L 7878, F 111, S 8, H V 5581, I/A 315 ( 7.02.20).
Nombramientos. Apo.Sol.: GARCIA TOLEDO JAVIER;ARNAU VILATA AITOR. Datos registrales. T 10597, L 7878, F 111, S 8, H V5581, I/A 316 ( 7.02.20).
24 de Diciembre de 2019Nombramientos. Apoderado: HERNANDEZ FLORES CAROLINA. Datos registrales. T 10597, L 7878, F 110, S 8, H V 5581, I/A311 (17.12.19).
Nombramientos. Apoderado: PORTALES GIL JOSE ELIAS. Datos registrales. T 10597, L 7878, F 110, S 8, H V 5581, I/A 312(17.12.19).
10 de Diciembre de 2019Revocaciones. Apo.Sol.: JIMENEZ CARRASCO JESUS MARIA. Nombramientos. Apo.Sol.: HERNANDEZ FLORES CAROLINA.Apoderado: FERNANDEZ VILAS CARMEN. Datos registrales. T 10597, L 7878, F 109, S 8, H V 5581, I/A 310 (29.11.19).
21 de Noviembre de 2019Página web de la sociedad. Traslado de la página web corporativa.Nueva página web: WWW.mercadona.es. Datos registrales. T10597, L 7878, F 109, S 8, H V 5581, I/A 308 (14.11.19).
06 de Noviembre de 2019Revocaciones. Apoderado: HERNANDEZ BOLIN HECTOR ALEJANDRO. Nombramientos. Apoderado: HERNANDEZ BOLINHECTOR ALEJANDRO. Datos registrales. T 10597, L 7878, F 106, S 8, H V 5581, I/A 301 (29.10.19).
Revocaciones. Apoderado: GIMENEZ PLASENCIA EUGENIO. Nombramientos. Apoderado: CANTALAPIEDRA MORENOANTONIO. Datos registrales. T 10597, L 7878, F 107, S 8, H V 5581, I/A 302 (29.10.19).
Revocaciones. Apoderado: GIMENEZ PLASENCIA EUGENIO. Nombramientos. Apoderado: LOPEZ VILLANUEVA RAFAELHILARIO. Datos registrales. T 10597, L 7878, F 107, S 8, H V 5581, I/A 303 (29.10.19).
Nombramientos. Apo.Sol.: PEREZ MARTINEZ EMILIANO;FERNANDEZ DIAZ ANA. Datos registrales. T 10597, L 7878, F 107, S 8,H V 5581, I/A 304 (29.10.19).
Nombramientos. Apoderado: ISERTE VICENTE MARIA JESUS. Datos registrales. T 10597, L 7878, F 108, S 8, H V 5581, I/A 305(29.10.19).
Nombramientos. Apoderado: GOMEZ PASCUAL JOSE MARIA. Datos registrales. T 10597, L 7878, F 108, S 8, H V 5581, I/A 306(29.10.19).
Nombramientos. Apoderado: BERROCAL MUÑOZ RAFAEL. Datos registrales. T 10597, L 7878, F 109, S 8, H V 5581, I/A 307(29.10.19).
30 de Octubre de 2019Nombramientos. Apoderado: FRANDES ECHARRI MANUEL. Datos registrales. T 10597, L 7878, F 106, S 8, H V 5581, I/A 300(23.10.19).
21 de Octubre de 2019Nombramientos. Apo.Sol.: FORNER HERRANZ ENRIQUE;GISBERT CUÑAT VICENTE;CHIERICATTI SANDRA GABRIELAPAULINA Datos registrales. T 10597, L 7878, F 105, S 8, H V 5581, I/A 299 (14.10.19).
20 de Septiembre de 2019Nombramientos. Apoderado: FERNANDEZ DIAZ ANA. Datos registrales. T 10597, L 7878, F 104, S 8, H V 5581, I/A 297(13.09.19).
Nombramientos. Apoderado: CORTEL AZCARRAGA LAURA. Datos registrales. T 10597, L 7878, F 105, S 8, H V 5581, I/A 298(13.09.19).
10 de Septiembre de 2019Nombramientos. Apo.Sol.: PEREZ MARTINEZ EMILIANO;GOMEZ GOMEZ ANDREA. Datos registrales. T 10597, L 7878, F 104, S8, H V 5581, I/A 296 ( 3.09.19).
05 de Septiembre de 2019Nombramientos. Apoderado: VIDAL PERAL NATALIA. Datos registrales. T 10597, L 7878, F 103, S 8, H V 5581, I/A 294(29.08.19).
Revocaciones. Apoderado: JURADO GOMEZ JUAN MANUEL. Nombramientos. Apoderado: ALVAREZ MENDEZ ARTUROMANUEL. Datos registrales. T 10597, L 7878, F 104, S 8, H V 5581, I/A 295 (29.08.19).
31 de Julio de 2019Nombramientos. Apoderado: DIAZ VILA PAULA ALEJANDRA. Datos registrales. T 10597, L 7878, F 103, S 8, H V 5581, I/A 293(24.07.19).
05 de Julio de 2019Nombramientos. Apoderado: VIDAL PERAL NATALIA. Datos registrales. T 10597, L 7878, F 102, S 8, H V 5581, I/A 292(28.06.19).
19 de Junio de 2019Revocaciones. Apoderado: BOSCH ILLA RAMON. Datos registrales. T 10597, L 7878, F 102, S 8, H V 5581, I/A 289 (11.06.19).
Nombramientos. Apoderado: GAETJENS SMITH CELIA. Datos registrales. T 10597, L 7878, F 102, S 8, H V 5581, I/A 290(12.06.19).
Nombramientos. Apoderado: MOLINA SEGURA ARANZAZU MARIA. Datos registrales. T 10597, L 7878, F 102, S 8, H V 5581, I/A291 (12.06.19).
18 de Junio de 2019Revocaciones. Apoderado: BOSCH ILLA RAMON. Nombramientos. Apoderado: HERNANDEZ BOLIN HECTOR ALEJANDRO.Datos registrales. T 10597, L 7878, F 101, S 8, H V 5581, I/A 288 (11.06.19).
12 de Junio de 2019Nombramientos. Apoderado: MOLINA SEGURA ARANZAZU MARIA. Datos registrales. T 10597, L 7878, F 101, S 8, H V 5581, I/A287 ( 5.06.19).
26 de Abril de 2019Revocaciones. Apoderado: LOPEZ ROZALEN FRANCISCO;LOPEZ ROZALEN FRANCISCO. Datos registrales. T 10597, L 7878, F98, S 8, H V 5581, I/A 281 (17.04.19).
Revocaciones. Apoderado: AGUADO FERNANDEZ ROSA MARIA. Nombramientos. Apoderado: AGUADO FERNANDEZ ROSAMARIA. Datos registrales. T 10597, L 7878, F 98, S 8, H V 5581, I/A 282 (17.04.19).
Nombramientos. Apoderado: GARCIA TORTOSA RUTH. Datos registrales. T 10597, L 7878, F 99, S 8, H V 5581, I/A 283(17.04.19).
Revocaciones. Apoderado: BERISTAIN URRESTI IÑIGO. Datos registrales. T 10597, L 7878, F 100, S 8, H V 5581, I/A 284(17.04.19).
Nombramientos. Apo.Sol.: BERROCAL MUÑOZ RAFAEL;GONZALEZ AMORIN ARIANA. Datos registrales. T 10597, L 7878, F100, S 8, H V 5581, I/A 285 (17.04.19).
Revocaciones. Apoderado: GOMEZ ROCAMORA MANUEL ANTONIO. Nombramientos. Apoderado: DEZFOLI ARJOMANDIMELIKA. Datos registrales. T 10597, L 7878, F 101, S 8, H V 5581, I/A 286 (18.04.19).
03 de Abril de 2019Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 10597, L 7878, F 98, S 8, H V 5581, I/A 280 (27.03.19).
02 de Abril de 2019Nombramientos. Apoderado: GARCIA TORTOSA RUTH. Datos registrales. T 10597, L 7878, F 97, S 8, H V 5581, I/A 279(26.03.19).
12 de Marzo de 2019Nombramientos. Apo.Sol.: SUERO RUANO LORENA;FERRE JUAN VICTOR MANUEL. Datos registrales. T 10597, L 7878, F 97,S 8, H V 5581, I/A 278 ( 5.03.19).
05 de Febrero de 2019Nombramientos. Apoderado: SANCHEZ ARANDA MARIA ROSA. Datos registrales. T 9873, L 7155, F 219, S 8, H V 5581, I/A 276(29.01.19).
Nombramientos. Apo.Sol.: PEREZ-GANDARAS CARRETERO JACOBO;GARCIA VALLS RAMON. Datos registrales. T 10597, L7878, F 97, S 8, H V 5581, I/A 277 (29.01.19).
19 de Noviembre de 2018Nombramientos. Apo.Sol.: MEIJIDE GUTIERREZ CARLOS JAVIER;MOYANO GONZALEZ RICARDO JESUS;BARRAGAN JIMENEZARMANDO;PERARNAU COMALLONGA ANA;ANNA ROSA GONZALEZ;CANO GUILLAMON JUANA MARIA;AFONSO CABRERAFATIMA;MARTIN CUESTA JOSE ANGEL;GIMENEZ MARTINEZ PILAR;ARRIOLA SERRANO ANA;NOGUERA SANCHEZJOSEFA;MARTINEZ ESCRIBANO MARIA DEL CARMEN;CASTILLA ALONSO ESTRELLA;MARTIN VEGA YOLANDA;FERNANDEZJIMENEZ JOSE ANTONIO;RUIZ CAMPOS MARIA TRINIDAD;CHILLIDA GONZALEZ ANA ISABEL;FERNANDEZ HERAS MARIALOURDES;ESCRIBANO MUÑOZ YOLANDA;HERNANDEZ ROJAS ANDRES;BADIA DONOSO SONIA;SALINAS REBOLLO MARIALUISA;GARCIA RODRIGUEZ ISRAEL;UZ PRADO MARIA EMILIA;XAMENA SANCHEZ MARIA DOLORS. Datos registrales. T 9873,L 7155, F 219, S 8, H V 5581, I/A 275 ( 9.11.18).
16 de Octubre de 2018Nombramientos. Apo.Sol.: MEIJIDE GUTIERREZ CARLOS JAVIER;UZ PRADO MARIA EMILIA;GARCIA VALLS RAMON. Datosregistrales. T 9873, L 7155, F 218, S 8, H V 5581, I/A 274 ( 8.10.18).
19 de Julio de 2018Nombramientos. Apo.Sol.: JIMENEZ CARRASCO JESUS MARIA;FERRE JUAN VICTOR MANUEL. Datos registrales. T 9873, L7155, F 218, S 8, H V 5581, I/A 273 (12.07.18).
02 de Julio de 2018Nombramientos. Apoderado: MIQUEL BOIX MARIA ANGELES. Datos registrales. T 9873, L 7155, F 217, S 8, H V 5581, I/A 270(25.06.18).
Nombramientos. Apoderado: ARRIOLA SERRANO ANA. Datos registrales. T 9873, L 7155, F 217, S 8, H V 5581, I/A 271(25.06.18).
Revocaciones. Apoderado: MALLUGUIZA CASTRO RAMON. Datos registrales. T 9873, L 7155, F 218, S 8, H V 5581, I/A 272(25.06.18).
26 de Junio de 2018Nombramientos. Apoderado: CORRALIZA CALDERON PEDRO. Datos registrales. T 9873, L 7155, F 216, S 8, H V 5581, I/A 269(19.06.18).
20 de Abril de 2018Nombramientos. Apo.Sol.: BATLLE POY JOAN;JIMENEZ CARRASCO JESUS MARIA;RUIZ ORTIZ JOSE FRANCISCO. Datosregistrales. T 9873, L 7155, F 215, S 8, H V 5581, I/A 266 (11.04.18).
18 de Abril de 2018Ceses/Dimisiones. Con.Delegado: INMO ALAMEDA SL. MiCoAudi: GOMEZ GOMEZ RAFAEL. PreCoAudi: GOMEZ GOMEZRAFAEL. Nombramientos. MiCoAudi: GOMEZ GOMEZ RAFAEL;ROIG HERRERO CAROLINA;ROIG HERRERO JUANA CLARA.PreCoAudi: GOMEZ GOMEZ RAFAEL. SeCoAudi: ROIG HERRERO CAROLINA. MiCoAudi: GOMEZ GOMEZ RAFAEL. PreCoAudi:GOMEZ GOMEZ RAFAEL. Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Consejero: INMO ALAMEDA SL;GOMEZ GOMEZRAFAEL;HERRECHA INVERSIONES SL. Otros conceptos: Juan José Roig Alfonso y Hortensia María Herrero Chacón quedannombrados personas físicas representantes de las consejeras reelegidas INMO ALAMEDA SL y HERRECHA INVERSIONES SL.Datos registrales. T 9873, L 7155, F 214, S 8, H V 5581, I/A 263 (11.04.18).
Nombramientos. Apoderado: BOSCH ILLA RAMON. Datos registrales. T 9873, L 7155, F 215, S 8, H V 5581, I/A 265 (11.04.18).
Nombramientos. Con.Delegado: INMO ALAMEDA SL. Datos registrales. T 9873, L 7155, F 215, S 8, H V 5581, I/A 264 (11.04.18).
Revocaciones. Apo.Sol.: MARTINEZ MORCILLO ALFONSO;MELENDEZ DIAZ AGUASANTA. Apoderado: CORTIZAS SANCHEZPATRICIA;GARCIA CLAVIJO JESUS MANUEL;DELGADO SOTO JUAN MANUEL. Nombramientos. Apo.Sol.: GARCIARODRIGUEZ ISRAEL;PERARNAU COMALLONGA ANA;XAMENA SANCHEZ MARIA DOLORS;CHILLIDA GONZALEZ ANAISABEL;BADIA DONOSO SONIA;SALINAS REBOLLO MARIA LUISA. Datos registrales. T 9873, L 7155, F 216, S 8, H V 5581, I/A267 (11.04.18).
Nombramientos. Apoderado: PEREZ-GANDARAS CARRETERO JACOBO. Datos registrales. T 9873, L 7155, F 216, S 8, H V5581, I/A 268 (11.04.18).
22 de Marzo de 2018Nombramientos. Apo.Sol.: CABEDO SERNA RICARD JOSEP;MELENDEZ DIAZ AGUASANTA;CORTIZAS SANCHEZ PATRICIA.Datos registrales. T 9873, L 7155, F 213, S 8, H V 5581, I/A 261 (15.03.18).
Revocaciones. Apoderado: ESCUDERO CERVERA JOSE VICENTE. Nombramientos. Apo.Sol.: BATLLE POY JOAN;JIMENEZCARRASCO JESUS MARIA;RUIZ ORTIZ JOSE FRANCISCO;PRIETO GARCIA LUIS MIGUEL;ALVAREZ VALCARCE ANGEL NIKE.Datos registrales. T 9873, L 7155, F 213, S 8, H V 5581, I/A 262 (15.03.18).
16 de Febrero de 2018Revocaciones. Apo.Sol.: MARZO DEL VISO JOSE MANUEL. Nombramientos. Apo.Sol.: ESCUDERO CERVERA JOSEVICENTE;PRIETO GARCIA LUIS MIGUEL;ALVAREZ VALCARCE ANGEL NIKE. Datos registrales. T 9873, L 7155, F 212, S 8, H V5581, I/A 260 ( 9.02.18).
25 de Enero de 2018Nombramientos. Apo.Sol.: RUIZ CAMPOS MARIA TRINIDAD;HERNANDEZ ROJAS ANDRES. Datos registrales. T 9873, L 7155, F212, S 8, H V 5581, I/A 258 (18.01.18).
Revocaciones. Apoderado: MENESES GONZALEZ JOSE MIGUEL. Datos registrales. T 9873, L 7155, F 212, S 8, H V 5581, I/A259 (18.01.18).
05 de Enero de 2018Revocaciones. Apo.Sol.: MARZO DEL VISO JOSE MANUEL. Nombramientos. Apoderado: ESCUDERO CERVERA JOSEVICENTE. Datos registrales. T 9873, L 7155, F 212, S 8, H V 5581, I/A 257 (28.12.17).
13 de Diciembre de 2017Revocaciones. Apo.Sol.: YAÑEZ GONZALEZ LUZ MARIA. Nombramientos. Apo.Sol.: ANDRES GARCIA BEATRIZ;RODRIGUEZPASTRANA MARIA LOURDES. Datos registrales. T 9873, L 7155, F 210, S 8, H V 5581, I/A 253 ( 4.12.17).
Revocaciones. Apoderado: RIVERA FAYOS AMPARO CARMEN. Nombramientos. Apoderado: HERRERO SOBRINO JAVIER.Datos registrales. T 9873, L 7155, F 211, S 8, H V 5581, I/A 254 ( 4.12.17).
Revocaciones. Apoderado: RIVERA FAYOS AMPARO CARMEN. Nombramientos. Apo.Sol.: HERRERO SOBRINOJAVIER;SOLAZ MONCAYO MIGUEL ANGEL. Datos registrales. T 9873, L 7155, F 211, S 8, H V 5581, I/A 255 ( 4.12.17).
17 de Noviembre de 2017Nombramientos. Apoderado: NOGUERA SANCHEZ JOSEFA. Datos registrales. T 9873, L 7155, F 209, S 8, H V 5581, I/A 251 (9.11.17).
Nombramientos. Apoderado: SUERO RUANO LORENA. Datos registrales. T 9873, L 7155, F 210, S 8, H V 5581, I/A 252 (9.11.17).
04 de Octubre de 2017Revocaciones. Apo.Sol.: YAÑEZ GONZALEZ LUZ MARIA. Nombramientos. Apo.Sol.: ANDRES GARCIA BEATRIZ. Apoderado:RODRIGUEZ PASTRANA MARIA LOURDES. Datos registrales. T 9873, L 7155, F 208, S 8, H V 5581, I/A 250 (26.09.17).
27 de Junio de 2017Nombramientos. Apoderado: GNERA ENERGIA Y TECNOLOGIA SL;GNERA ENERGIA Y TECNOLOGIA SL. Datos registrales. T9873, L 7155, F 207, S 8, H V 5581, I/A 246 (20.06.17).
Revocaciones. Apoderado: GARCIA GANS MARIA PILAR. Nombramientos. Apoderado: GIMENEZ PLASENCIA EUGENIO.Datos registrales. T 9873, L 7155, F 208, S 8, H V 5581, I/A 247 (20.06.17).
Nombramientos. Apoderado: ISERTE VICENTE MARIA JESUS. Datos registrales. T 9873, L 7155, F 208, S 8, H V 5581, I/A 248(20.06.17).
Nombramientos. Apoderado: MALLUGUIZA CASTRO RAMON. Datos registrales. T 9873, L 7155, F 208, S 8, H V 5581, I/A 249(20.06.17).
13 de Junio de 2017Nombramientos. Apoderado: ISERTE VICENTE MARIA JESUS. Datos registrales. T 9873, L 7155, F 207, S 8, H V 5581, I/A 245 (6.06.17).
23 de Mayo de 2017Nombramientos. Apoderado: RIVERA FAYOS AMPARO CARMEN. Datos registrales. T 9873, L 7155, F 206, S 8, H V 5581, I/A244 (16.05.17).
17 de Mayo de 2017Fusión por absorción. Sociedades absorbidas: MENA SUPERMERCADOS SL. SASKIBE SL. Datos registrales. T 9873, L 7155, F205, S 8, H V 5581, I/A 243 ( 9.05.17).
20 de Abril de 2017Revocaciones. Apo.Sol.: FUENTES MORENO GUSTAVO RAFAEL. Datos registrales. T 9873, L 7155, F 205, S 8, H V 5581, I/A240 (10.04.17).
Revocaciones. Apo.Sol.: FUENTES MORENO GUSTAVO RAFAEL. Datos registrales. T 9873, L 7155, F 205, S 8, H V 5581, I/A241 (11.04.17).
Nombramientos. Apoderado: GOMEZ ROCAMORA MANUEL ANTONIO. Datos registrales. T 9873, L 7155, F 205, S 8, H V 5581,I/A 242 (11.04.17).
29 de Marzo de 2017Reelecciones. Consejero: PORTOVAN SOCIEDAD LIMITADA;ROIG HERRERO CAROLINA. Secretario: ROIG HERREROCAROLINA. Consejero: ROIG HERRERO DESAMPARADOS. Auditor: DELOITTE SL. Consejero: ROIG HERRERO HORTENSIA.Datos registrales. T 9873, L 7155, F 204, S 8, H V 5581, I/A 239 (22.03.17).
13 de Febrero de 2017Nombramientos. Apoderado: GARCIA JIMENEZ CARLOS. Datos registrales. T 9873, L 7155, F 203, S 8, H V 5581, I/A 237 (6.02.17).
Nombramientos. Apoderado: LOPEZ VILLANUEVA RAFAEL HILARIO. Datos registrales. T 9873, L 7155, F 204, S 8, H V 5581, I/A238 ( 6.02.17).
02 de Febrero de 2017Nombramientos. Apo.Sol.: FUENTES MORENO GUSTAVO RAFAEL;GARCIA PONCE MARIA ISABEL;SOCORRO SANTANAMIGUEL ANGEL;YAÑEZ GONZALEZ LUZ MARIA;CORTIZAS SANCHEZ MARTA MARIA;CASANS PASCUAL RAMON;GARCIAJIMENEZ CARLOS;SANZO HERRERA JUAN JOSE;MEGIAS GONZALEZ DIONISIO. Datos registrales. T 9873, L 7155, F 203, S 8,H V 5581, I/A 236 (26.01.17).
02 de Enero de 2017Nombramientos. Apoderado: GUTIERREZ JIMENEZ JOSE. Datos registrales. T 9873, L 7155, F 202, S 8, H V 5581, I/A 235(23.12.16).
22 de Diciembre de 2016Nombramientos. Apo.Sol.: PLA CARCELLER LUIS IGNACIO;CABAÑAS LOPEZ MARTA;MIQUEL BOIX MARIA ANGELES;SAURISANTARRUFINA JOSE MANUEL;MARZO DEL VISO JOSE MANUEL;GUTIERREZ JIMENEZ JOSE. Datos registrales. T 9873, L7155, F 202, S 8, H V 5581, I/A 234 (15.12.16).
20 de Septiembre de 2016Nombramientos. Apoderado: MONZON GARCIA ELENA. Datos registrales. T 9873, L 7155, F 201, S 8, H V 5581, I/A 232(13.09.16).
Nombramientos. Apoderado: TORRES MATA CRISTINA. Datos registrales. T 9873, L 7155, F 201, S 8, H V 5581, I/A 233(13.09.16).
30 de Junio de 2016Nombramientos. Apoderado: MARTIN VEGA YOLANDA. Datos registrales. T 9873, L 7155, F 201, S 8, H V 5581, I/A 231(23.06.16).
27 de Junio de 2016Otros conceptos: Extinción del poder conferido a DOÑA ROSA MARIA MUÑOZ MOLINA objeto de la inscripción 123ª, comoconsecuencia de su fallecimiento ocurrido el día 17 de enero de 2008. Extinción del poder conferido a DON BRAULIO PASTORAZNAR que fue objeto de la inscripción 119ª, como consecuencia de su fallecimiento ocurrido el día 3 de abril de 2013. Datosregistrales. T 9873, L 7155, F 200, S 8, H V 5581, I/A 230 (20.06.16).
01 de Junio de 2016Revocaciones. Apoderado: JUAN MAÑEZ MANUEL. Datos registrales. T 9873, L 7155, F 200, S 8, H V 5581, I/A 228 (25.05.16).
Revocaciones. Apoderado: GARCES LOPEZ MARTA. Datos registrales. T 9873, L 7155, F 200, S 8, H V 5581, I/A 229 (25.05.16).
23 de Mayo de 2016Fe de erratas: D. SALVADOR ALIAGA PALAO que aparece como apoderado de MERCADONA SA en el envío 52 del año 1998,habiendo sido revocado su poder el 14/07/1997 y, por tal error, rectificar la insc. 86 del tomo 3073 folio 196 hoja V-5581 con fecha06/07/1998, no debiendo aparecer dicho Sr. como apoderado. Datos registrales. T 3073, L 389, F 196, S 8, H V 5581, I/A 87 (6.07.98).
10 de Mayo de 2016Modificaciones estatutarias. Adición de los artículos 14BIS y 14TER a los estatutos sociales. Datos registrales. T 9873, L 7155, F200, S 8, H V 5581, I/A 227 ( 3.05.16).
06 de Mayo de 2016Revocaciones. Apoderado: MONTES SUAREZ RAQUEL. Datos registrales. T 9873, L 7155, F 200, S 8, H V 5581, I/A 226(28.04.16).
20 de Abril de 2016Nombramientos. Apoderado: GOMEZ PASCUAL JOSE MARIA. Datos registrales. T 9873, L 7155, F 199, S 8, H V 5581, I/A 225(13.04.16).
23 de Marzo de 2016Reelecciones. Consejero: ROIG ALFONSO JUAN JOSE. Presidente: ROIG ALFONSO JUAN JOSE. Auditor: DELOITTE SL.Consejero: HERRERO CHACON HORTENSIA MARIA. Vicepresid.: HERRERO CHACON HORTENSIA MARIA. Datos registrales. T9873, L 7155, F 199, S 8, H V 5581, I/A 224 (16.03.16).
25 de Febrero de 2016Otros conceptos: Extinción del poder objeto de la inscripción 113& como consecuencia del fallecimiento del apoderado Don RicardoVíctor Martínez Durán, el día 7 de enero de 2016. Datos registrales. T 9873, L 7155, F 199, S 8, H V 5581, I/A 223 (18.02.16).
18 de Enero de 2016Revocaciones. Apo.Sol.: JIMENEZ IGLESIAS MIGUEL ANGEL. Datos registrales. T 9873, L 7155, F 199, S 8, H V 5581, I/A 222(11.01.16).
31 de Diciembre de 2015Nombramientos. Apoderado: AGUADO FERNANDEZ ROSA MARIA. Datos registrales. T 9873, L 7155, F 197, S 8, H V 5581, I/A220 (23.12.15).
Nombramientos. Apoderado: MIQUEL BOIX MARIA ANGELES. Datos registrales. T 9873, L 7155, F 198, S 8, H V 5581, I/A 221(23.12.15).
22 de Junio de 2015Revocaciones. Apo.Sol.: APARICIO CABALLER FRANCISCO. Datos registrales. T 9873, L 7155, F 197, S 8, H V 5581, I/A 219(15.06.15).
15 de Abril de 2015Reelecciones. Consejero: ROIG HERRERO JUANA CLARA. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 9873, L 7155, F 197, S 8,H V 5581, I/A 218 ( 8.04.15).
31 de Marzo de 2015Nombramientos. Apoderado: BOSCH ILLA RAMON. Datos registrales. T 3837, L 1149, F 148, S 8, H V 5581, I/A 217 (24.03.15).
12 de Enero de 2015Nombramientos. Apoderado: TORRES MATA CRISTINA. Datos registrales. T 3837, L 1149, F 147, S 8, H V 5581, I/A 215 (2.01.15).
Nombramientos. Apoderado: GARCIA GANS MARIA PILAR. Datos registrales. T 3837, L 1149, F 148, S 8, H V 5581, I/A 216 (2.01.15).
21 de Agosto de 2014Nombramientos. Apoderado: LOPEZ VILLANUEVA RAFAEL HILARIO. Datos registrales. T 3837, L 1149, F 147, S 8, H V 5581, I/A214 (13.08.14).
09 de Mayo de 2014Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 3837, L 1149, F 147, S 8, H V 5581, I/A 213 ( 2.05.14).
31 de Marzo de 2014Otros conceptos: =EXTINGUIDO= el poder conferido en la inscripciones 65&, 70& y 116&, a =DON CARLOS CALERO VENTOSO,=por su fallecimiento acaecido el día 29 de septiembre de 2005, según resulta de certificación literal de defunción librada el día 19 dediciembre de 2013 por el Registro Civil de Valencia. Datos registrales. T 3073, L 389, F 206, S 8, H V 5581, I/A116/M (20.03.14).
29 de Octubre de 2013Nombramientos. Apoderado: ORTIZ AREVALO DIEGO. Datos registrales. T 3837, L 1149, F 146, S 8, H V 5581, I/A 212(21.10.13).
08 de Octubre de 2013Nombramientos. Apoderado: SOCORRO SANTANA MIGUEL ANGEL. Datos registrales. T 3837, L 1149, F 146, S 8, H V 5581, I/A210 ( 1.10.13).
Nombramientos. Apoderado: PORTALES GIL JOSE ELIAS. Datos registrales. T 3837, L 1149, F 146, S 8, H V 5581, I/A 211 (1.10.13).
18 de Junio de 2013Revocaciones. Apoderado: MULAS VILLAR JUAN RAMON. Datos registrales. T 3837, L 1149, F 145, S 8, H V 5581, I/A 208(11.06.13).
Nombramientos. Apoderado: GERMAN MONGE JUAN ANTONIO. Datos registrales. T 3837, L 1149, F 145, S 8, H V 5581, I/A 209(11.06.13).
08 de Mayo de 2013Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 3837, L 1149, F 145, S 8, H V 5581, I/A 207 (29.04.13).
11 de Abril de 2013Ceses/Dimisiones. Consejero: HERRECHA INVERSIONES SL;GOMEZ GOMEZ RAFAEL. Con.Delegado: INMO ALAMEDA SL.Nombramientos. Consejero: INMO ALAMEDA SL;GOMEZ GOMEZ RAFAEL;HERRECHA INVERSIONES SL. Otros conceptos:D.Juan José Roig Aflonso continúa como persona física representante de la consejera reelegida, la mercantil "INMO ALAMEDA SL"; yD& Hortensia María Herrero Chacón continúa como persona física representante de la consejera reelegida, la mercantil "HERRECHAINVERSIONES SL". Datos registrales. T 3837, L 1149, F 144, S 8, H V 5581, I/A 204 ( 4.04.13).
Nombramientos. Con.Delegado: INMO ALAMEDA SL. Datos registrales. T 3837, L 1149, F 145, S 8, H V 5581, I/A 205 ( 4.04.13).
Revocaciones. Apoderado: ILLAN VIVAS JOSE RAMON;DE LA PRIETA RODRIGUEZ MARIA ARANZAZU. Datos registrales. T3837, L 1149, F 145, S 8, H V 5581, I/A 206 ( 4.04.13).
20 de Marzo de 2013Nombramientos. Apoderado: BERISTAIN URRESTI IÑIGO. Datos registrales. T 3837, L 1149, F 144, S 8, H V 5581, I/A 203(12.03.13).
07 de Diciembre de 2012Nombramientos. Apoderado: CASTILLA ALONSO ESTRELLA. Datos registrales. T 3837, L 1149, F 144, S 8, H V 5581, I/A 202(28.11.12).
11 de Octubre de 2012Nombramientos. Apoderado: DE LA PRIETA RODRIGUEZ MARIA ARANZAZU. Datos registrales. T 3837, L 1149, F 143, S 8, H V5581, I/A 201 ( 2.10.12).
21 de Septiembre de 2012Nombramientos. Apoderado: GONZALEZ VELAZQUEZ CARMEN. Datos registrales. T 3837, L 1149, F 143, S 8, H V 5581, I/A 200(12.09.12).
14 de Septiembre de 2012Nombramientos. Apoderado: MULAS VILLAR JUAN RAMON. Datos registrales. T 3837, L 1149, F 143, S 8, H V 5581, I/A 199 (5.09.12).
16 de Agosto de 2012Revocaciones. Apo.Sol.: LOPEZ MARTINEZ JUST. Datos registrales. T 3837, L 1149, F 142, S 8, H V 5581, I/A 198 ( 6.08.12).
27 de Junio de 2012Modificaciones estatutarias. Articulo 5: CAPITAL SOCIAL. Datos registrales. T 3837, L 1149, F 142, S 8, H V 5581, I/A 197(18.06.12).
15 de Junio de 2012Nombramientos. Apoderado: MEGIAS GONZALEZ DIONISIO. Datos registrales. T 3837, L 1149, F 142, S 8, H V 5581, I/A 196 (6.06.12).
10 de Abril de 2012Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Consejero: PORTOVAN SOCIEDAD LIMITADA;ROIG HERRERO HORTENSIA;ROIGHERRERO CAROLINA;ROIG HERRERO DESAMPARADOS. Secretario: ROIG HERRERO CAROLINA. Datos registrales. T 3837, L1149, F 142, S 8, H V 5581, I/A 195 (28.03.12).
31 de Enero de 2012Otros conceptos: La página web corporativa de la sociedad a los efectos de publicaciones es la siguiente:www.mercadona.es/ns/index.php. Datos registrales. T 3837, L 1149, F 141, S 8, H V 5581, I/A 194 (20.01.12).
27 de Enero de 2012Modificaciones estatutarias. Modificar el artículo 5º y suprimir el 5 bis.-.Adicionar al Artículo 6º los apartados 6bis y 6ter. Datosregistrales. T 3074, L 390, F 113, S 8, H V 5581, I/A 193 (18.01.12).
22 de Diciembre de 2011Nombramientos. Apo.Sol.: CORTIZAS SANCHEZ MARTA MARIA;YAÑEZ GONZALEZ LUZ MARIA;GARCIA PONCE MARIAISABEL. Datos registrales. T 3074, L 390, F 113, S 8, H V 5581, I/A 191 (13.12.11).
Revocaciones. Apoderado: RODRIGUEZ BATISTA MANUEL. Apo.Sol.: VEGA MARTINEZ JOAQUIN. Datos registrales. T 3074, L390, F 113, S 8, H V 5581, I/A 192 (13.12.11).
01 de Junio de 2011Revocaciones. Apoderado: PASTOR AGUDO JOSE ANTONIO. Datos registrales. T 3074, L 390, F 112, S 8, H V 5581, I/A 189(23.05.11).
Revocaciones. Apo.Sol.: MARTIN DIAZ ROSA MARIA. Datos registrales. T 3074, L 390, F 112, S 8, H V 5581, I/A 190 (23.05.11).
12 de Mayo de 2011Nombramientos. Consejero: ROIG ALFONSO JUAN JOSE. Presidente: ROIG ALFONSO JUAN JOSE. Consejero: HERREROCHACON HORTENSIA MARIA. Vicepresid.: HERRERO CHACON HORTENSIA MARIA. Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL.Datos registrales. T 3074, L 390, F 112, S 8, H V 5581, I/A 188 ( 3.05.11).
20 de Abril de 2011Cancelaciones de oficio de nombramientos. Vicepresid.: HERRERO CHACON HORTENSIA. Consejero: HERRERO CHACONHORTENSIA. Presidente: ROIG ALFONSO JUAN JOSE. Consejero: ROIG ALFONSO JUAN JOSE. Datos registrales. T 3074, L 390,F 112, S 8, H V 5581, I/A 148 M ( 8.04.11).
07 de Abril de 2011Nombramientos. Apoderado: CANO GUILLAMON JUANA MARIA. Datos registrales. T 3074, L 390, F 112, S 8, H V 5581, I/A 187(29.03.11).
03 de Noviembre de 2010Nombramientos. Apoderado: MENESES GONZALEZ JOSE MIGUEL;JURADO GOMEZ JUAN MANUEL. Datos registrales. T 3073,L 389, F 225, S 8, H V 5581, I/A 186 (22.10.10).
21 de Octubre de 2010Nombramientos. Apoderado: FERNANDEZ JIMENEZ JOSE ANTONIO. Datos registrales. T 3073, L 389, F 225, S 8, H V 5581, I/A185 (11.10.10).
31 de Agosto de 2010Nombramientos. Apoderado: LOPEZ ROZALEN FRANCISCO. Datos registrales. T 3073, L 389, F 224, S 8, H V 5581, I/A 182(20.08.10).
Nombramientos. Apo.Sol.: AGUADO FERNANDEZ ROSA MARIA;SANZO HERRERA JUAN JOSE. Datos registrales. T 3073, L389, F 224, S 8, H V 5581, I/A 183 (20.08.10).
Revocaciones. Apo.Sol.: OLIVER MORAGUES JUAN ANTONIO;OLIVER MORAGUES JUAN ANTONIO;CAZORLA RAYAALONSO;BELENCHON GONZALEZ JUSTO JOSE;MOMPO CHINESTA JOAQUIN;MARTINEZ GUTIERREZ JUAN JOSE.Apoderado:BLASCO GARCIA VICENTE HECTOR;GOMEZ PEREZ JESUS;GOMEZ GOMEZ RAFAEL;VILANA GALVAÑON RAFAEL;FORTEAGARCES GERARDO;GOMEZ GOMEZ RAFAEL;SAMPER LOPEZ JOSE CORNELIO. Apo.Sol.: BETI AGUIRREBENGOAVICTOR;VALDIVIELSO NAVARRO ANGEL;GARCIA LOPEZ DAVID;PASCUAL NAVARRO JOSE VICENTE. Apoderado:HERNANDEZ MELIA ALFONSO ANTONIO. Datos registrales. T 3073, L 389, F 225, S 8, H V 5581, I/A 184 (20.08.10).
11 de Mayo de 2010Nombramientos. Apoderado: MONTES SUAREZ RAQUEL. Datos registrales. T 3073, L 389, F 223, S 8, H V 5581, I/A 181(30.04.10).
29 de Abril de 2010Reelecciones. Consejero: ROIG HERRERO JUANA CLARA. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 3073, L 389, F 223, S 8, HV 5581, I/A 179 (20.04.10).
Revocaciones. Apoderado: BLANES CARBONELL JOSE LUIS. Datos registrales. T 3073, L 389, F 223, S 8, H V 5581, I/A 180(20.04.10).
01 de Marzo de 2010Nombramientos. Apo.Sol.: DEL PALACIO AGEA LAURA;CASADO LABRADOR JOSE JULIO. Datos registrales. T 3073, L 389, F223, S 8, H V 5581, I/A 178 (18.02.10).
23 de Febrero de 2010Nombramientos. Apoderado: LOPEZ ROZALEN FRANCISCO. Datos registrales. T 3073, L 389, F 222, S 8, H V 5581, I/A 176(12.02.10).
Nombramientos. Apoderado: DELGADO SOTO JUAN MANUEL. Datos registrales. T 3073, L 389, F 222, S 8, H V 5581, I/A 177(12.02.10).
15 de Febrero de 2010Nombramientos. Apoderado: IGLESIAS PRADA NOELIA. Datos registrales. T 3073, L 389, F 222, S 8, H V 5581, I/A 175 (4.02.10).
18 de Mayo de 2009Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 3073, L 389, F 221, S 8, H V 5581, I/A 174 ( 6.05.09).
24 de Abril de 2009Revocaciones. Apoderado: ARAGON SANCHEZ RAFAEL ANGEL. Datos registrales. T 3073, L 389, F 221, S 8, H V 5581, I/A 172(15.04.09).
Nombramientos. Apoderado: GIMENEZ PLASENCIA EUGENIO. Datos registrales. T 3073, L 389, F 221, S 8, H V 5581, I/A 173(15.04.09).
23 de Enero de 2009Nombramientos. Apoderado: GARCIA CLAVIJO JESUS MANUEL. Datos registrales. T 3073, L 389, F 221, S 8, H V 5581, I/A 171(14.01.09).