Buscador CIF Logo

Actos BORME Mercados Centrales De Abastecimiento De Murcia Sa

驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Mercados Centrales De Abastecimiento De Murcia Sa

Actos BORME Mercados Centrales De Abastecimiento De Murcia Sa - A30015952

Tenemos registrados 31 Actos BORME del Registro Mercantil de Murcia para Mercados Centrales De Abastecimiento De Murcia Sa con CIF A30015952

馃敊 Perfil de Mercados Centrales De Abastecimiento De Murcia Sa
馃洅 Comprar listado completo de Empresas de Murcia

Actos BORME de Mercados Centrales De Abastecimiento De Murcia Sa

31 de Mayo de 2023
Reelecciones. Vicepr.1: ALFREDO SUAZ GONZALEZ. Consejero: ALFREDO SUAZ GONZALEZ;MARIA ISABEL BALBUENAJIMENEZ. Datos registrales. T 2400 , F 50, S 8, H MU 18011, I/A 84 (24.05.23).

16 de Febrero de 2023
Nombramientos. Consejero: PURIFICACION VERDEJO COCA. Datos registrales. T 2400 , F 50, S 8, H MU 18011, I/A 83 (9.02.23).

27 de Diciembre de 2022
Ceses/Dimisiones. Consejero: PEDRO VILLOLDO MAZO. Datos registrales. T 2400 , F 50, S 8, H MU 18011, I/A 82 (19.12.22).

21 de Junio de 2022
Reelecciones. Auditor: BLAZQUEZ & ASOCIADOS AUDITORES SLP. Datos registrales. T 2400 , F 49, S 8, H MU 18011, I/A 81(14.06.22).

09 de Junio de 2022
Reelecciones. Consejero: LAURA TORRE ALVAREZ. Datos registrales. T 2400 , F 49, S 8, H MU 18011, I/A 80 ( 2.06.22).

29 de Noviembre de 2021
Reelecciones. Consejero: LAURA TORRE ALVAREZ. Datos registrales. T 2400 , F 49, S 8, H MU 18011, I/A 79 (22.11.21).

12 de Noviembre de 2021
Nombramientos. Consejero: MARIA TERESA CASTILLO PASALODOS. Datos registrales. T 2400 , F 49, S 8, H MU 18011, I/A 77 (4.11.21).

Ceses/Dimisiones. Consejero: JOSE BALLESTA GERMAN. Presidente: JOSE BALLESTA GERMAN. Vicepr.2: JUAN FERNANDOHERNANDEZ PIERNAS. Nombramientos. Consejero: JOSE ANTONIO SERRANO MARTINEZ. Presidente: JOSE ANTONIOSERRANO MARTINEZ. Vicepr.2: JUAN VICENTE LARROSA GARRE. Datos registrales. T 2400 , F 49, S 8, H MU 18011, I/A 78 (4.11.21).

19 de Octubre de 2020
Nombramientos. Apoderado: RICARDO RUBIO AROCA. Datos registrales. T 2400 , F 48, S 8, H MU 18011, I/A 76 ( 9.10.20).

10 de Julio de 2020
Ceses/Dimisiones. Consejero: SILVIA LLERENA MU脩OZ. Vicepr.1: SILVIA LLERENA MU脩OZ. Consejero: JOSE ANTONIOCASANOVA GAYOSO;PEDRO ANTONIO MONTELONGO MARTIN. Nombramientos. Consejero: ALFREDO SUAZGONZALEZ;MARIA ISABEL BALBUENA JIMENEZ;CLARA CALDERON RUIZ;PEDRO VILLOLDO MAZO. Vicepr.1: ALFREDO SUAZGONZALEZ. Datos registrales. T 2400 , F 48, S 8, H MU 18011, I/A 73 ( 3.07.20).

Ceses/Dimisiones. Consejero: MARIA DEL CARMEN PELEGRIN GARCIA;JUAN VICENTE LARROSA GARRE;FRANCISCA PEREZLOPEZ;JOSE BALLESTA GERMAN. Presidente: JOSE BALLESTA GERMAN. Consejero: CLARA CALDERON RUIZ.Nombramientos. Consejero: JOSE BALLESTA GERMAN. Presidente: JOSE BALLESTA GERMAN. Vicepr.2: JUAN FERNANDOHERNANDEZ PIERNAS. Consejero: JUAN FERNANDO HERNANDEZ PIERNAS;JUAN VICENTE LARROSA GARRE;MERCEDESBERNABE PEREZ;INMACULADA ORTEGA DOMINGUEZ;CLARA MARIA MARTINEZ BAEZA. Datos registrales. T 2400 , F 48, S 8,H MU 18011, I/A 74 ( 3.07.20).

Reelecciones. Auditor: BLAZQUEZ & ASOCIADOS AUDITORES SLP. Datos registrales. T 2400 , F 48, S 8, H MU 18011, I/A 75 (3.07.20).

29 de Agosto de 2019
Otros conceptos: Se modifican los Estatutos Sociales para adaptarlos a la Ley de Sociedades de Capital. Modificaci贸n de duraci贸n:Indefinida. P谩gina web de la sociedad. Creaci贸n de la p谩gina web corporativa: www.mercamurcia.es. Datos registrales. T 2400 , F46, S 8, H MU 18011, I/A 72 (22.08.19).

12 de Abril de 2018
Ceses/Dimisiones. Consejero: MARIA DOLORES ALARCON MARTINEZ;FLORENCIO CASILLAS MARTIN. Nombramientos.Consejero: PEDRO ANTONIO MONTELONGO MARTIN;JOSE ANTONIO CASANOVA GAYOSO. Datos registrales. T 2400 , F 46, S8, H MU 18011, I/A 70 ( 6.04.18).

Ceses/Dimisiones. Consejero: ANTONIO MARIN PEREZ;M陋 CECILIA MILANES HERNANDEZ. Secretario: ANTONIO MARINPEREZ. Nombramientos. SecreNoConsj: ANTONIO MARIN PEREZ. Reelecciones. Consejero: JOSE ANTONIO CASANOVA

24 de Noviembre de 2016
Nombramientos. Auditor: BLAZQUEZ & ASOCIADOS AUDITORES SLP. Datos registrales. T 2400 , F 46, S 8, H MU 18011, I/A 69(17.11.16).

22 de Abril de 2016
Nombramientos. Consejero: JOSE BALLESTA GERMAN. Presidente: JOSE BALLESTA GERMAN. Fe de erratas: Al publicar lainscripcion 68 se omitio el nombramiento de Don Jose Ballesta German como consejero y presidente del Consejo por plazo de tresa帽os. Datos registrales. T 2400 , F 45, S 8, H MU 18011, I/A 68 (28.10.15).

04 de Noviembre de 2015
Ceses/Dimisiones. Consejero: MIGUEL ANGEL CAMARA BOTIA;CRISTOBAL HERRERO MARTINEZ;ANDREA JUDIT GARRIESMEDINA;ESTHER HERGUEDAS APARICIO. Presidente: MIGUEL ANGEL CAMARA BOTIA. Vicepresid.: CRISTOBAL HERREROMARTINEZ. Nombramientos. Consejero: MARIA DEL CARMEN PELEGRIN GARCIA;JUAN VICENTE LARROSAGARRE;FRANCISCA PEREZ LOPEZ. Vicepr.1: SILVIA LLERENA MU脩OZ. Reelecciones. Consejero: SILVIA LLERENA MU脩OZ.Datos registrales. T 2400 , F 45, S 8, H MU 18011, I/A 68 (28.10.15).

20 de Agosto de 2015
Ceses/Dimisiones. Consejero: MELANIE GONZALEZ VIVERO;PABLO MANUEL GONZALEZ GONZALEZ. Nombramientos.Consejero: JORGE FLORES ALVAREZ;LAURA TORRE ALVAREZ. Datos registrales. T 2400 , F 45, S 8, H MU 18011, I/A 67(13.08.15).

26 de Septiembre de 2014
Nombramientos. Apoderado: RICARDO RUBIO AROCA. Datos registrales. T 2400 , F 43, S 8, H MU 18011, I/A 65 (19.09.14).

Revocaciones. Apoderado: MARTIN PE脩A DE LA FUENTE. Datos registrales. T 2400 , F 45, S 8, H MU 18011, I/A 66 (19.09.14).

04 de Abril de 2014
Ceses/Dimisiones. Consejero: APOLINAR GOMEZ MARTINEZ;GUILLERMO HERRAIZ ARTERO;JOSE-ANTONIO DE RUEDA Y DERUEDA. Secretario: JOSE-ANTONIO DE RUEDA Y DE RUEDA. Nombramientos. Consejero: SILVIA LLERENA MU脩OZ.Vicepresid.: SILVIA LLERENA MU脩OZ. Consejero: PABLO MANUEL GONZALEZ GONZALEZ;ANTONIO MARIN PEREZ. Secretario:ANTONIO MARIN PEREZ. Reelecciones. Consejero: FLORENCIO CASILLAS MARTIN;MELANIE GONZALEZ VIVERO;MARIADOLORES ALARCON MARTINEZ;M& CECILIA MILANES HERNANDEZ;MIGUEL ANGEL CAMARA BOTIA;CRISTOBAL HERREROMARTINEZ;ANDREA JUDIT GARRIES MEDINA;ESTHER HERGUEDAS APARICIO. Presidente: MIGUEL ANGEL CAMARA BOTIA.Vicepresid.: CRISTOBAL HERRERO MARTINEZ. Datos registrales. T 2400 , F 43, S 8, H MU 18011, I/A 62 (28.03.14).

Nombramientos. Auditor: ABANTE AUDIEST AUDITORES SAP. Datos registrales. T 2400 , F 43, S 8, H MU 18011, I/A 63(28.03.14).

Nombramientos. Auditor: SECTOR 3 SAP. Datos registrales. T 2400 , F 43, S 8, H MU 18011, I/A 64 (28.03.14).

17 de Febrero de 2012
Ceses/Dimisiones. Consejero: MIGUEL ANGEL CAMARA BOTIA. Presidente: MIGUEL ANGEL CAMARA BOTIA. Vicepresid.:CRISTOBAL HERRERO MARTINEZ. Consejero: CRISTOBAL HERRERO MARTINEZ;MARIA DOLORES MARTINEZ GUILLEN;JULIOJOSE LORENZO EGURCE. Nombramientos. Consejero: MIGUEL ANGEL CAMARA BOTIA;CRISTOBAL HERREROMARTINEZ;ANDREA JUDIT GARRIES MEDINA;ESTHER HERGUEDAS APARICIO;MARIA DOLORES ALARCON MARTINEZ.Presidente: MIGUEL ANGEL CAMARA BOTIA. Vicepresid.: CRISTOBAL HERRERO MARTINEZ. Reelecciones. Consejero:MELANIE GONZALEZ VIVERO. Datos registrales. T 2400 , F 43, S 8, H MU 18011, I/A 61 ( 9.02.12).

15 de Febrero de 2012
Reelecciones. Consejero: ANTONIO SANCHEZ CARRILLO. Datos registrales. T 978 , F 90, S 8, H MU 18011, I/A 37 (21.10.02).

02 de Junio de 2011
Nombramientos. Auditor: ABANTE AUDIEST AUDITORES SAP. Datos registrales. T 2400 , F 42, S 8, H MU 18011, I/A 60(24.05.11).

25 de Febrero de 2011
Fe de erratas: Al publicar la inscripcion 59 se consigno erroneamente la fecha de nombramiento de los cargos, siendo la correcta el28 de julio de 2010, habiendo sido designados por tres a帽os. Datos registrales. T 2400 , F 42, S 8, H MU 18011, I/A 59 (19.10.10).

28 de Octubre de 2010
Ceses/Dimisiones. Consejero: REMIGIO LOPEZ MARTINEZ. Reelecciones. Consejero: JOSE-ANTONIO DE RUEDA Y DERUEDA. Secretario: JOSE-ANTONIO DE RUEDA Y DE RUEDA. Consejero: APOLINAR GOMEZ MARTINEZ;CRISTOBAL HERREROMARTINEZ;MIGUEL ANGEL CAMARA BOTIA. Presidente: MIGUEL ANGEL CAMARA BOTIA. Vicepresid.: CRISTOBAL HERREROMARTINEZ. Consejero: GUILLERMO HERRAIZ ARTERO;M& CECILIA MILANES HERNANDEZ. Datos registrales. T 2400 , F 42, S8, H MU 18011, I/A 59 (19.10.10).

26 de Febrero de 2010
Ceses/Dimisiones. Consejero: MANUEL HERNANDEZ PAGAN;MARIA VAZQUEZ GONZALEZ. Nombramientos. Consejero:JULIO JOSE LORENZO EGURCE;FLORENCIO CASILLAS MARTIN. Datos registrales. T 2400 , F 42, S 8, H MU 18011, I/A 58(17.02.10).

20 de Marzo de 2009
Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 5.672,16 Euros. Resultante Suscrito: 4.422.103,20 Euros. Datos registrales. T 2400 , F41, S 8, H MU 18011, I/A 57 (11.03.09).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n