Actos BORME de Mesos Gestion Y Servicios Sl
11 de Abril de 2023Nombramientos. Apo.Sol.: LOPEZ SEISDEDOS ANA BELEN. Apo.Manc.: LOPEZ SEISDEDOS ANA BELEN. Datos registrales. T40854 , F 7, S 8, H M 454639, I/A 27 (31.03.23).
22 de Febrero de 2023Ceses/Dimisiones. VsecrNoConsj: CARRASCO BERNAL MARIA ELENA. Revocaciones. Apoderado: PRIETO GONZALEZDANIEL. Apo.Manc.: MONGE MU脩OZ MARIA-ISABEL. Apo.Sol.: MONGE MU脩OZ MARIA-ISABEL;ARANDILLA RUIZ PATRICIA.Apo.Manc.: ARANDILLA RUIZ PATRICIA. Apoderado: RODRIGUEZ NAJERA MIGUEL ANGEL. Nombramientos. VsecrNoConsj:CEBRIAN SEVILLA MARIA JOSE. Apo.Man.Soli: MARZAL GARCIA ARTURO. Apo.Manc.: ZARDOYA SERRANO SERGIO;VIALTORRES TERNERO LUIS. Apo.Man.Soli: DOMINGUEZ JARQUE AGUSTIN;MAYOR MORANCHEL EVA MARIA;RUIZ ESCRIBANOELENA MARIA;RUIZ ESCRIBANO ELENA MARIA. Datos registrales. T 40854 , F 4, S 8, H M 454639, I/A 26 (15.02.23).
16 de Febrero de 2022Revocaciones. Auditor: ADVANCE AUDIT SL. Nombramientos. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 40854 , F 4, S 8, H M454639, I/A 25 ( 9.02.22).
03 de Diciembre de 2021Nombramientos. Apoderado: MARZAL GARCIA ARTURO. Datos registrales. T 40854 , F 3, S 8, H M 454639, I/A 24 (26.11.21).
29 de Julio de 2021Revocaciones. Apo.Sol.: MARTINEZ DE GUINEA QUERENDEZ FERNANDO EUGENIO. Apo.Manc.: MARTINEZ DE GUINEAQUERENDEZ FERNANDO EUGENIO. Nombramientos. Vicepresid.: ZARDOYA SERRANO SERGIO. Datos registrales. T 40854 ,F 3, S 8, H M 454639, I/A 23 (22.07.21).
17 de Junio de 2021Ceses/Dimisiones. Consejero: MARTINEZ DE GUINEA QUERENDEZ FERNANDO EUGENIO. Vicepresid.: MARTINEZ DE GUINEAQUERENDEZ FERNANDO EUGENIO. Datos registrales. T 40854 , F 3, S 8, H M 454639, I/A 22 (10.06.21).
28 de Abril de 2021Nombramientos. Apoderado: RODRIGUEZ NAJERA MIGUEL ANGEL;VIAL TORRES TERNERO LUIS;ZARDOYA SERRANOSERGIO. Datos registrales. T 40854 , F 2, S 8, H M 454639, I/A 21 (21.04.21).
21 de Septiembre de 2020Declaraci贸n de unipersonalidad. Socio 煤nico: HOMESERVE ASISTENCIA SPAIN SA. Ceses/Dimisiones. Adm. Solid.: PADROESCODIN RAMON MANUEL;RODRIGUEZ NAJERA MIGUEL ANGEL. Nombramientos. Consejero: PRIETO GIBELLOFERNANDO;MARTINEZ DE GUINEA QUERENDEZ FERNANDO EUGENIO;VIAL TORRES-TERNERO LUIS;ZARDOYA SERRANOSERGIO. Presidente: PRIETO GIBELLO FERNANDO. Vicepresid.: MARTINEZ DE GUINEA QUERENDEZ FERNANDO EUGENIO.Con.Delegado: PRIETO GIBELLO FERNANDO. SecreNoConsj: CEREZO MIRANDA PALOMA ISABEL. VsecrNoConsj: CARRASCOBERNAL MARIA ELENA. Otros conceptos: Cambio del Organo de Administraci贸n: Administradores solidarios a Consejo deadministraci贸n. Datos registrales. T 33917 , F 160, S 8, H M 454639, I/A 19 (14.09.20).
Revocaciones. Apoderado: RODRIGUEZ MARIBONA DE AZCUNAGA ALVARO;RODRIGUEZ-MARIBONA DE AZCUNAGAALVARO;CENTENERA LOPEZ ADOLFO;VINOS CAHUE GORKA. Nombramientos. Apo.Manc.: PRIETO GIBELLO FERNANDO.Apo.Sol.: PRIETO GIBELLO FERNANDO;VIAL TORRES-TERNERO LUIS. Apo.Manc.: VIAL TORRES-TERNERO LUIS;ZARDOYASERRANO SERGIO. Apo.Sol.: ZARDOYA SERRANO SERGIO;MARTINEZ DE GUINEA QUERENDEZ FERNANDO EUGENIO.Apo.Manc.: MARTINEZ DE GUINEA QUERENDEZ FERNANDO EUGENIO;MONGE MU脩OZ MARIA-ISABEL. Apo.Sol.: MONGEMU脩OZ MARIA-ISABEL. Apo.Manc.: LOPEZ SEIDEDOS ANA BELEN. Apo.Sol.: LOPEZ SEIDEDOS ANA BELEN;ALVAREZ RUIZDIEGO. Apo.Manc.: ALVAREZ RUIZ DIEGO;RODRIGUEZ SAEZ SERGIO. Apo.Sol.: RODRIGUEZ SAEZ SERGIO;ARANDILLA RUIZPATRICIA. Apo.Manc.: ARANDILLA RUIZ PATRICIA;MARTINEZ OLEAGA LARA MARIA. Apo.Sol.: MARTINEZ OLEAGA LARAMARIA. Apo.Manc.: CEREZO MIRANDA PALOMA ISABEL. Apo.Sol.: CEREZO MIRANDA PALOMA ISABEL;MUGICA NICOLASIZASKUN. Apo.Manc.: MUGICA NICOLAS IZASKUN;OLEA APARICIO ALEJANDRA. Apo.Sol.: OLEA APARICIOALEJANDRA;SERRANO RICO VANESA. Apo.Manc.: SERRANO RICO VANESA;REINOSO SIMON GABRIEL. Apo.Sol.: REINOSOSIMON GABRIEL;HERMIDA JIMENEZ BEATRIZ-MARIA. Apo.Manc.: HERMIDA JIMENEZ BEATRIZ-MARIA;PRIMO ADAN TERESA.Apo.Sol.: PRIMO ADAN TERESA;BUENO FERRAN OLGA MARIA. Apo.Manc.: BUENO FERRAN OLGA MARIA;MEDINA BUENOSEBASTIAN MIGUEL. Apo.Sol.: MEDINA BUENO SEBASTIAN MIGUEL;VINIEGRA ESCANERO JOSE ENRIQUE. Apo.Manc.:VINIEGRA ESCANERO JOSE ENRIQUE. Datos registrales. T 33917 , F 162, S 8, H M 454639, I/A 20 (14.09.20).
24 de Diciembre de 2019Nombramientos. Auditor: ADVANCE AUDIT SL. Datos registrales. T 33917 , F 160, S 8, H M 454639, I/A 18 (17.12.19).
18 de Octubre de 2019Nombramientos. Apoderado: VINOS CAHUE GORKA. Datos registrales. T 33917 , F 159, S 8, H M 454639, I/A 17 (11.10.19).
13 de Febrero de 2018Nombramientos. Apoderado: CENTENERA LOPEZ ADOLFO. Datos registrales. T 33917 , F 159, S 8, H M 454639, I/A 16 (6.02.18).
29 de Junio de 2017Nombramientos. Auditor: ADVANCE AUDIT SL. Datos registrales. T 33917 , F 159, S 8, H M 454639, I/A 15 (22.06.17).
18 de Marzo de 2016Nombramientos. Apoderado: PRIETO GONZALEZ DANIEL. Datos registrales. T 33917 , F 158, S 8, H M 454639, I/A 13 (10.03.16).
Nombramientos. Apoderado: RODRIGUEZ-MARIBONA DE AZCUNAGA ALVARO. Datos registrales. T 33917 , F 158, S 8, H M454639, I/A 14 (10.03.16).
10 de Diciembre de 2015Fusi贸n por absorci贸n. Sociedades absorbidas: MESOS SOLUTIONS SL. MESOS SERVICES SL. MESOS MARKETING SL. Datosregistrales. T 33917 , F 155, S 8, H M 454639, I/A 12 ( 2.12.15).
06 de Noviembre de 2015Modificaciones estatutarias. MODIFICACION PARCIAL DE LOS ESTATUTOS SOCIALES.-. Datos registrales. T 25251 , F 112, S8, H M 454639, I/A 11 (28.10.15).
11 de Diciembre de 2013Nombramientos. Apoderado: RODRIGUEZ MARIBONA DE AZCUNAGA ALVARO. Datos registrales. T 25251 , F 112, S 8, H M454639, I/A 10 ( 2.12.13).
14 de Junio de 2013Ampliaci贸n de capital. Capital: 58.530,00 Euros. Resultante Suscrito: 161.410,00 Euros. Datos registrales. T 25251 , F 111, S 8, HM 454639, I/A 9 ( 4.06.13).
11 de Junio de 2013Ampliaci贸n de capital. Capital: 27.680,00 Euros. Resultante Suscrito: 102.880,00 Euros. Datos registrales. T 25251 , F 110, S 8, HM 454639, I/A 8 ( 4.06.13).
16 de Mayo de 2013Ceses/Dimisiones. Adm. Solid.: VINOS CAHUE GORKA. Nombramientos. Adm. Solid.: RODRIGUEZ NAJERA MIGUEL ANGEL.Datos registrales. T 25251 , F 110, S 8, H M 454639, I/A 7 ( 8.05.13).
23 de Agosto de 2011Ampliaci贸n de capital. Capital: 22.837,00 Euros. Resultante Suscrito: 75.200,00 Euros. Cambio de domicilio social. AVDA DE LAINDUSTRIA 18 (COSLADA). Datos registrales. T 25251 , F 108, S 8, H M 454639, I/A 6 (11.08.11).
10 de Septiembre de 2009Ampliaci贸n de capital. Capital: 5.236,00 Euros. Resultante Suscrito: 52.363,00 Euros. Datos registrales. T 25251 , F 108, S 8, H M454639, I/A 5 (20.08.09).
21 de Agosto de 2009Ceses/Dimisiones. Adm. Solid.: HORNOS BUESO JOSE LUIS;ARRIBAS MO脩IVAS ANTONIO. Modificaciones estatutarias. 12.Ejercicio y duraci贸n del cargo.. Cambio de domicilio social. AVDA DE LA INDUSTRIA 21 - NAVE 10 POSTERIOR. POLI(FUENLABRADA). Datos registrales. T 25251 , F 107, S 8, H M 454639, I/A 4 (11.08.09).
22 de Julio de 2009Ampliaci贸n de capital. Capital: 40.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 43.200,00 Euros. Datos registrales. T 25251 , F 107, S 8, HM 454639, I/A 2 (10.07.09).
Ampliaci贸n de capital. Capital: 3.927,00 Euros. Resultante Suscrito: 47.127,00 Euros. Datos registrales. T 25251 , F 107, S 8, H M454639, I/A 3 (10.07.09).