Buscador CIF Logo

Actos BORME Metalpanel Sa

驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Metalpanel Sa

Actos BORME Metalpanel Sa - A16182305

Tenemos registrados 18 Actos BORME del Registro Mercantil de Toledo para Metalpanel Sa con CIF A16182305

馃敊 Perfil de Metalpanel Sa
馃洅 Comprar listado completo de Empresas de Toledo

Actos BORME de Metalpanel Sa

14 de Noviembre de 2023
Nombramientos. Auditor: EUDITA CUSPIDE AUDITORES SL. Datos registrales. T 1698 , F 180, S 8, H TO 33094, I/A 15 (7.11.23).

14 de Enero de 2021
Nombramientos. Auditor: EUDITA CUSPIDE AUDITORES SL. Datos registrales. T 1698 , F 180, S 8, H TO 33094, I/A 14 (7.01.21).

12 de Febrero de 2020
Nombramientos. Apo.Sol.: RODRIGO LOPEZ LUIS-ALBERTO. Apo.Manc.: RODRIGO LOPEZ LUIS-ALBERTO. Datos registrales.T 1529 , F 42, S 8, H TO 33094, I/A 13 ( 5.02.20).

18 de Junio de 2019
Reelecciones. Consejero: MORALES GONZALEZ ANGEL;CANDEL JIMENEZ RAFAEL;MORALES RUIZ MARTINALBERTO;CANDEL JIMENEZ PEDRO. Presidente: MORALES GONZALEZ ANGEL. Secretario: CANDEL JIMENEZ RAFAEL.Cons.Del.Sol: MORALES GONZALEZ ANGEL;CANDEL JIMENEZ RAFAEL. Datos registrales. T 1529 , F 42, S 8, H TO 33094, I/A12 (10.06.19).

23 de Noviembre de 2017
Reelecciones. Auditor: EUDITA CUSPIDE AUDITORES SL. Datos registrales. T 1529 , F 42, S 8, H TO 33094, I/A 11 (16.11.17).

17 de Abril de 2017
Nombramientos. Apo.Man.Soli: MORALES RUIZ MARTIN ALBERTO;NAVARRO CARRILLO ADRIAN;MONTOYA ZARCO JOSEMANUEL. Datos registrales. T 1529 , F 41, S 8, H TO 33094, I/A 9 ( 6.04.17).

02 de Noviembre de 2016
Ampliaci贸n de capital. Suscrito: 58.898,98 Euros. Desembolsado: 58.898,98 Euros. Resultante Suscrito: 3.376.474,18 Euros.Resultante Desembolsado: 3.376.474,18 Euros. Datos registrales. T 1529 , F 41, S 8, H TO 33094, I/A 8 (20.10.16).

21 de Noviembre de 2014
Nombramientos. Auditor: EUDITA CUSPIDE AUDITORES SL. Datos registrales. T 1529 , F 41, S 8, H TO 33094, I/A 7 (13.11.14).

29 de Julio de 2014
Ceses/Dimisiones. Consejero: CANDEL NAVARRO RAFAEL;GONZALEZ MUJERIEGO ISIDORA;MORALES GONZALEZANGEL;CANDEL JIMENEZ PEDRO;RUIZ SANCHEZ MARIA ANGELES;MORALES RUIZ MARTIN ALBERTO;CANDEL MOLINAFRANCISCO. Presidente: MORALES GONZALEZ ANGEL. Cons.Del.Sol: MORALES GONZALEZ ANGEL. Vicepresid.: CANDELJIMENEZ PEDRO. Consejero: CANDEL JIMENEZ RAFAEL. Secretario: CANDEL JIMENEZ RAFAEL. Cons.Del.Sol: CANDELJIMENEZ RAFAEL. Nombramientos. Consejero: MORALES GONZALEZ ANGEL;CANDEL JIMENEZ PEDRO;MORALES RUIZMARTIN ALBERTO. Presidente: MORALES GONZALEZ ANGEL. Consejero: CANDEL JIMENEZ RAFAEL. Secretario: CANDELJIMENEZ RAFAEL. Cons.Del.Sol: CANDEL JIMENEZ RAFAEL;MORALES GONZALEZ ANGEL. Datos registrales. T 1529 , F 41, S8, H TO 33094, I/A 6 (21.07.14).

15 de Noviembre de 2013
Otros conceptos: Hecho constar el cambio de denominaci贸n social del auditor de cuentas la sociedad "CUSPIDE AUDITORES SL"que pasa a denominarse "EUDITA CUSPIDE AUDITORES SL". Datos registrales. T 1529 , F 40, S 8, H TO 33094, I/AMargi (7.11.13).

13 de Mayo de 2013
Declaraci贸n de unipersonalidad. Socio 煤nico: HIERROS Y TRANSFORMADOS SA. Datos registrales. T 1529 , F 40, S 8, H TO33094, I/A 5 ( 6.05.13).

11 de Abril de 2013
Ceses/Dimisiones. Consejero: MORALES GONZALEZ MARIA CONCEPCION. Nombramientos. Consejero: GONZALEZMUJERIEGO ISIDORA. Datos registrales. T 1529 , F 40, S 8, H TO 33094, I/A 4 ( 2.04.13).

21 de Noviembre de 2011
Reelecciones. Auditor: CUSPIDE AUDITORES SL. Datos registrales. T 1529 , F 40, S 8, H TO 33094, I/A 3 (10.11.11).

23 de Septiembre de 2011
Cambio de domicilio social. CMNO DE LA MESA ORTIZ S/N - POLIGONO INDUSTRIAL AL (QUINTANAR DE LA ORDEN). Datosregistrales. T 1529 , F 41, S 8, H TO 33094, I/A 2 (12.09.11).

21 de Junio de 2011
Ampliaci贸n de capital. Suscrito: 48.080,80 Euros. Desembolsado: 48.080,80 Euros. Resultante Suscrito: 3.317.575,20 Euros.Resultante Desembolsado: 3.317.575,20 Euros. Datos registrales. T 592 , F 214, S 8, H CU 3433, I/A 16 (25.05.11).

28 de Febrero de 2011
Nombramientos. Cons.Del.Sol: CANDEL JIMENEZ RAFAEL;MORALES GONZALEZ ANGEL. Datos registrales. T 527 , F 128, S 8,H CU 3433, I/A 15 ( 4.01.11).

24 de Enero de 2011
Ceses/Dimisiones. Consejero: CANDEL JIMENEZ RAFAEL. Secretario: CANDEL JIMENEZ RAFAEL. Cons.Del.Sol: CANDELJIMENEZ RAFAEL. Presidente: MORALES GONZALEZ ANGEL. Cons.Del.Sol: MORALES GONZALEZ ANGEL. Consejero:MORALES GONZALEZ ANGEL;NAVARRO CEBRIAN MARIA BELEN. Nombramientos. Consejero: MORALES GONZALEZANGEL;MORALES GONZALEZ MARIA CONCEPCION;RUIZ SANCHEZ MARIA ANGELES;CANDEL JIMENEZ PEDRO;CANDELJIMENEZ RAFAEL;CANDEL MOLINA FRANCISCO;CANDEL NAVARRO RAFAEL;MORALES RUIZ MARTIN ALBERTO. Presidente:MORALES GONZALEZ ANGEL. Vicepresid.: CANDEL JIMENEZ PEDRO. Secretario: CANDEL JIMENEZ RAFAEL. Otrosconceptos: Modificaci贸n del art铆culo 27潞 de los Estatutos Sociales. Datos registrales. T 527 , F 128, S 8, H CU 3433, I/A 15 (4.01.11).

02 de Febrero de 2009
Nombramientos. Auditor: CUSPIDE AUDITORES SL. Datos registrales. T 527 , F 127, S 8, H CU 3433, I/A 14 (20.01.09).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n