Actos BORME de Meteora Energy Sl
11 de Diciembre de 2019Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: RIJN CAPITAL BV. Representan: DE BOER MEINDERT. Revocaciones. Apoderado: CANALEJOLASARTE GUILLERMO;DEL PINO Y CALVO SOTELO RAFAEL;CANALEJO LASARTE GUILLERMO. Apo.Sol.: SCHMOLLERTAMARA;LAORDEN BAEZA MARTA;DEL CASTILLO GOLDING JORGE. Apoderado: MEDRANO MARTINEZ ROBERTO.Nombramientos. Liquidador: RIJN CAPITAL BV. Representan: DE BOER MEINDERT. Disoluci贸n. Voluntaria. Extinci贸n. Datosregistrales. T 31585 , F 64, S 8, H M 524104, I/A 19 (29.11.19).
15 de Octubre de 2019Ceses/Dimisiones. Adm. Mancom.: LAORDEN BAEZA MARTA;RIJN CAPITAL BV. Representan: DE BOER MEINDERT.Nombramientos. Adm. Unico: RIJN CAPITAL BV. Representan: DE BOER MEINDERT. Apoderado: MEDRANO MARTINEZROBERTO. Otros conceptos: Cambio del Organo de Administraci贸n: Administradores mancomunados a Administrador 煤nico.Datos registrales. T 31585 , F 63, S 8, H M 524104, I/A 18 ( 8.10.19).
12 de Junio de 2018Cambio de domicilio social. C/ NU脩EZ DE BALBOA 33 1潞 B (MADRID). Datos registrales. T 31585 , F 62, S 8, H M 524104, I/A 17( 5.06.18).
11 de Mayo de 2018Revocaciones. Apoderado: CUESTA CABOT GERARDO;RAMALLO MONTIS ALONSO;DAVALOS OLIVARES MARTINFEDERICO;CUESTA CABOT GERARDO;RAMALLO MONTIS ALONSO;ALVAREZ-MENDIZABAL TURMO RAFAEL.Nombramientos. Apo.Sol.: SCHMOLLER TAMARA;LAORDEN BAEZA MARTA;DEL CASTILLO GOLDING JORGE. Datosregistrales. T 31585 , F 61, S 8, H M 524104, I/A 16 ( 4.05.18).
10 de Mayo de 2018Ceses/Dimisiones. Consejero: DAVALOS OLIVARES MARTIN FEDERICO;LAORDEN BAEZA MARTA;RIJN CAPITAL BV.Presidente: DAVALOS OLIVARES MARTIN FEDERICO. Secretario: LAORDEN BAEZA MARTA. Representan: DE BOER MEINDERT.Nombramientos. Adm. Mancom.: LAORDEN BAEZA MARTA;RIJN CAPITAL BV. Representan: DE BOER MEINDERT.Modificaciones estatutarias. Modificacion del art铆culo 14 de los Estatutos Sociales relativo a la estructura del organo deadministracion . Otros conceptos: Cambio del Organo de Administraci贸n: Consejo de administraci贸n a Administradoresmancomunados. Datos registrales. T 31585 , F 60, S 8, H M 524104, I/A 15 ( 3.05.18).
23 de Julio de 2014Cambio de domicilio social. C/ MIGUEL ANGEL 23 1 - IZQDA, LOCAL A (MADRID). Datos registrales. T 31585 , F 60, S 8, H M524104, I/A 14 (14.07.14).
07 de Noviembre de 2013Ampliaci贸n de capital. Capital: 80.800,00 Euros. Resultante Suscrito: 100.000,00 Euros. Modificaciones estatutarias. Art铆culo delos estatutos: 6. Capital.-Ampliaci贸n de capital social en 80.800 euros con prima de emisi贸n por un total de 991.809,17 euros. . Datosregistrales. T 29108 , F 174, S 8, H M 524104, I/A 13 (29.10.13).
20 de Marzo de 2013Ceses/Dimisiones. Representan: DE BOER MEINDERT. Adm. Mancom.: DEL PINO Y CALVO SOTELO RAFAEL;RIJN CAPITAL BV.Nombramientos. Representan: DE BOER MEINDERT. Consejero: DAVALOS OLIVARES MARTIN FEDERICO;LAORDEN BAEZAMARTA;RIJN CAPITAL BV. Presidente: DAVALOS OLIVARES MARTIN FEDERICO. Secretario: LAORDEN BAEZA MARTA.Modificaciones estatutarias. Cambio del Organo de Administraci贸n: Administradores mancomunados a Consejo de administraci贸n.Datos registrales. T 29108 , F 174, S 8, H M 524104, I/A 12 (12.03.13).
23 de Enero de 2013Nombramientos. Apoderado: CANALEJO LASARTE GUILLERMO;CUESTA CABOT GERARDO;RAMALLO MONTISALONSO;ALVAREZ-MENDIZABAL TURMO RAFAEL. Datos registrales. T 29108 , F 173, S 8, H M 524104, I/A 11 (15.01.13).
20 de Noviembre de 2012Otros conceptos: NOTIFICACION DEL CAMBIO DE DENOMINACION SOCIAL DEL ADMINISTRADOR MANCOMUNADO DE LASOCIEDAD, QUE HA PASADO DE DENOMINARSE "POLAR CAPITAL BV", A DENOMINARSE "RIJN CAPITAL BV". Datosregistrales. T 29108 , F 173, S 8, H M 524104, I/A 10 ( 7.11.12).