Actos BORME de Metromatic Sa
05 de Diciembre de 2013Ceses/Dimisiones. Adm. Solid.: SAGI VALLMITJANA VICTOR;SAGI MONTPLET VICTOR. Nombramientos. Liquidador: SAGIMONTPLET VICTOR. Disoluci贸n. Voluntaria. Extinci贸n. Datos registrales. T 9687 , F 77, S 8, H M 48775, I/A 38 (27.11.13).
12 de Junio de 2012Cambio de domicilio social. C/ INFANTA MERCEDES 96 - 6潞 J (MADRID). Datos registrales. T 9687 , F 77, S 8, H M 48775, I/A37 (31.05.12).
12 de Marzo de 2012Ceses/Dimisiones. Consejero: SAGI VALLMITJANA VICTOR. Presidente: SAGI VALLMITJANA VICTOR. Consejero: BUCH SERRAJOSEP. Secretario: BUCH SERRA JOSEP. Consejero: KAPLAN OLIVIER;UNGER GERARD. Con.Delegado: SAGI VALLMITJANAVICTOR. Nombramientos. Adm. Solid.: SAGI VALLMITJANA VICTOR;SAGI MONTPLET VICTOR. Reducci贸n de capital. Importereducci贸n: 60.200,00 Euros. Resultante Suscrito: 0,00 Euros. Ampliaci贸n de capital. Suscrito: 150.000,00 Euros. Desembolsado:150.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 150.000,00 Euros. Resultante Desembolsado: 150.000,00 Euros. Modificacionesestatutarias. Art铆culo de los estatutos: 7. Capital.-. Art铆culo de los estatutos: 7. Capital.-. Art铆culo de los estatutos: 2. Objeto.-.Cambiodel Organo de Administraci贸n: Consejo de administraci贸n a Administradores solidarios. Otros conceptos: NUEVA REDACCION DELOS ESTATUTOS SOCIALES. Ampliacion del objeto social. LA COMPRA- VENTA, ALQUILER, INSTALACION Y EXPLOTACIONDE TODA CLASE DE TIPOS DE MAQUINAS AUTOMATICAS, EXPENDEDORAS DE ARTICULOS DE USO O CONSUMO,ASICOMO LA COMPRA-VENTA, ARRENDAMIENTO Y SUBARRENDAMIENTO DE INMUEBLES. EXCEPTO EL ARRENDAMIENTOFINANCIERO. Cambio de domicilio social. C/ CALLE INFANTA MERCEDES 107, 1潞 A (MADRID). Datos registrales. T 9687 , F75, S 8, H M 48775, I/A 36 (29.02.12).
18 de Enero de 2012Nombramientos. Auditor: AUDALIA AUDITORES SL. Datos registrales. T 9687 , F 75, S 8, H M 48775, I/A 35 ( 9.01.12).
03 de Enero de 2011Revocaciones. Apoderado: MARTINEZ MORILLA LUIS FERNANDO. Datos registrales. T 9687 , F 74, S 8, H M 48775, I/A 34(21.12.10).
26 de Noviembre de 2010Revocaciones. Apoderado: MARTIN PLAZA LUCAS. Datos registrales. T 9687 , F 74, S 8, H M 48775, I/A 33 (16.11.10).
08 de Noviembre de 2010Nombramientos. Apoderado: BUCH SERRA JOSEP. Datos registrales. T 9687 , F 73, S 8, H M 48775, I/A 32 (27.10.10).
30 de Septiembre de 2009Nombramientos. Apoderado: MARTIN PLAZA LUCAS. Datos registrales. T 9687 , F 73, S 8, H M 48775, I/A 30 (16.09.09).
Otros conceptos: REVOCADO EL PODER CONFERIDO A FAVOR DE DON JULIO RUIZ CATALAN, MEDIANTE ESCRITURA QUEORIGINO LA INSCRIPCION 16& DE LA HOJA SOCIAL. Datos registrales. T 9687 , F 73, S 8, H M 48775, I/A 31 (16.09.09).
06 de Agosto de 2009Ceses/Dimisiones. Consejero: SAGI VALLMITJANA VICTOR. Presidente: SAGI VALLMITJANA VICTOR. Consejero: BUCH SERRAJOSEP. Secretario: BUCH SERRA JOSEP. Con.Delegado: SAGI VALLMITJANA VICTOR. Consejero: KAPLAN OLIVIER;UNGERGERARD. Nombramientos. Consejero: SAGI VALLMITJANA VICTOR. Presidente: SAGI VALLMITJANA VICTOR. Consejero: BUCHSERRA JOSEP. Secretario: BUCH SERRA JOSEP. Consejero: KAPLAN OLIVIER;UNGER GERARD. Con.Delegado: SAGIVALLMITJANA VICTOR. Datos registrales. T 9687 , F 72, S 8, H M 48775, I/A 29 (27.07.09).