Actos BORME de Mexi Foods Sl
11 de Febrero de 2021Disoluci贸n. Fusion. Extinci贸n. Datos registrales. T 35785 , F 8, S 8, H M 20649, I/A 29 ( 4.02.21).
15 de Diciembre de 2020Otros conceptos: Queda CERRADA LA HOJA de la sociedad por un plazo de SEIS MESES al haber sido absorbida la sociedad aque la misma se refiere, por la denominada "MISSION FOODS IBERIA, S.A.U.", domiciliada en Toledo. Datos registrales. T 35785 , F6, S 8, H M 20649, I/A 28M ( 4.12.20).
31 de Agosto de 2020Revocaciones. Apo.Man.Soli: RICO FEIJOO MARIA LUISA. Nombramientos. Apoderado: DIEZ ESTEBAN TERESA. Datosregistrales. T 35785 , F 6, S 8, H M 20649, I/A 28 (24.08.20).
28 de Julio de 2020Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 35785 , F 6, S 8, H M 20649, I/A 27(21.07.20).
27 de Julio de 2020Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 35785 , F 5, S 8, H M 20649, I/A 25(20.07.20).
Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 35785 , F 6, S 8, H M 20649, I/A 26(20.07.20).
02 de Septiembre de 2019Revocaciones. Apo.Man.Soli: BURGUILLO HERNANDEZ OLGA. Datos registrales. T 35785 , F 5, S 8, H M 20649, I/A 24(26.08.19).
24 de Abril de 2019Revocaciones. Apo.Sol.: ELIZONDO RIOS GUILLERMO;SALINAS CENICEROS BARBARA ALEJANDRA. Datos registrales. T35785 , F 5, S 8, H M 20649, I/A 23 (15.04.19).
09 de Abril de 2019Nombramientos. Apo.Sol.: MALDONADO PEREZ RODOLFO ENRIQUE;SOLIS PEREZ ALEJANDRO. Datos registrales. T 35785 ,F 5, S 8, H M 20649, I/A 22 ( 2.04.19).
03 de Abril de 2019Ceses/Dimisiones. SecreNoConsj: ASHMAN AMY LUCY. Revocaciones. Apo.Man.Soli: VARGAS GUAJARDO SALVADOR.Nombramientos. SecreNoConsj: MARTINEZ VILLARREAL RODRIGO. VsecrNoConsj: ASHMAN AMY LUCY. Datos registrales. T35785 , F 4, S 8, H M 20649, I/A 21 (27.03.19).
21 de Junio de 2018Revocaciones. Apo.Man.Soli: NOVOKHATNII ANTON. Nombramientos. Apoderado: MARTINEZ HERNANDEZ ANDREA DELVALLE;BATYR ANASTASIIA. Datos registrales. T 35785 , F 2, S 8, H M 20649, I/A 20 (13.06.18).
06 de Marzo de 2018Nombramientos. Apo.Sol.: ELIZONDO RIOS GUILLERMO;SALINAS CENICEROS BARBARA ALEJANDRA. Datos registrales. T35785 , F 1, S 8, H M 20649, I/A 19 (23.02.18).
29 de Marzo de 2017Revocaciones. Apo.Man.Soli: ALMUDI MARTIN IMANOL. Nombramientos. Apo.Man.Soli: RIVERA VEGA MIGUEL ANGEL. Datosregistrales. T 13128 , F 159, S 8, H M 20649, I/A 18 (22.03.17).
20 de Mayo de 2016Revocaciones. Apoderado: MALDONADO PEREZ RODOLFO ENRIQUE;SOLIS PEREZ ALEJANDRO;ALONSO CEMBRANO JOSEIGNACIO;GARCIA GARCIA ANA BELEN;NOVOKHATNII ANTON. Nombramientos. Apo.Man.Soli: GONZALEZ MORENO JUAN-ANTONIO;VARGAS GUAJARDO SALVADOR;MALDONADO PEREZ RODOLFO ENRIQUE;SOLIS PEREZ ALEJANDRO;ALMUDIMARTIN IMANOL;GARCIA GARCIA ANA BELEN;NOVOKHATNII ANTON;BURGUILLO HERNANDEZ OLGA;DEMANDTLEONARDUS WITHELMUS ELISABETH;ASHMAN AMY LUCY;RICO FEIJOO MARIA LUISA;SAEED MOHAMMED. Datosregistrales. T 13128 , F 157, S 8, H M 20649, I/A 17 (12.05.16).
17 de Mayo de 2016Ceses/Dimisiones. SecreNoConsj: BALA脩A DE EGUIA JOSE MARIA. Nombramientos. SecreNoConsj: ASHMAN AMY LUCY.Datos registrales. T 13128 , F 157, S 8, H M 20649, I/A 16 ( 9.05.16).
01 de Julio de 2015Nombramientos. Apoderado: GARCIA GARCIA ANA BELEN;NOVOKHATNII ANTON. Datos registrales. T 13128 , F 156, S 8, H M20649, I/A 15 (19.06.15).
29 de Abril de 2015Declaraci贸n de unipersonalidad. Socio 煤nico: GRUMA INTERNATIONAL FOODS SL. Modificaciones estatutarias. SE DEROGAEL ARTICULO 8 BIS DE LOS ESTATUTOS SOCIALES Y SE MODIFICA EL ARTICULO 10 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES . Datosregistrales. T 13128 , F 155, S 8, H M 20649, I/A 14 (21.04.15).
19 de Febrero de 2015Nombramientos. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 13128 , F 155, S 8, H M 20649,I/A 13 (12.02.15).
12 de Junio de 2014Ceses/Dimisiones. Presidente: ALONSO CEMBRANO JOSE IGNACIO. Vicepresid.: BANUS GUTIERREZ GONZALO. Consejero:BANUS GUTIERREZ GONZALO;ALONSO CEMBRANO JOSE IGNACIO;GARCIA QUIROS GARCIA FELIPESecretario: GARCIAQUIROS GARCIA FELIPE. Cons.Del.Sol: GARCIA QUIROS GARCIA FELIPE;BANUS GUTIERREZ GONZALO;ALONSO CEMBRANOJOSE IGNACIO Nombramientos. Consejero: MALDONADO PEREZ RODOLFO ENRIQUE;SOLIS PEREZ ALEJANDRO;BURKEDANNIE LEE JR. Presidente: MALDONADO PEREZ RODOLFO ENRIQUE. SecreNoConsj: BALA脩A DE EGUIA JOSE MARIA.Modificaciones estatutarias. Refundici贸n de Estatutos sociales . Datos registrales. T 13128 , F 150, S 8, H M 20649, I/A 11(29.05.14).
Revocaciones. Apoderado: BANUS GUTIERREZ GONZALO;ALONSO CEMBRANO JOSE IGNACIO;GARCIA QUIROS GARCIAFELIPE Nombramientos. Apoderado: MALDONADO PEREZ RODOLFO ENRIQUE;SOLIS PEREZ ALEJANDRO;ALONSOCEMBRANO JOSE IGNACIO. Datos registrales. T 13128 , F 154, S 8, H M 20649, I/A 12 (29.05.14).
22 de Mayo de 2014Ceses/Dimisiones. Consejero: DOLLS ABELLAN PEDRO. Datos registrales. T 13128 , F 150, S 8, H M 20649, I/A 10 ( 8.05.14).
04 de Julio de 2011Nombramientos. Auditor: INTEGRACION DE TECNICAS DE GESTION AUDITORES SLP. Datos registrales. T 13128 , F 149, S 8,H M 20649, I/A 9 (20.06.11).