Actos BORME de Mexico Media Investments Sl
19 de Enero de 2016Ceses/Dimisiones. Consejero: MARTINEZ DAVID;IBA脩EZ ALVAREZ MARIANO;DIRETORA CORPORATE SERVICES SA.Presidente: MARTINEZ DAVID. Consejero: GARCIA GASSULL ROVIRA GERARD;LOSADA ENRIQUEZ VICTOR JAVIER;SANCHEZSARMIENTO SEBASTIAN. Vicepresid.: SANCHEZ SARMIENTO SEBASTIAN. SecreNoConsj: COSTAS FERRE MARIAMONTSERRAT. Nombramientos. Liquidador: SANCHEZ SARMIENTO SEBASTIAN. Disoluci贸n. Voluntaria. Extinci贸n. Datosregistrales. T 27362 , F 218, S 8, H M 493096, I/A 20 (11.01.16).
27 de Noviembre de 2015Nombramientos. Apoderado: GARCIA GASSULL ROVIRA GERARD;COSTAS FERRE MARIA MONTSERRAT. Datos registrales. T27362 , F 218, S 8, H M 493096, I/A 19 (20.11.15).
20 de Noviembre de 2012Ceses/Dimisiones. Consejero: HERRERA JULIO. Vicepresid.: HERRERA JULIO. Nombramientos. Consejero: SANCHEZSARMIENTO SEBASTIAN. Vicepresid.: SANCHEZ SARMIENTO SEBASTIAN. Datos registrales. T 27362 , F 217, S 8, H M 493096,I/A 17 ( 8.11.12).
Revocaciones. Apoderado: HERRERA JULIO;HERRERA JULIO;MARTINEZ DAVID;HERRERA JULIO. Nombramientos.Apoderado: SANCHEZ SARMIENTO SEBASTIAN. Datos registrales. T 27362 , F 217, S 8, H M 493096, I/A 18 ( 8.11.12).
14 de Diciembre de 2011Ceses/Dimisiones. SecreNoConsj: BATET SERRA NURIA. Nombramientos. SecreNoConsj: COSTAS FERRE MARIAMONTSERRAT. Datos registrales. T 27362 , F 216, S 8, H M 493096, I/A 16 (30.11.11).
25 de Abril de 2011Cambio de domicilio social. C/ FERNANDO EL SANTO 27 - LOCAL 4潞 A. (MADRID). Datos registrales. T 27362 , F 216, S 8, H M493096, I/A 15 ( 8.04.11).
04 de Agosto de 2010Ampliaci贸n de capital. Capital: 996.988,00 Euros. Resultante Suscrito: 1.000.000,00 Euros. Datos registrales. T 27362 , F 215, S 8,H M 493096, I/A 14 (26.07.10).
22 de Julio de 2010Ceses/Dimisiones. Secretario: MARTIN DE VIDALES GODINO MONICA. VsecrNoConsj: MARTINEZ-CABALLERO GOVANTESFELIPE. Nombramientos. SecreNoConsj: BATET SERRA NURIA. Datos registrales. T 27362 , F 149, S 8, H M 493096, I/A 10(12.07.10).
Nombramientos. Consejero: GARCIA GASSULL ROVIRA GERARD;LOSADA ENRIQUEZ VICTOR JAVIER. Modificacionesestatutarias. SE MODIFICAN LOS ARTICULOS 17潞 Y 18潞 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES.. Datos registrales. T 27362 , F 150, S8, H M 493096, I/A 11 (12.07.10).
Nombramientos. Apo.Man.Soli: BAROT ARQUED SANTIAGO. Apo.Manc.: DIRETORA CORPORATE SERVICES SA. Datosregistrales. T 27362 , F 150, S 8, H M 493096, I/A 12 (12.07.10).
Revocaciones. Apoderado: PEREZ-HERNANDEZ DURAN MARIA;GOMEZ OLMEDO FRANCISCO. Nombramientos. Apoderado:GARCIA GASSULL ROVIRA GERARD;LOSADA ENRIQUEZ VICTOR JAVIER. Datos registrales. T 27362 , F 215, S 8, H M 493096,I/A 13 (12.07.10).
27 de Mayo de 2010Cambio de domicilio social. C/ VILLANUEVA 12 - BAJO B (MADRID). Datos registrales. T 27362 , F 149, S 8, H M 493096, I/A 9(18.05.10).
18 de Marzo de 2010Nombramientos. Apoderado: DIRETORA CORPORATE SERVICES SA. Datos registrales. T 27362 , F 148, S 8, H M 493096, I/A 7( 8.03.10).
Nombramientos. Apoderado: DIRETORA CORPORATE SERVICES SA. Datos registrales. T 27362 , F 148, S 8, H M 493096, I/A 8( 8.03.10).
08 de Marzo de 2010Nombramientos. Apoderado: MARTINEZ DAVID;HERRERA JULIO. Datos registrales. T 27362 , F 148, S 8, H M 493096, I/A 5(24.02.10).
Nombramientos. Apoderado: PEREZ-HERNANDEZ DURAN MARIA;GOMEZ OLMEDO FRANCISCO. Datos registrales. T 27362 ,F 148, S 8, H M 493096, I/A 6 (24.02.10).
01 de Marzo de 2010Nombramientos. Apoderado: MARTINEZ DAVID;HERRERA JULIO. Datos registrales. T 27362 , F 147, S 8, H M 493096, I/A 3(17.02.10).
Nombramientos. Apoderado: MARTINEZ DAVID;HERRERA JULIO;IBA脩EZ ALVAREZ MARIANO;GLENNIE QUIROS FRANCISCOJOSE;VELEZ VARELA ROSA LILIA. Datos registrales. T 27362 , F 147, S 8, H M 493096, I/A 4 (18.02.10).