Actos BORME de Michizara Sl
31 de Enero de 2020Situaci贸n concursal. Procedimiento concursal 2311/2019. FIRME: No, Fecha de resoluci贸n 9/01/2020. Auto de declaraci贸n deconcurso. Voluntario. Juzgado: num. 0 JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 7 DE MADRID. Juez: DON JUAN CARLOS PICAZOMENENDEZ. Datos registrales. T 36269 , F 204, S 8, H M 651637, I/A A (24.01.20).
29 de Enero de 2020Ceses/Dimisiones. Consejero: VALDECANTOS JIMENEZ DE ANDRADE PEDRO;GONZALEZ DE BETOLAZA GARCIA ROBERTORAMON. Presidente: GONZALEZ DE BETOLAZA GARCIA ROBERTO RAMON. Consejero: DE LA INFIESTA ROLLAN JOSEMANUEL. Nombramientos. Adm. Solid.: GONZALEZ DE BETOLAZA GARCIA ROBERTO RAMON;DE LA INFIESTA ROLLAN JOSEMANUEL. Otros conceptos: Cambio del Organo de Administraci贸n: Consejo de administraci贸n a Administradores solidarios. Datosregistrales. T 36269 , F 204, S 8, H M 651637, I/A 16 (22.01.20).
22 de Noviembre de 2019Ceses/Dimisiones. VsecrNoConsj: SESMA LOPEZ DOLORES. SecreNoConsj: BLASCO FILLOL SERGIO. Nombramientos.SecreNoConsj: FERNANDEZ DE ARAOZ GOMEZ-ACEBO ALEJANDRO. VsecrNoConsj: NIETO GARCIA MARIA. Datos registrales.T 36269 , F 203, S 8, H M 651637, I/A 15 (15.11.19).
07 de Junio de 2019Ceses/Dimisiones. Consejero: RUBIDO RAMONDE BENITO DAMIAN;GISPERT DE CHIA NURIA;DOMINGO RAMIREZ JUAN-JESUS;DE TORO DE ASTOBIZA GABRIEL. Datos registrales. T 36269 , F 203, S 8, H M 651637, I/A 14 (31.05.19).
05 de Diciembre de 2018Nombramientos. Consejero: DOMINGO RAMIREZ JUAN-JESUS;DE TORO DE ASTOBIZA GABRIEL. Datos registrales. T 36269 ,F 59, S 8, H M 651637, I/A 12 (26.11.18).
Nombramientos. Apoderado: VALDECANTOS JIMENEZ DE ANDRADE PEDRO. Datos registrales. T 36269 , F 203, S 8, H M651637, I/A 13 (28.11.18).
22 de Octubre de 2018Ceses/Dimisiones. Presidente: FONCILLAS GARCIA DE LA MATA IGNACIO MARIA. Consejero: FONCILLAS GARCIA DE LA MATAIGNACIO;PEREZ DE HERRASTI PELLON JOSE MARIA. Nombramientos. Consejero: DE LA INFIESTA ROLLAN JOSEMANUEL;GISPERT DE CHIA NURIA. Ampliaci贸n de capital. Capital: 2.608.592,00 Euros. Resultante Suscrito: 2.611.592,00 Euros.Ampliaci贸n de capital. Capital: 2.388.408,00 Euros. Resultante Suscrito: 5.000.000,00 Euros. Datos registrales. T 36269 , F 56, S8, H M 651637, I/A 10 (11.10.18).
Revocaciones. Apoderado: VALDECANTOS JIMENEZ DE ANDRADE PEDRO;FONCILLAS GARCIA DE LA MATA IGNACIOMARIA;RUBIDO RAMONDE BENITO DAMIAN;PEREZ DE HERRASTI PELLON JOSE MARIA;GONZALEZ DE BETOLAZA GARCIAROBERTO RAMON. Nombramientos. Presidente: GONZALEZ DE BETOLAZA GARCIA ROBERTO RAMON. Apoderado: RUBIDORAMONDE BENITO DAMIAN;VALDECANTOS JIMENEZ DE ANDRADE PEDRO;DE LA INFIESTA ROLLAN JOSEMANUEL;GISPERT DE CHIA NURIA;GONZALEZ DE BETOLAZA GARCIA ROBERTO RAMON. Datos registrales. T 36269 , F 58, S8, H M 651637, I/A 11 (11.10.18).
07 de Marzo de 2018Sociedad unipersonal. Cambio de identidad del socio 煤nico: BTC ONCE SARL. Datos registrales. T 36269 , F 56, S 8, H M651637, I/A 9 (27.02.18).
17 de Enero de 2018Modificaciones estatutarias. Fecha de Cierre de Ejercicio: 28/2. Introducci贸n del art铆culo 4 bis de los estatutos sociales.. Datosregistrales. T 36269 , F 56, S 8, H M 651637, I/A 8 (10.01.18).
04 de Enero de 2018Nombramientos. Apo.Sol.: TORIJA CARPINTERO GABRIEL;SIERRA GARCIA MARCO. Datos registrales. T 36269 , F 55, S 8, HM 651637, I/A 7 (26.12.17).
21 de Noviembre de 2017Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: FONCILLAS GARCIA DE LA MATA IGNACIO MARIA. Nombramientos. SecreNoConsj: BLASCOFILLOL SERGIO. VsecrNoConsj: SESMA LOPEZ DOLORES. Consejero: FONCILLAS GARCIA DE LA MATA IGNACIO;RUBIDORAMONDE BENITO DAMIAN;PEREZ DE HERRASTI PELLON JOSE MARIA;VALDECANTOS JIMENEZ DE ANDRADEPEDRO;GONZALEZ DE BETOLAZA GARCIA ROBERTO RAMON. Presidente: FONCILLAS GARCIA DE LA MATA IGNACIO MARIA.Modificaciones estatutarias. SE MODIFICAN LOS ARTICULOS 8 Y 9 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES. . Otros conceptos:Cambio del Organo de Administraci贸n: Administrador 煤nico a Consejo de administraci贸n. Datos registrales. T 36269 , F 51, S 8, H M651637, I/A 4 (13.11.17).
Nombramientos. Apoderado: VALDECANTOS JIMENEZ DE ANDRADE PEDRO;FONCILLAS GARCIA DE LA MATA IGNACIOMARIA;RUBIDO RAMONDE BENITO DAMIAN;PEREZ DE HERRASTI PELLON JOSE MARIA;GONZALEZ DE BETOLAZA GARCIAROBERTO RAMON. Datos registrales. T 36269 , F 52, S 8, H M 651637, I/A 5 (13.11.17).
Nombramientos. Apoderado: VALDECANTOS JIMENEZ DE ANDRADE PEDRO. Datos registrales. T 36269 , F 54, S 8, H M651637, I/A 6 (13.11.17).
18 de Agosto de 2017Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: SESMA LOPEZ DOLORES. Nombramientos. Adm. Unico: FONCILLAS GARCIA DE LA MATAIGNACIO MARIA. Ampliacion del objeto social. La fabricaci贸n, distribuci贸n, venta, importaci贸n y exportaci贸n de ropa confeccionaday prendas de vestir en general, sus accesorios, calzados y art铆culos de regalo y perfumer铆a. La adquisici贸n, explotaci贸n, arrendamiento,promoci贸n y enajenaci贸n de bienes inmuebles. Cambio de domicilio social. C/ SERRANO 66 6陋 (MADRID). Datos registrales. T36269 , F 51, S 8, H M 651637, I/A 2 ( 9.08.17).
Sociedad unipersonal. Cambio de identidad del socio 煤nico: FONCILLAS GARCIA DE LA MATA IGNACIO MARIA. Datosregistrales. T 36269 , F 51, S 8, H M 651637, I/A 3 ( 9.08.17).
11 de Agosto de 2017Constituci贸n. Comienzo de operaciones: 13.07.17. Objeto social: La sociedad tendr谩 por objeto las siguientes actividades:Actividades de las sociedades holding; Otras actividades de consultor铆a de gesti贸n empresarial; Otra educaci贸n n. c. o. p.;Intermediarios del comercio de productos diversos; Comercio al por menor de textiles en establecimientos especializad. Domicilio:PASEO EDUARDO DATO 23 2 (MADRID). Capital: 3.000,00 Euros. Declaraci贸n de unipersonalidad. Socio 煤nico: SESMA LOPEZDOLORES. Nombramientos. Adm. Unico: SESMA LOPEZ DOLORES. Socio: SESMA LOPEZ DOLORES. Datos registrales. T36269 , F 50, S 8, H M 651637, I/A 1 ( 4.08.17).