Buscador CIF Logo

Actos BORME Micronet Sa

驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Micronet Sa

Actos BORME Micronet Sa - A28899599

Tenemos registrados 16 Actos BORME del Registro Mercantil de Madrid para Micronet Sa con CIF A28899599

馃敊 Perfil de Micronet Sa
馃洅 Comprar listado completo de Empresas de Madrid

Actos BORME de Micronet Sa

16 de Junio de 2021
Ceses/Dimisiones. Consejero: MARTINEZ LOPEZ FRANCISCO JOSE. Cons.Del.Sol: MARTINEZ LOPEZ FRANCISCO JOSE.Consejero: PEREZ PRIETO SERGIO. Presidente: MARTINEZ LOPEZ FRANCISCO JOSE. Secretario: PEREZ PRIETO SERGIO.Consejero: LOPEZ MORA JULIO. Nombramientos. Consejero: MARTINEZ LOPEZ FRANCISCO JOSE. Con.Delegado: MARTINEZLOPEZ FRANCISCO JOSE. Presidente: MARTINEZ LOPEZ FRANCISCO JOSE. Consejero: PEREZ PRIETO SERGIO. Secretario:PEREZ PRIETO SERGIO. Consejero: LOPEZ MORA JULIO. Datos registrales. T 22872 , F 196, S 8, H M 104687, I/A 68 ( 9.06.21).

14 de Junio de 2017
Ceses/Dimisiones. Consejero: BARTOLOME MIGUEL JOSE FERNANDO. Nombramientos. Consejero: LOPEZ MORA JULIO.Datos registrales. T 22872 , F 195, S 8, H M 104687, I/A 67 ( 7.06.17).

22 de Noviembre de 2016
Ceses/Dimisiones. Consejero: OSUNA SAIZ IGNACIO. Presidente: OSUNA SAIZ IGNACIO. Cons.Del.Sol: OSUNA SAIZ IGNACIO.Secretario: MARTINEZ LOPEZ FRANCISCO JOSE. Nombramientos. Presidente: MARTINEZ LOPEZ FRANCISCO JOSE.Secretario: PEREZ PRIETO SERGIO. Datos registrales. T 22872 , F 195, S 8, H M 104687, I/A 66 (14.11.16).

07 de Julio de 2016
Ceses/Dimisiones. Consejero: MARTINEZ LOPEZ FRANCISCO JOSE;OSUNA SAIZ IGNACIO;BARTOLOME MIGUEL JOSEFERNANDO.Presidente: OSUNA SAIZ IGNACIO. Secretario: MARTINEZ LOPEZ FRANCISCO JOSE. Cons.Del.Sol: OSUNA SAIZIGNACIO;MARTINEZ LOPEZ FRANCISCO JOSE. Nombramientos. Consejero: OSUNA SAIZ IGNACIO. Presidente: OSUNA SAIZIGNACIO. Cons.Del.Sol: OSUNA SAIZ IGNACIO. Consejero: MARTINEZ LOPEZ FRANCISCO JOSE. Secretario: MARTINEZ LOPEZFRANCISCO JOSE. Cons.Del.Sol: MARTINEZ LOPEZ FRANCISCO JOSE. Consejero: BARTOLOME MIGUEL JOSEFERNANDO;PEREZ PRIETO SERGIO. Datos registrales. T 22872 , F 194, S 8, H M 104687, I/A 65 (27.06.16).

03 de Noviembre de 2014
Modificaciones estatutarias. Art铆culo de los estatutos: 26. EJERCICIO SOCIAL. El ejercicio social dar谩 comienzo el primero de eneroy terminar谩 el treinta y uno de diciembre. . . . . -. Datos registrales. T 22872 , F 194, S 8, H M 104687, I/A 64 (27.10.14).

10 de Febrero de 2014
Declaraci贸n de unipersonalidad. Socio 煤nico: TASLOKO SL. Datos registrales. T 22872 , F 194, S 8, H M 104687, I/A 63(31.01.14).

05 de Febrero de 2014
Cambio de domicilio social. AVDA DE LA FUENTE NUEVA, NUMERO 14, NAVE 7B (SAN SEBASTIAN DE LOS REYES). Datosregistrales. T 22872 , F 192, S 8, H M 104687, I/A 61 (28.01.14).

Nombramientos. Apoderado: PEREZ PRIETO SERGIO. Datos registrales. T 22872 , F 192, S 8, H M 104687, I/A 62 (28.01.14).

22 de Noviembre de 2013
Ceses/Dimisiones. Auditor: TORRENTE CENALMOR BELEN. Aud.Supl.: ATRIUM AUDITORES SA. Datos registrales. T 22872 , F192, S 8, H M 104687, I/A 60 (14.11.13).

10 de Diciembre de 2012
Revocaciones. Auditor: MAZARS AUDITORES SLP. Nombramientos. Auditor: TORRENTE CENALMOR BELEN. Aud.Supl.:ATRIUM AUDITORES SA. Datos registrales. T 22872 , F 191, S 8, H M 104687, I/A 59 (28.11.12).

13 de Julio de 2011
Ceses/Dimisiones. Consejero: MARTINEZ LOPEZ FRANCISCO-JOSE;OSUNA SAIZ IGNACIO;LOPEZ MORA JULIO. Presidente:LOPEZ MORA JULIO. Secretario: MARTINEZ LOPEZ FRANCISCO-JOSE. Cons.Del.Man: LOPEZ MORA JULIO;MARTINEZ LOPEZFRANCISCO-JOSE;OSUNA SAIZ IGNACIO. Revocaciones. Apo.Sol.: LOPEZ MORA JULIO;OSUNA SAIZ IGNACIO;MARTINEZLOPEZ FRANCISCO JOSE. Nombramientos. Consejero: MARTINEZ LOPEZ FRANCISCO JOSE;OSUNA SAIZIGNACIO;BARTOLOME MIGUEL JOSE FERNANDO.Presidente: OSUNA SAIZ IGNACIO. Secretario: MARTINEZ LOPEZFRANCISCO JOSE. Cons.Del.Sol: OSUNA SAIZ IGNACIO;MARTINEZ LOPEZ FRANCISCO JOSE. Datos registrales. T 22872 , F190, S 8, H M 104687, I/A 58 ( 1.07.11).

23 de Noviembre de 2009
Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 35.950,00 Euros. Resultante Suscrito: 225.000,00 Euros. Fe de erratas: SE OMITIO PORERROR EN LA INSCRIPCION 44& UN ACTO DE REDUCCION DE CAPITAL DE 225.000 EUROS. Datos registrales. T 6426 , F225, S 8, H M 104687, I/A 44 (17.07.06).

Ampliaci贸n de capital. Suscrito: 9.925,00 Euros. Desembolsado: 9.925,00 Euros. Resultante Suscrito: 234.925,00 Euros. ResultanteDesembolsado: 234.925,00 Euros. Datos registrales. T 22872 , F 189, S 8, H M 104687, I/A 56 (11.11.09).

Ampliaci贸n de capital. Suscrito: 29.950,00 Euros. Desembolsado: 29.950,00 Euros. Resultante Suscrito: 264.875,00 Euros.Resultante Desembolsado: 264.875,00 Euros. Datos registrales. T 22872 , F 190, S 8, H M 104687, I/A 57 (11.11.09).

19 de Junio de 2009
Revocaciones. Auditor: CABALLERO ANTON ANGEL. Aud.Supl.: CABALLERO ALONSO ANGEL MARIA. Nombramientos.Auditor: MAZARS AUDITORES SL. Datos registrales. T 22872 , F 189, S 8, H M 104687, I/A 55 ( 9.06.09).

10 de Junio de 2009
Cambio de domicilio social. AVDA CAMINO DE LO CORTAO 6-8 - NAVE 3 (SAN SEBASTIAN DE LOS REYES). Datosregistrales. T 22872 , F 189, S 8, H M 104687, I/A 54 (29.05.09).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n