Actos BORME de Midamarta Sl
06 de Septiembre de 2023Otros conceptos: EXTINGUIDA Y CANCELADOS TODOS SUS ASIENTOS POR HABER SIDO ABSORBIDA POR LA SOCIEDAD"GESTION DE INMUEBLES ADQUIRIDOS SL" INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL DE MALAGA. Extinci贸n. Dep贸sito delibros. Datos registrales. T 33842 , F 154, S 8, H M 427321, I/A 53 (30.08.23).
16 de Enero de 2023Sociedad unipersonal. Cambio de identidad del socio 煤nico: UNICAJA BANCO SA. Datos registrales. T 33842 , F 153, S 8, H M427321, I/A 51 ( 9.01.23).
Revocaciones. Apoderado: PASTOR LEIRA MANUEL ROGELIO;PASTOR LEIRA MANUEL ROGELIO. Datos registrales. T 33842 ,F 154, S 8, H M 427321, I/A 52 ( 9.01.23).
04 de Julio de 2022Ceses/Dimisiones. Representan: SANCHEZ ALVAREZ VICENTE. Nombramientos. Representan: MU脩OZ TORRES MARIALOURDES. Datos registrales. T 33842 , F 153, S 8, H M 427321, I/A 50 (27.06.22).
20 de Mayo de 2022Nombramientos. Apo.Sol.: CARRE脩O FERNANDEZ MARIO LUIS;FERNANDEZ RODRIGUEZ JOSE CARLOS. Datos registrales.T 33842 , F 152, S 8, H M 427321, I/A 48 (12.05.22).
Nombramientos. Apo.Sol.: ANDALUZA DE TRAMITACIONES Y GESTIONES SA. Datos registrales. T 33842 , F 153, S 8, H M427321, I/A 49 (12.05.22).
19 de Mayo de 2022Nombramientos. Apo.Sol.: BRAVO PERIA脩EZ SILVIA;FERNANDEZ RODRIGUEZ JOSE CARLOS;CAMPILLO LORENZOGABRIEL;MU脩OZ TORRES LOURDES;CASAS PATI脩O MARIA-JESUS;CALVO MERODIO CELIA;RODRIGUEZ URGELADELA;MARTINEZ COLLAR MONICA;MURILLO SANCHEZ VICENTE;CASTRO GARCIA-RUBIO ENRIQUE-LUIS;MARTIN LOZANOMARIA-PILAR;PODADERA DOMINGUEZ ANA. Datos registrales. T 33842 , F 151, S 8, H M 427321, I/A 46 (11.05.22).
Nombramientos. Apo.Sol.: CARRE脩O FERNANDEZ MARIO LUIS;FERNANDEZ RODRIGUEZ JOSE CARLOS. Datos registrales.T 33842 , F 152, S 8, H M 427321, I/A 47 (11.05.22).
29 de Octubre de 2021Revocaciones. Auditor: DELOITTE SL. Nombramientos. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datosregistrales. T 33842 , F 151, S 8, H M 427321, I/A 45 (22.10.21).
17 de Marzo de 2021Revocaciones. Auditor: GRANT THORNTON SLP. Nombramientos. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 33842 , F 151, S8, H M 427321, I/A 44 (10.03.21).
16 de Marzo de 2021Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: MACANAS D'ANIELLO SAMUEL WINSTON. Nombramientos. Adm. Solid.: ASTURIANA DEADMINISTRACION DE VALORES MOBILIARIO;ADMINISTRADORA VALTENAS SL. Representan: MACANAS D'ANIELLO SAMUELWINSTON;SANCHEZ ALVAREZ VICENTE. Otros conceptos: Cambio del Organo de Administraci贸n: Administrador 煤nico aAdministradores solidarios. Datos registrales. T 33842 , F 150, S 8, H M 427321, I/A 43 ( 9.03.21).
13 de Noviembre de 2020Declaraci贸n de unipersonalidad. Socio 煤nico: LIBERBANK SA. Datos registrales. T 33842 , F 150, S 8, H M 427321, I/A 41 (5.11.20).
Nombramientos. Apoderado: DE PABLO VILLAFRANCA SUSANA. Datos registrales. T 33842 , F 150, S 8, H M 427321, I/A 42 (5.11.20).
02 de Octubre de 2020Nombramientos. Apoderado: PASTOR LEIRA MANUEL ROGELIO. Datos registrales. T 33842 , F 149, S 8, H M 427321, I/A 39(27.09.20).
Nombramientos. Apoderado: PASTOR LEIRA MANUEL ROGELIO. Datos registrales. T 33842 , F 149, S 8, H M 427321, I/A 40(27.09.20).
31 de Julio de 2020Cambio de domicilio social. CMNO DE LA FUENTE DE LA MORA 5 (MADRID). Datos registrales. T 33842 , F 148, S 8, H M427321, I/A 37 (24.07.20).
Nombramientos. Apo.Sol.: MU脩OZ TORRES LOURDES. Datos registrales. T 33842 , F 148, S 8, H M 427321, I/A 38 (24.07.20).
16 de Julio de 2020Ceses/Dimisiones. Adm. Mancom.: BALLESTEROS CORRALES JOSE LUIS;DE FERNANDO SOUSA FRANCISCO.Nombramientos. Adm. Unico: MACANAS D'ANIELLO SAMUEL WINSTON. Otros conceptos: Cambio del Organo deAdministraci贸n: Administradores mancomunados a Administrador 煤nico. Datos registrales. T 33842 , F 148, S 8, H M 427321, I/A 36 (9.07.20).
15 de Julio de 2020Revocaciones. Apo.Sol.: LILLO CERVANTES ANA-MARIA;SANCHEZ MARTIN LAURA. Apoderado: SALVADOR RODRIGUEZMARIA DE LA SOLEDAD. Apo.Manc.: BALLESTEROS CORRALES JOSE LUIS;MILLET MARTINEZ EDUARDO;SERNA CABRERASERGIO;GARCIA HORNERO EDUVIGES;LOPE DIAZ MANUEL. Apoderado: CARRASCO PARILLA DAVID. Datos registrales. T33842 , F 148, S 8, H M 427321, I/A 35 ( 8.07.20).
29 de Junio de 2020Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 78.028.346,70 Euros. Resultante Suscrito: 71.971.653,30 Euros. Datos registrales. T33842 , F 147, S 8, H M 427321, I/A 34 (22.06.20).
22 de Mayo de 2020Ceses/Dimisiones. Adm. Mancom.: MILLET MARTINEZ EDUARDO. Nombramientos. Adm. Mancom.: DE FERNANDO SOUSAFRANCISCO. Datos registrales. T 33842 , F 147, S 8, H M 427321, I/A 33 (16.05.20).
19 de Octubre de 2018Nombramientos. Auditor: GRANT THORNTON SLP. Datos registrales. T 33842 , F 147, S 8, H M 427321, I/A 32 (11.10.18).
15 de Diciembre de 2017Revocaciones. Apo.Sol.: DIAZ ALVAREZ MARIA VICTORIA. Datos registrales. T 33842 , F 146, S 8, H M 427321, I/A 31 ( 4.12.17).
25 de Agosto de 2017Cambio de domicilio social. C/ JOSE ORTEGA Y GASSET 22-24 4陋 (MADRID). Datos registrales. T 33842 , F 146, S 8, H M427321, I/A 30 (14.08.17).
05 de Abril de 2016Nombramientos. Apoderado: CARRASCO PARILLA DAVID. Otros conceptos: MODIFICADA LA FORMA DE ACTUACION DELOS APODERADOS NOMBRADOS EN LA INSCRIPCION 25& DE LA HOJA SOCIAL. Datos registrales. T 33842 , F 146, S 8, H M427321, I/A 29 (28.03.16).
01 de Febrero de 2016Ampliaci贸n de capital. Capital: 82.386.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 232.386.000,00 Euros. Reducci贸n de capital. Importereducci贸n: 82.386.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 150.000.000,00 Euros. Datos registrales. T 33842 , F 145, S 8, H M 427321,I/A 28 (25.01.16).
21 de Diciembre de 2015Ceses/Dimisiones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Nombramientos. Auditor: GRANT THORNTONSLP. Datos registrales. T 33842 , F 145, S 8, H M 427321, I/A 27 (14.12.15).
23 de Noviembre de 2015Revocaciones. Apoderado: TOMERO MARTIN EUGENIO;BALLESTEROS CORRALES JOSE LUIS;MAYORAL CORRAL LUISAGUSTIN;FERNANDEZ MARTINEZ FERNANDO JOSE;FERNANDEZ REAL JOSE MARIA;MILLET MARTINEZ EDUARDO. Datosregistrales. T 33842 , F 145, S 8, H M 427321, I/A 26 (13.11.15).
20 de Noviembre de 2015Nombramientos. Apo.Manc.: BALLESTEROS CORRALES JOSE LUIS;MILLET MARTINEZ EDUARDO;SERNA CABRERASERGIO;GARCIA HORNERO EDUVIGES;LOPE DIAZ MANUEL. Datos registrales. T 27826 , F 126, S 8, H M 427321, I/A 25(12.11.15).
21 de Octubre de 2015Ceses/Dimisiones. Adm. Mancom.: TOMERO MARTIN EUGENIO;BALLESTEROS CORRALES JOSE LUIS. Nombramientos.Adm. Mancom.: BALLESTEROS CORRALES JOSE LUIS;MILLET MARTINEZ EDUARDO. Datos registrales. T 27826 , F 126, S 8, HM 427321, I/A 24 ( 9.10.15).
19 de Diciembre de 2014Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 27826 , F 126, S 8, H M 427321,I/A 23 (11.12.14).
28 de Octubre de 2014Nombramientos. Apoderado: MILLET MARTINEZ EDUARDO. Otros conceptos: Modificado el apartado B) Modo de ejercicio de lainscripci贸n 16&. Datos registrales. T 27826 , F 126, S 8, H M 427321, I/A 22 (20.10.14).
23 de Octubre de 2014Nombramientos. Apoderado: SALVADOR RODRIGUEZ MARIA DE LA SOLEDAD. Datos registrales. T 27826 , F 125, S 8, H M427321, I/A 21 (15.10.14).
30 de Septiembre de 2014Cambio de domicilio social. C/ JOSE ORTEGA Y GASSET 22, - 3潞 PLANTA. (MADRID). Datos registrales. T 27826 , F 125, S 8, HM 427321, I/A 20 (22.09.14).
12 de Septiembre de 2014Ceses/Dimisiones. Adm. Mancom.: ALVAREZ LOPEZ ANGEL;VALDECANTOS GARCIA ELOY. Nombramientos. Adm. Mancom.:TOMERO MARTIN EUGENIO;BALLESTEROS CORRALES JOSE LUIS. Datos registrales. T 27826 , F 125, S 8, H M 427321, I/A 19( 2.09.14).
10 de Septiembre de 2014Revocaciones. Apoderado: SANCHEZ-HEREDERO ALVAREZ ANDRES;ALVAREZ LOPEZ ANGEL;VALDECANTOS GARCIAELOY;MARIN BELLVER JOSE IGNACIO;TOMERO MARTIN EUGENIO. Datos registrales. T 27826 , F 122, S 8, H M 427321, I/A 17( 2.09.14).
Nombramientos. Apo.Sol.: LILLO CERVANTES ANA-MARIA;DIAZ ALVAREZ MARIA VICTORIA;SANCHEZ MARTIN LAURA. Datosregistrales. T 27826 , F 123, S 8, H M 427321, I/A 18 ( 2.09.14).
03 de Septiembre de 2014Nombramientos. Apoderado: TOMERO MARTIN EUGENIO;BALLESTEROS CORRALES JOSE LUIS;MAYORAL CORRAL LUISAGUSTIN;FERNANDEZ MARTINEZ FERNANDO JOSE;FERNANDEZ REAL JOSE MARIA. Datos registrales. T 27826 , F 118, S 8,H M 427321, I/A 16 (27.08.14).
12 de Julio de 2013Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 122.000.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 0,00 Euros. Ampliaci贸n de capital. Capital:150.000.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 150.000.000,00 Euros. Datos registrales. T 27826 , F 118, S 8, H M 427321, I/A 15 (4.07.13).
05 de Marzo de 2012Nombramientos. Apoderado: BRIAREO GESTION SA. Datos registrales. T 27826 , F 117, S 8, H M 427321, I/A 14 (21.02.12).
09 de Febrero de 2012Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 141.450.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 0,00 Euros. Ampliaci贸n de capital. Capital:250.000.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 250.000.000,00 Euros. Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 128.000.000,00 Euros.Resultante Suscrito: 122.000.000,00 Euros. Datos registrales. T 27826 , F 115, S 8, H M 427321, I/A 13 (30.01.12).
18 de Enero de 2012Nombramientos. Apoderado: ALVAREZ LOPEZ ANGEL;VALDECANTOS GARCIA ELOY;MARIN BELLVER JOSEIGNACIO;TOMERO MARTIN EUGENIO. Datos registrales. T 27826 , F 112, S 8, H M 427321, I/A 12 ( 9.01.12).
23 de Diciembre de 2011Nombramientos. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 27826 , F 112, S 8, H M 427321,I/A 11 (12.12.11).
16 de Septiembre de 2011Revocaciones. Apo.Manc.: BARREU LAFUENTE ANTONIO;LARRAZ GONZALEZ MARIA JESUS. Datos registrales. T 27826 , F111, S 8, H M 427321, I/A 10 ( 5.09.11).
05 de Abril de 2011Ceses/Dimisiones. Adm. Mancom.: CAJA DE AHORROS DE CASTILLA LA MANCHA;CAJA CASTILLA LA MANCHACORPORACION SA. Representan: SANCHEZ HEREDERO ALVAREZ ANDRES;ALKORTA ANDONEGI PATXI XABIER.Nombramientos. Adm. Mancom.: ALVAREZ LOPEZ ANGEL;VALDECANTOS GARCIA ELOY. Cambio de domicilio social. C/JOSE ORTEGA Y GASSET 22, 5& PLANTA (MADRID). Datos registrales. T 27826 , F 111, S 8, H M 427321, I/A 9 (25.03.11).
03 de Noviembre de 2010Ampliaci贸n de capital. Capital: 11.220.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 141.450.000,00 Euros. Modificaciones estatutarias.Art铆culo de los estatutos: 5. Capital.-. Datos registrales. T 27826 , F 109, S 8, H M 427321, I/A 8 (19.10.10).
28 de Octubre de 2010Otros conceptos: Se subsana la inscripci贸n 6& en cuanto a la aportaci贸n de una finca que corresponde a la participaciones 3280 a3309, siendo lo correcto, por dichas participaciones tres fincas r煤sticas, aportadas por Caja de Ahorros de Castilla la Mancha , inscritastodas en el Registro de la Propiedad de Cuenca. Datos registrales. T 27826 , F 108, S 8, H M 427321, I/A 7 (19.10.10).
17 de Septiembre de 2010Ceses/Dimisiones. Consejero: SAIZ ALONSO FRANCISCO JAVIER;RODRIGUEZ ROMO JOSE LUIS. Presidente: RODRIGUEZROMO JOSE LUIS. Con.Delegado: RODRIGUEZ ROMO JOSE LUIS. Consejero: LOPEZ HERNANDEZ ALEJANDRO. SecreNoConsj:LOPEZ HERNANDEZ ALEJANDRO. Nombramientos. Adm. Mancom.: CAJA DE AHORROS DE CASTILLA LA MANCHA;CAJACASTILLA LA MANCHA CORPORACION SA. Representan: ALKORTA ANDONEGI PATXI XABIER;SANCHEZ HEREDEROALVAREZ ANDRES. Modificaciones estatutarias. Cambio del Organo de Administraci贸n: Consejo de administraci贸n aAdministradores mancomunados. Datos registrales. T 23808 , F 15, S 8, H M 427321, I/A 5 ( 7.09.10).
Ampliaci贸n de capital. Capital: 129.230.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 130.230.000,00 Euros. Datos registrales. T 23808 , F15, S 8, H M 427321, I/A 6 ( 7.09.10).
21 de Junio de 2010Nombramientos. Apoderado: SANCHEZ HEREDERO ALVAREZ ANDRES. Datos registrales. T 23808 , F 13, S 8, H M 427321, I/A3 ( 8.06.10).
Nombramientos. Apo.Manc.: BARREU LAFUENTE ANTONIO;LARRAZ GONZALEZ MARIA JESUS. Datos registrales. T 23808 , F14, S 8, H M 427321, I/A 4 ( 8.06.10).