Actos BORME de Mielso Sa
11 de Agosto de 2023Revocaciones. Apoderado: ALCACER FALCO MARIA MARTA;ALCACER FALCO MARIA MARTA. Datos registrales. T 749, L 316,F 170, S 8, H CS 4576, I/A 65 ( 4.08.23).
28 de Julio de 2023Nombramientos. Apoderado: GOMEZ LOPEZ FRANCISCA. Datos registrales. T 749, L 316, F 169, S 8, H CS 4576, I/A 64(20.07.23).
21 de Febrero de 2023Revocaciones. Apoderado: ROYO GARCIA PEDRO. Datos registrales. T 641, L 208, F 78, S 8, H CS 4576, I/A 62 (14.02.23).
30 de Diciembre de 2022Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: ROYO GARCIA PEDRO. Nombramientos. Adm. Unico: BRAUTON BRAUTON MATIASEUGENIO. Datos registrales. T 641, L 208, F 78, S 8, H CS 4576, I/A 60 (22.12.22).
Nombramientos. Apoderado: ALCACER FALCO MARIA MARTA. Datos registrales. T 641, L 208, F 78, S 8, H CS 4576, I/A 61(22.12.22).
08 de Noviembre de 2022Ceses/Dimisiones. Auditor: RALLO MONFORT MIGUEL. Aud.Supl.: RALLO BORRAS MIGUEL. Nombramientos. Auditor: RALLOBORRAS MIGUEL. Aud.Supl.: RALLO MONFORT MIGUEL. Datos registrales. T 641, L 208, F 78, S 8, H CS 4576, I/A 59 (31.10.22).
18 de Mayo de 2022Nombramientos. Apoderado: ALCACER FALCO MARIA MARTA. Datos registrales. T 641, L 208, F 77, S 8, H CS 4576, I/A 58(10.05.22).
23 de Febrero de 2022Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: SORRIBES CARRERAS JORGE. Nombramientos. Adm. Unico: ROYO GARCIA PEDRO. Datosregistrales. T 641, L 208, F 77, S 8, H CS 4576, I/A 57 (16.02.22).
19 de Noviembre de 2019Ceses/Dimisiones. Auditor: PALLARES CHIVA RAMON JAVIER. Aud.Supl.: ROSELLO PALMER ALEJANDRO. Nombramientos.Auditor: RALLO MONFORT MIGUEL;RALLO BORRAS MIGUEL. Datos registrales. T 641, L 208, F 77, S 8, H CS 4576, I/A 56 (8.11.19).
12 de Julio de 2017Reelecciones. Adm. Unico: SORRIBES CARRERAS JORGE. Datos registrales. T 641, L 208, F 77, S 8, H CS 4576, I/A 55 (5.07.17).
24 de Enero de 2017Ceses/Dimisiones. Aud.Supl.: RALLO MONFORT MIGUEL. Nombramientos. Aud.Supl.: ROSELLO PALMER ALEJANDRO.Reelecciones. Auditor: PALLARES CHIVA RAMON JAVIER. Datos registrales. T 641, L 208, F 77, S 8, H CS 4576, I/A 54(12.01.17).
28 de Julio de 2014Reelecciones. Auditor: PALLARES CHIVA RAMON JAVIER. Aud.Supl.: RALLO MONFORT MIGUEL. Datos registrales. T 641, L208, F 76, S 8, H CS 4576, I/A 53 (16.07.14).
04 de Febrero de 2013Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 60.101,21 Euros. Resultante Suscrito: 240.404,84 Euros. Modificaciones estatutarias.Art铆culo de los estatutos: MODIFICADO por reducci贸n de capital.. Datos registrales. T 641, L 208, F 76, S 8, H CS 4576, I/A 52(26.01.13).
27 de Septiembre de 2012Ceses/Dimisiones. Adm. Solid.: ROYO GARCIA PEDRO;SORRIBES CARRERAS JORGE. Nombramientos. Adm. Unico:SORRIBES CARRERAS JORGE. Modificaciones estatutarias. Cambio del Organo de Administraci贸n: Administradores solidarios aAdministrador 煤nico.modificacion articulo 19.modificacion articulo 22. Datos registrales. T 641, L 208, F 76, S 8, H CS 4576, I/A 50(18.09.12).
Nombramientos. Apoderado: ROYO GARCIA PEDRO. Datos registrales. T 641, L 208, F 76, S 8, H CS 4576, I/A 51 (18.09.12).
13 de Mayo de 2011Ceses/Dimisiones. Auditor: DF ECONOMISTES AUDITORS SL. Nombramientos. Auditor: PALLARES CHIVA RAMON JAVIER.Aud.Supl.: RALLO MONFORT MIGUEL. Datos registrales. T 641, L 208, F 75, S 8, H CS 4576, I/A 49 (28.04.11).
07 de Septiembre de 2010Ceses/Dimisiones. Consejero: GONZALEZ MESTRE JOAQUIN;CARRERAS CHEREGUINI MERCEDES. Secretario: CARRERASCHEREGUINI MERCEDES. Consejero: SORRIBES JAIME BERNARDO. Presidente: SORRIBES JAIME BERNARDO.
Revocaciones. Apo.Manc.: GONZALEZ MESTRE JOAQUIN. Apo.Man.Soli: GONZALEZ MESTRE JOAQUIN. Apoderado:GONZALEZ MESTRE JOAQUIN. Datos registrales. T 641, L 208, F 75, S 8, H CS 4576, I/A 48 (26.08.10).
09 de Abril de 2010Ceses/Dimisiones. Vicesecret.: GONZALEZ MESTRE JOAQUIN. Reelecciones. Consejero: GONZALEZ MESTREJOAQUIN;SORRIBES JAIME BERNARDO;CARRERAS CHEREGUINI MERCEDES. Presidente: SORRIBES JAIME BERNARDO.Secretario: CARRERAS CHEREGUINI MERCEDES. Datos registrales. T 641, L 208, F 75, S 8, H CS 4576, I/A 46 (25.03.10).