Actos BORME de Miguel Bellido Sociedad Anonima
28 de Marzo de 2023Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 118.008,73 Euros. Resultante Suscrito: 738.433,52 Euros. Datos registrales. T 594 , F 41,S 8, H CR 1280, I/A 42 (16.03.23).
23 de Enero de 2023Cambio de domicilio social. POLIG INDUSTRIAL, S/N - CALLE UNION EUROPEA -PARC (MANZANARES). Datos registrales. T
19 de Julio de 2021Nombramientos. Aud.Supl.: ESPAUDITORES SOCIEDAD LIMITADA PROFESIONAL. Auditor: CASTEJON MARTIN MARIA ELENA.Datos registrales. T 594 , F 41, S 8, H CR 1280, I/A 40 ( 6.07.21).
08 de Junio de 2021Ceses/Dimisiones. Consejero: MONSALVE MU脩OZ ALFONSO. Datos registrales. T 594 , F 41, S 8, H CR 1280, I/A 39 ( 1.06.21).
05 de Mayo de 2020Nombramientos. Consejero: BELLIDO SERRANO SONIA;LAVI脩A RICHI EDUARDO;MONSALVE MU脩OZ ALFONSO. Datosregistrales. T 594 , F 41, S 8, H CR 1280, I/A 38 ( 1.04.20).
20 de Agosto de 2019Ceses/Dimisiones. Consejero: SERRANO FERNANDEZ JULIA;GARCIA SECO COLLADO VICENTA. Reelecciones. Consejero:BELLIDO QUINTIAN FELIX;BELLIDO QUINTIAN ALBERTO;BELLIDO CUELLAR DAVID;GRANADOS PATON PEDRO. Secretario:BELLIDO QUINTIAN ALBERTO. Presidente: BELLIDO QUINTIAN FELIX. Cons.Del.Sol: BELLIDO QUINTIAN FELIX;BELLIDOQUINTIAN ALBERTO. Datos registrales. T 594 , F 39, S 8, H CR 1280, I/A 36 ( 5.08.19).
Cambio de domicilio social. POLIG INDUSTRIAL, S/N - CALLE I -PARCELAS 12 Y 13 (MANZANARES). Datos registrales. T 594 ,F 40, S 8, H CR 1280, I/A 37 ( 5.08.19).
19 de Marzo de 2019Ceses/Dimisiones. Secretario: GARCIA LOPEZ LUIS. Nombramientos. Secretario: BELLIDO QUINTIAN ALBERTO. Datosregistrales. T 594 , F 39, S 8, H CR 1280, I/A 34 ( 8.03.19).
Ceses/Dimisiones. Consejero: GARCIA LOPEZ LUIS;BELLIDO QUINTIAN MARIA EVA. Modificaciones estatutarias.MODIFICADOS LOS ARTICULOS 26 Y 29 DE LOS ESTATUTOS REFERENTES AL ORGANO DE ADMINISTRACION. Datosregistrales. T 594 , F 39, S 8, H CR 1280, I/A 35 ( 8.03.19).
25 de Enero de 2019Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 45.075,91 Euros. Resultante Suscrito: 856.442,25 Euros. Modificaciones estatutarias.MODIFICADO EL ARTICULO 32 DE LOS ESTATUTOS REFERENTE A LA RETRIBUCION DEL ORGANO DE ADMINISTRACION..Datos registrales. T 594 , F 39, S 8, H CR 1280, I/A 32 (15.01.19).
22 de Noviembre de 2018Nombramientos. Apoderado: BELLIDO SERRANO SONIA. Datos registrales. T 594 , F 38, S 8, H CR 1280, I/A 32 (15.11.18).
27 de Septiembre de 2018Reelecciones. Auditor: GOMEZ GARCIA FERNANDO. Aud.Supl.: CASTEJON MARTIN MARIA ELENA. Datos registrales. T 594 , F38, S 8, H CR 1280, I/A 31 (18.09.18).
11 de Septiembre de 2018Ceses/Dimisiones. Consejero: MONSALVE MU脩OZ ALFONSO. Cons.Del.Sol: MONSALVE MU脩OZ ALFONSO. Revocaciones.Apoderado: MONSALVE MU脩OZ ALFONSO. Datos registrales. T 594 , F 38, S 8, H CR 1280, I/A 30 ( 7.08.18).
07 de Junio de 2018Ceses/Dimisiones. Consejero: CUELLAR DE HARO MARIA ISABEL. Datos registrales. T 594 , F 37, S 8, H CR 1280, I/A 29(28.05.18).
17 de Abril de 2017Nombramientos. Consejero: BELLIDO CUELLAR DAVID. Datos registrales. T 594 , F 37, S 8, H CR 1280, I/A 27 ( 5.04.17).
11 de Febrero de 2016Ceses/Dimisiones. Consejero: BELLIDO QUINTIAN MIGUEL. Datos registrales. T 594 , F 37, S 8, H CR 1280, I/A 26 (15.01.16).
16 de Noviembre de 2015Reelecciones. Aud.Supl.: CASTEJON MARTIN MARIA ELENA. Auditor: GOMEZ GARCIA FERNANDO. Datos registrales. T 594 , F37, S 8, H CR 1280, I/A 25 ( 4.11.15).
18 de Marzo de 2015Nombramientos. Apo.Man.Soli: GONZALEZ-CALERO MASCARAQUE ENCARNACION;NAVARRO MARTIN MANUEL. Datosregistrales. T 443 , F 225, S 8, H CR 1280, I/A 24 ( 4.03.15).
08 de Mayo de 2014Reelecciones. Consejero: BELLIDO QUINTIAN FELIX;GARCIA LOPEZ LUIS;BELLIDO QUINTIAN ALBERTO;BELLIDO QUINTIANMIGUEL;GRANADOS PATON PEDRO;MONSALVE MU脩OZ ALFONSO;CUELLAR DE HARO MARIA ISABEL;SERRANOFERNANDEZ JULIA;BELLIDO QUINTIAN MARIA EVA;GARCIA SECO COLLADO VICENTA. Presidente: BELLIDO QUINTIAN FELIX.Secretario: GARCIA LOPEZ LUIS. Cons.Del.Sol: BELLIDO QUINTIAN FELIX;BELLIDO QUINTIAN ALBERTO;MONSALVE MU脩OZALFONSO. Datos registrales. T 443 , F 225, S 8, H CR 1280, I/A 23 (23.04.14).
05 de Septiembre de 2012Nombramientos. Auditor: GOMEZ GARCIA FERNANDO. Aud.Supl.: CASTEJON MARTIN MARIA ELENA. Datos registrales. T 443, F 225, S 8, H CR 1280, I/A 22 ( 2.08.12).
07 de Agosto de 2009Reelecciones. Auditor: AUDITORES ECONOMISTAS SOCIEDAD LIMITADA. Datos registrales. T 443 , F 225, S 8, H CR 1280, I/A21 (27.07.09).
22 de Mayo de 2009Ceses/Dimisiones. Consejero: BELLIDO QUINTIAN JULIETA. Reelecciones. Consejero: BELLIDO QUINTIAN FELIX;GARCIALOPEZ LUIS;BELLIDO QUINTIAN ALBERTO;BELLIDO QUINTIAN MIGUEL;GRANADOS PATON PEDRO;MONSALVE MU脩OZALFONSO;CUELLAR DE HARO MARIA ISABEL;SERRANO FERNANDEZ JULIA;BELLIDO QUINTIAN MARIA EVA;GARCIA SECOCOLLADO VICENTA. Presidente: BELLIDO QUINTIAN FELIX. Cons.Del.Sol: BELLIDO QUINTIAN FELIX;BELLIDO QUINTIANALBERTO;MONSALVE MU脩OZ ALFONSO. Secretario: GARCIA LOPEZ LUIS. Datos registrales. T 443 , F 224, S 8, H CR 1280, I/A19 ( 8.05.09).
Nombramientos. Apo.Man.Soli: GONZALEZ-CALERO MASCARAQUE MARIA ENCARNACION;NAVARRO MARTIN MANUEL.Datos registrales. T 443 , F 224, S 8, H CR 1280, I/A 20 ( 8.05.09).