Buscador CIF Logo

Actos BORME Miguel Herraz Sl

驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Miguel Herraz Sl

Actos BORME Miguel Herraz Sl - B80679137

Tenemos registrados 10 Actos BORME del Registro Mercantil de Madrid para Miguel Herraz Sl con CIF B80679137

馃敊 Perfil de Miguel Herraz Sl
馃洅 Comprar listado completo de Empresas de Madrid

Actos BORME de Miguel Herraz Sl

09 de Agosto de 2022
Nombramientos. Apoderado: HERRAZ RAMOS LUIS MIGUEL. Datos registrales. T 26826 , F 128, S 8, H M 110986, I/A 19 (2.08.22).

13 de Abril de 2022
Revocaciones. Apoderado: HERRAZ RAMOS JUAN CARLOS. Datos registrales. T 26826 , F 128, S 8, H M 110986, I/A 18 (6.04.22).

20 de Diciembre de 2021
Nombramientos. Apoderado: DE ONDARZA CARRERA BORJA. Datos registrales. T 26826 , F 127, S 8, H M 110986, I/A 17(10.12.21).

05 de Noviembre de 2018
Cambio de domicilio social. C/ PALOMA 2 - BAJO (COLMENAREJO). Datos registrales. T 26826 , F 127, S 8, H M 110986, I/A 16(26.10.18).

31 de Octubre de 2013
Ceses/Dimisiones. Consejero: HERRAZ RAMOS EVA MARIA. Con.Delegado: HERRAZ RAMOS EVA MARIA. Nombramientos.Consejero: DE ONDARZA CARRERA BORJA. Con.Delegado: DE ONDARZA CARRERA BORJA. Datos registrales. T 26826 , F 126,S 8, H M 110986, I/A 15 (23.10.13).

23 de Diciembre de 2011
Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 169.920,00 Euros. Resultante Suscrito: 670.080,00 Euros. Datos registrales. T 26826 , F126, S 8, H M 110986, I/A 14 (12.12.11).

02 de Noviembre de 2011
Otros conceptos: POR ACUERDO DE LA JUNTA DEL 20 DE ABRIL DE 2011, SE REDOMINAN LAS PARTICIPACIONESSOCIALES Y SE DA NUEVA REDACCION AL ARTICULO 5潞.- Datos registrales. T 26826 , F 125, S 8, H M 110986, I/A 13(18.10.11).

22 de Marzo de 2011
Nombramientos. Apoderado: HERRAZ RAMOS JUAN CARLOS. Datos registrales. T 26826 , F 125, S 8, H M 110986, I/A 12 (8.03.11).

02 de Octubre de 2009
Ceses/Dimisiones. Consejero: HERRAZ RAMOS MARIA DE LAS MERCEDES. Con.Delegado: HERRAZ RAMOS MARIA DE LASMERCEDES. Nombramientos. Consejero: HERRAZ RAMOS EVA MARIA. Con.Delegado: HERRAZ RAMOS EVA MARIA. Datosregistrales. T 6815 , F 225, S 8, H M 110986, I/A 11 (22.09.09).

16 de Marzo de 2009
Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: RAMOS HORCAJUELO MARIA LUISA. Nombramientos. Consejero: HERRAZ GARCIAMIGUEL;RAMOS HORCAJUELO MARIA LUISA;HERRAZ RAMOS MARIA DE LAS MERCEDES. Presidente: HERRAZ GARCIAMIGUEL. Secretario: RAMOS HORCAJUELO MARIA LUISA. Con.Delegado: HERRAZ RAMOS MARIA DE LAS MERCEDES.Modificaciones estatutarias. 13. Administraci贸n y Representacion.-.Cambio del Organo de Administraci贸n: Administrador 煤nico aConsejo de administraci贸n. Datos registrales. T 6815 , F 225, S 8, H M 110986, I/A 10 ( 4.03.09).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n