Actos BORME de Mil Catorce Sl
23 de Agosto de 2022Revocaciones. APODERADO: RIUS CASANOVAS JOSE MARIA;RIUS CASANOVAS GABRIEL;RIUS CASANOVAS JUAN.APODERAD.SOL: GARCES BEGUE JOSE. Datos registrales. T 35793 , F 77, S 8, H B 76154, I/A 23 (16.08.22).
04 de Enero de 2021Revocaciones. PRESIDENTE: RIUS FERNANDEZ ALBERT. Nombramientos. APOD.MANCOMU: RIUS FERNANDEZALBERT;RIUS ALFEREZ JOSEP;RIUS FAIG ONA. PRESIDENTE: RIUS FAIG ONA. Datos registrales. T 35793 , F 76, S 8, H B76154, I/A 22 (23.12.20).
21 de Agosto de 2014Revocaciones. CONSEJERO: RIUS CASANOVAS JOSE MARIA;RIUS CASANOVAS GABRIEL;RIUS CASANOVAS JOAN.PRESIDENTE: RIUS CASANOVAS JOSEP MARIA. SECR.NO CONS: RIUS ALFEREZ JOSEP. Nombramientos. CONSEJERO:RIUS FERNANDEZ ALBERT. PRESIDENTE: RIUS FERNANDEZ ALBERT. CONSEJERO: RIUS FERNANDEZ ANNA;RIUS ALFEREZJOSEP. SECRETARIO: RIUS ALFEREZ JOSEP. CONSEJERO: RIUS ALFEREZ GABRIEL;RIUS FAIG ONA;RIUS FAIG CLARA.Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 1.367.706,00 Euros. Resultante Suscrito: 0,00 Euros. Ampliaci贸n de capital. Capital:6.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 6.000,00 Euros. Datos registrales. T 35793 , F 75, S 8, H B 76154, I/A 21 (12.08.14).
17 de Febrero de 2014Nombramientos. AUDIT.CUENT.: VELAUDIA AUDITORES SL. Datos registrales. T 35793 , F 74, S 8, H B 76154, I/A 20 ( 7.02.14).
31 de Julio de 2013Nombramientos. APODERAD.SOL: GARCIA BLANCO JORGE;GUSTA CALDERON JORDI;GARCES BEGUE JOSE;RIUSALFEREZ JOSEP. Datos registrales. T 35793 , F 74, S 8, H B 76154, I/A 19 (23.07.13).
06 de Mayo de 2010Ampliaci贸n de capital. Capital: 347.502,00 Euros. Resultante Suscrito: 1.367.706,00 Euros. Datos registrales. T 35793 , F 74, S 8,H B 76154, I/A 18 (26.04.10).
30 de Diciembre de 2009Ampliaci贸n de capital. Capital: 650.004,00 Euros. Resultante Suscrito: 1.020.204,00 Euros. Datos registrales. T 35793 , F 73, S 8,H B 76154, I/A 17 (16.12.09).