Buscador CIF Logo

Actos BORME Millicom International One Sl

驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Millicom International One Sl

Actos BORME Millicom International One Sl - B86817111

Tenemos registrados 11 Actos BORME del Registro Mercantil de Madrid para Millicom International One Sl con CIF B86817111

馃敊 Perfil de Millicom International One Sl
馃洅 Comprar listado completo de Empresas de Madrid

Actos BORME de Millicom International One Sl

12 de Enero de 2023
Ceses/Dimisiones. Consejero: KIDDELL JOHN EDWARD. Presidente: KIDDELL JOHN EDWARD. Co.De.Ma.So: KIDDELL JOHNEDWARD. Nombramientos. Consejero: LANGEVIN ANTHONY PHILIPPE. Co.De.Ma.So: LANGEVIN ANTHONY PHILIPPE.Apoderado: NIEUWLAND BRUNO;BRUHA SHELDON LEE;DE BENITO FERNANDEZ GONZALO. Presidente: LANGEVIN ANTHONYPHILIPPE. Apoderado: LANGEVIN ANTHONY PHILIPPE. Datos registrales. T 31180 , F 209, S 8, H M 561195, I/A 12 ( 4.01.23).

13 de Octubre de 2022
Revocaciones. Apo.Manc.: PENNINGTON TIMOTHY LINCOLN. Nombramientos. Apo.Manc.: NIEUWLAND BRUNO;GILLPATRICK ANTHONY;VANHAEREN BART;VIANNA CELSO. Datos registrales. T 31180 , F 209, S 8, H M 561195, I/A 11 ( 5.10.22).

22 de Julio de 2022
Ceses/Dimisiones. Consejero: PENNINGTON TIMOTHY LINCOLN. Co.De.Ma.So: PENNINGTON TIMOTHY LINCOLN.Nombramientos. Consejero: BRUHA SHELDON LEE. Co.De.Ma.So: BRUHA SHELDON LEE. Datos registrales. T 31180 , F 208, S8, H M 561195, I/A 10 (15.07.22).

02 de Noviembre de 2021
Revocaciones. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 31180 , F 208, S 8, H M 561195, I/A 9 (25.10.21).

29 de Abril de 2021
Ceses/Dimisiones. Adm. Mancom.: KIDDELL JOHN EDWARD;PENNINGTON TIMOTHY LINCOLN;NIEUWLAND BRUNO;DEBENITO FERNANDEZ GONZALO. Nombramientos. Consejero: KIDDELL JOHN EDWARD;DE BENITO FERNANDEZGONZALO;PENNINGTON TIMOTHY LINCOLN;NIEUWLAND BRUNO. Presidente: KIDDELL JOHN EDWARD. Vicepresid.: DEBENITO FERNANDEZ GONZALO. Co.De.Ma.So: KIDDELL JOHN EDWARD;PENNINGTON TIMOTHY LINCOLN;DE BENITOFERNANDEZ GONZALO;NIEUWLAND BRUNO. SecreNoConsj: GONZALEZ ALONSO-ALEGRE RAMIRO. Otros conceptos:Cambio del Organo de Administraci贸n: Administradores mancomunados a Consejo de administraci贸n. Datos registrales. T 31180 , F207, S 8, H M 561195, I/A 8 (22.04.21).

21 de Noviembre de 2019
Nombramientos. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 31180 , F 207, S 8, H M 561195, I/A 7 (14.11.19).

18 de Noviembre de 2016
Nombramientos. Adm. Mancom.: DE BENITO FERNANDEZ GONZALO. Datos registrales. T 31180 , F 206, S 8, H M 561195, I/A 6(11.11.16).

17 de Septiembre de 2015
Nombramientos. Adm. Mancom.: NIEUWLAND BRUNO. Datos registrales. T 31180 , F 206, S 8, H M 561195, I/A 5 (10.09.15).

05 de Mayo de 2015
Nombramientos. Apo.Manc.: HAPPART JEAN PAUL JOSE;ESCALON SALVADOR;NIEUWLAND BRUNO;GILL PATRICKANTHONY;LAETITIA DIMOVIC JUSTINE;VAN OERS DE PREST JACQUES-FRANCOIS;BERNAL CAROLINA RAQUEL. Datosregistrales. T 31180 , F 206, S 8, H M 561195, I/A 4 (24.04.15).

12 de Diciembre de 2014
Ceses/Dimisiones. Adm. Mancom.: ZAGAR MARC ANDRE. Nombramientos. Adm. Mancom.: PENNINGTON TIMOTHY LINCOLN.Datos registrales. T 31180 , F 205, S 8, H M 561195, I/A 3 ( 3.12.14).

25 de Noviembre de 2014
Nombramientos. Apo.Sol.: KIDDEL JOHN EDWARD;ZAGAR MARC ANDRE. Datos registrales. T 31180 , F 204, S 8, H M 561195,I/A 2 (17.11.14).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n