Actos BORME de Mimwatt Xxi Sl
04 de Agosto de 2022Nombramientos. AUDIT.CUENT.: VIR AUDIT SLP. Datos registrales. T 44077 , F 205, S 8, H B 219543, I/A 13 (26.07.22).
01 de Octubre de 2020Nombramientos. CONS.DEL.SOL: ROVIRA VILARO JORDI. Datos registrales. T 44077 , F 203, S 8, H B 219543, I/A 12(22.09.20).
11 de Septiembre de 2020Revocaciones. ADM.UNICO: ROVIRA VILARO JORDI. Nombramientos. CONSEJERO: ROVIRA VILARO JORDI. PRESIDENTE:ROVIRA VILARO JORDI. CONSEJERO: ROVIRA VILARO JOAN;ROVIRA GARCIA MARIA ROSA. SECRETARIO: ROVIRA GARCIAMARIA ROSA. Modificaciones estatutarias. MODIFICACION DE LOS ARTICULOS 20 Y 24 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES.Datos registrales. T 44077 , F 203, S 8, H B 219543, I/A 11 ( 2.09.20).
31 de Diciembre de 2018Ampliaci贸n de capital. Capital: 4.627.300,00 Euros. Resultante Suscrito: 6.998.500,00 Euros. Datos registrales. T 44077 , F 202, S8, H B 219543, I/A 10 (20.12.18).
22 de Abril de 2016Revocaciones. ADM.UNICO: ROVIRA TENAS SEBASTIA. Nombramientos. ADM.UNICO: ROVIRA VILARO JORDI.Modificaciones estatutarias. MODIFICACION DEL ARTICULO 20 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES. SISTEMA RETRIBUTIVO DELORGANO DE ADMINISTRACION SOCIAL. Datos registrales. T 44077 , F 201, S 8, H B 219543, I/A 9 (14.04.16).
30 de Octubre de 2013Nombramientos. APODERAD.SOL: ROVIRA MARTINEZ MARC. Datos registrales. T 33004 , F 96, S 8, H B 219543, I/A 8(22.10.13).
18 de Octubre de 2013Revocaciones. ADM.UNICO: ROVIRA MARTINEZ MARC. Nombramientos. ADM.UNICO: ROVIRA TENAS SEBASTIA.Ampliaci贸n de capital. Capital: 1.930.300,00 Euros. Resultante Suscrito: 2.371.200,00 Euros. Modificaciones estatutarias.MODIFICACION ARTICULO 20 SISTEMA DE REMUNERACION ORGANO ADMINISTRACION. Fusi贸n por absorci贸n. Sociedadesabsorbidas: CAL PASTOR DE MANLLEU 1679 SL. Datos registrales. T 33004 , F 93, S 8, H B 219543, I/A 7 (10.10.13).