Actos BORME de Minerias Del Terraba Sl
20 de Abril de 2017Ceses/Dimisiones. Secretario: GARCIA GOMEZ DE ZAMORA REMEDIOS. Consejero: CESPEDES MENDEZ MARVIN;ANTILLONAPPEL ALEJANDRO. Vicepresid.: ANTILLON APPEL ALEJANDRO. Vicesecret.: CESPEDES MENDEZ MARVIN. Cons.Del.Man:ANTILLON APPEL ALEJANDRO;CESPEDES MENDEZ MARVIN. Consejero: HIDALGO HIDALGO DAN ALBERTO. Presidente:HIDALGO HIDALGO DAN ALBERTO. Nombramientos. Liquidador: FERNANDEZ DE LA REGUERA MENDEZ OCTAVIO.Disoluci贸n. Voluntaria. Extinci贸n. Datos registrales. T 34559 , F 171, S 8, H M 240923, I/A 15 ( 5.04.17).
19 de Agosto de 2016Ceses/Dimisiones. Consejero: FACHLER GRINSTEIN FREDDY. Presidente: FACHLER GRINSTEIN FREDDY. Cons.Del.Man:FACHLER GRINSTEIN FREDDY. Nombramientos. Consejero: HIDALGO HIDALGO DAN ALBERTO. Presidente: HIDALGOHIDALGO DAN ALBERTO. Datos registrales. T 14551 , F 111, S 8, H M 240923, I/A 14 ( 8.08.16).
14 de Agosto de 2012Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 5.152.085,00 Euros. Resultante Suscrito: 100.000,00 Euros. Datos registrales. T 14551 ,F 111, S 8, H M 240923, I/A 13 ( 2.08.12).
09 de Marzo de 2012Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 1.394.471,00 Euros. Resultante Suscrito: 5.252.085,00 Euros. Datos registrales. T 14551, F 110, S 8, H M 240923, I/A 12 (28.02.12).
06 de Mayo de 2011Nombramientos. Cons.Del.Man: FACHLER GRINSTEIN FREDDY;ANTILLON APPEL ALEJANDRO;CESPEDES MENDEZ MARVIN.Apoderado: PACHECO ALPIZAR HUMBERTO;PACHECO ORTIZ HUMBERTO;PACHECO ORTIZ MIGUEL. Datos registrales. T14551 , F 110, S 8, H M 240923, I/A 11 (25.04.11).
10 de Junio de 2009Revocaciones. Apoderado: BUERGO SANZ MANUEL. Nombramientos. Apoderado: FERNANDEZ DE LA REGUERA MENDEZOCTAVIO. Datos registrales. T 14551 , F 109, S 8, H M 240923, I/A 10 (29.05.09).