Buscador CIF Logo

Actos BORME Miniso Lifestyle Spain Sl

驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Miniso Lifestyle Spain Sl

Actos BORME Miniso Lifestyle Spain Sl - B88081492

Tenemos registrados 20 Actos BORME del Registro Mercantil de Madrid para Miniso Lifestyle Spain Sl con CIF B88081492

馃敊 Perfil de Miniso Lifestyle Spain Sl
馃洅 Comprar listado completo de Empresas de Madrid

Actos BORME de Miniso Lifestyle Spain Sl

10 de Febrero de 2023
Revocaciones. Apoderado: GUTIERREZ NI脩O PABLO. Datos registrales. T 39017 , F 20, S 8, H M 670082, I/A 20 ( 5.02.23).

Nombramientos. Apoderado: CUETO ALVAREZ DE SOTOMAYOR ANA ISABEL. Datos registrales. T 39017 , F 20, S 8, H M670082, I/A 21 ( 5.02.23).

17 de Noviembre de 2022
Nombramientos. Auditor: LOBELIA AUDITORES SL. Datos registrales. T 39017 , F 19, S 8, H M 670082, I/A 19 (10.11.22).

28 de Diciembre de 2021
Nombramientos. Apoderado: GUTIERREZ NI脩O PABLO. Datos registrales. T 39017 , F 18, S 8, H M 670082, I/A 16 (21.12.21).

Revocaciones. Apoderado: WU CHAO;QIN JINXING;OLAVARRIETA BERNARDINO EVA;LLORENTE HERNANDEZ DE ALBAEVA;ESTRADA RUIZ NATALIA;MARI脩O-CASTELAO GONZALEZ JOSE DOMINGO;MERINO RUBIO RAFAEL;MERINO RUBIORAFAEL. Datos registrales. T 39017 , F 19, S 8, H M 670082, I/A 17 (21.12.21).

Nombramientos. Apoderado: RIVERA CASTILLO ANA. Datos registrales. T 39017 , F 19, S 8, H M 670082, I/A 18 (21.12.21).

18 de Noviembre de 2021
Fe de erratas: Se omiti贸 por error en la inscripci贸n 12陋 la publicaci贸n del cese de BAYO SEVILLA SANTIAGO (Vicesecret.) yBERECIBAR MUTIOZABAL JOSE RAMON (SecreNoConsej). Datos registrales. T 39017 , F 16, S 8, H M 670082, I/A 12 ( 4.11.21).

15 de Noviembre de 2021
Nombramientos. Apoderado: DE LOS ANGELES NIETO CRISTINA;PERALES FELIX MARIA DOLORES. Datos registrales. T39017 , F 17, S 8, H M 670082, I/A 15 ( 5.11.21).

12 de Noviembre de 2021
Ceses/Dimisiones. Consejero: BARROSO JIMENEZ JOSE LUIS. Presidente: BARROSO JIMENEZ JOSE LUIS. Consejero:RODRIGUEZ LLOPIS MIGUEL ANGEL. Nombramientos. Consejero: DE VUYST FRANCOISE ANNY CHARLOTTEJEANNE;SERRANO ARENAS PATRICIA. Presidente: DE VUYST FRANCOISE ANNY CHARLOTTE JEANNE. Cambio de domiciliosocial. C/ JOSE ECHEGARAY 1 (ROZAS DE MADRID (LAS)). Datos registrales. T 39017 , F 16, S 8, H M 670082, I/A 11 ( 4.11.21).

Ceses/Dimisiones. Consejero: TOBILLAS ANGULO ROBERTO;URRUTIA COBALEDA FERNANDO;DE VUYST FRANCOISE ANNYCHARLOTTE JEANNE;SERRANO ARENAS PATRICIA. Presidente: DE VUYST FRANCOISE ANNY CHARLOTTE JEANNE.Nombramientos. Adm. Unico: BILCAN GLOBAL SERVICES SL. Representan: URRUTIA COBALEDA FERNANDO. Otrosconceptos: Cambio del Organo de Administraci贸n: Consejo de administraci贸n a Administrador 煤nico. Datos registrales. T 39017 , F16, S 8, H M 670082, I/A 12 ( 4.11.21).

Ampliaci贸n de capital. Capital: 17.240,00 Euros. Resultante Suscrito: 70.240,00 Euros. Datos registrales. T 39017 , F 17, S 8, H M670082, I/A 13 ( 4.11.21).

P茅rdida del caracter de unipersonalidad. Datos registrales. T 39017 , F 17, S 8, H M 670082, I/A 14 ( 4.11.21).

31 de Julio de 2019
Nombramientos. Apoderado: MERINO RUBIO RAFAEL. Datos registrales. T 39017 , F 15, S 8, H M 670082, I/A 10 (24.07.19).

22 de Abril de 2019
Nombramientos. Apoderado: PERALES FELIX MARIA DOLORES;OLAVARRIETA BERNARDINO EVA;CASTRO SANCHEZJORGE;LLORENTE HERNANDEZ DE ALBA EVA;ESTRADA RUIZ NATALIA;MARI脩O-CASTELAO GONZALEZ JOSEDOMINGO;RIVERA CASTILLO ANA;MERINO RUBIO RAFAEL. Datos registrales. T 37597 , F 82, S 8, H M 670082, I/A 8 (11.04.19).

Nombramientos. Apoderado: URRUTIA COBALEDA FERNANDO;URIARTE ALBAINA MIKEL;TOBILLAS ANGULOROBERTO;GOMEZ MAYOR MARIA DEL CARMEN;PEREZ GONZALEZ CRISTINA;BARROETA ZULUAGA JAVIER. Datosregistrales. T 39017 , F 11, S 8, H M 670082, I/A 9 (11.04.19).

17 de Abril de 2019
Ceses/Dimisiones. Consejero: WU CHAO;HUANG JINXIAN;YANG LIN. Presidente: WU CHAO. SecreNoConsj: QIN JINXING.Revocaciones. Apo.Sol.: PORRAS PEDRAZA JUAN. Nombramientos. Consejero: BARROSO JIMENEZ JOSE LUIS. Presidente:BARROSO JIMENEZ JOSE LUIS. Consejero: TOBILLAS ANGULO ROBERTO;URRUTIA COBALEDA FERNANDO;RODRIGUEZLLOPIS MIGUEL ANGEL.SecreNoConsj: BERECIBAR MUTIOZABAL JOSE RAMON. Vicesecret.: BAYO SEVILLA SANTIAGO.Cambio de domicilio social. VIA DE LAS DOS CASTILLAS KM 33 Km - COMPLEJO ATI (POZUELO DE ALARCON). Datosregistrales. T 37597 , F 81, S 8, H M 670082, I/A 7 (10.04.19).

04 de Enero de 2019
Ampliaci贸n de capital. Capital: 50.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 53.000,00 Euros. Datos registrales. T 37597 , F 81, S 8, H M670082, I/A 6 (26.12.18).

08 de Noviembre de 2018
Nombramientos. Apoderado: WU CHAO;QIN JINXING. Datos registrales. T 37597 , F 80, S 8, H M 670082, I/A 5 (30.10.18).

17 de Octubre de 2018
Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: WU CHAO. Nombramientos. Consejero: WU CHAO;YANG LIN;HUANG JINXIAN. Presidente: WUCHAO. SecreNoConsj: QIN JINXING. Otros conceptos: Cambio del Organo de Administraci贸n: Administrador 煤nico a Consejo deadministraci贸n. Datos registrales. T 37597 , F 79, S 8, H M 670082, I/A 4 ( 9.10.18).

16 de Octubre de 2018
Nombramientos. Apo.Sol.: PORRAS PEDRAZA JUAN. Datos registrales. T 37597 , F 79, S 8, H M 670082, I/A 3 ( 5.10.18).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n