Actos BORME de Misco Iberia Computer Supplies Sl
17 de Diciembre de 2020Ceses/Dimisiones. Consejero: CANTWELL ALAN JOHN;DOWNER HARVEY PAUL;ROBISON COLIN. Presidente: CANTWELLALAN JOHN. SecreNoConsj: TMF MANAGEMENT (SPAIN) SL. Representan: GARRIGUES CALDERON MARIA-BELEN.Nombramientos. Liquidador: CANTWELL ALAN JOHN. Disoluci贸n. Voluntaria. Extinci贸n. Datos registrales. T 19986 , F 153, S8, H M 73286, I/A 95 (10.12.20).
13 de Febrero de 2018Reelecciones. Auditor: GRANT THORNTON SLP. Datos registrales. T 19986 , F 153, S 8, H M 73286, I/A 94 ( 5.02.18).
25 de Septiembre de 2017Cambio de domicilio social. C/ SAN RAFAEL NUMERO 1 - PARQUE EMPRESARIAL EUROP (ALCOBENDAS). Datos registrales.T 19986 , F 153, S 8, H M 73286, I/A 93 (14.09.17).
15 de Septiembre de 2017Nombramientos. Apoderado: CANTWELL ALAN JOHN;DOWNER HARVEY PAUL;MARIN CURBELO OSCAR;NAJERA-ALESONDEL CAMPO JULIAN;KARGER-KOCSIS LASZLO JAZSEL;JUHASZ-EMBER PIROSKA GISELA;TIBORCZ FERENC TAMAS. Datosregistrales. T 19986 , F 152, S 8, H M 73286, I/A 92 ( 7.09.17).
27 de Junio de 2017Revocaciones. Apoderado: CAMINO REDONDO ESTHER;KARGER-KOCSIS LASZLO JAZSEL;EMBER PIROSKA GIZELLA.Nombramientos. Apoderado: CANTWELL ALAN JOHN;DOWNER HARVEY PAUL;NAJERA-ALESON DEL CAMPO JULIAN;MARINCURBELO OSCAR;KARGER-KOCSIS LASZLO JOZSEF;JUHASZ-EMBER PIROSKA GISELA;TIBORCZ FERENC TAMAS. Datosregistrales. T 19986 , F 152, S 8, H M 73286, I/A 91 (19.06.17).
26 de Junio de 2017Otros conceptos: Cambiada la denominaci贸n del socio 煤nico que ha pasado a ser "MISCO LUXEMBOURG S.a.r.l", y su domicilio hacambiado a 46, Boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330, Luxemburgo. Datos registrales. T 19986 , F 151, S 8, H M 73286, I/A90 (16.06.17).
26 de Abril de 2017Ceses/Dimisiones. Consejero: LEEDS ROBERT ALAN;AXMACHER THOMAS WILLIAM. Cons.Del.Sol: AXMACHER THOMASWILLIAM. Consejero: REINHOLD LAWRENCE PHILIP. Cons.Del.Sol: REINHOLD LAWRENCE PHILIP. Presidente: REINHOLDLAWRENCE PHILIP. Nombramientos. Consejero: CANTWELL ALAN JOHN;DOWNER HARVEY PAUL;ROBISON COLIN.Presidente: CANTWELL ALAN JOHN. Datos registrales. T 19986 , F 151, S 8, H M 73286, I/A 89 (18.04.17).
25 de Abril de 2017Revocaciones. Apo.Manc.: REINHOLD LAWRENCE PHILIP;AXMACHER THOMAS WILLIAM;BAKER ROBERT. Apoderado: LEEDSROBERT ALAN;NYEKI ESZTER. Datos registrales. T 19986 , F 151, S 8, H M 73286, I/A 88 (17.04.17).
08 de Febrero de 2017Reelecciones. Auditor: GRANT THORNTON SLP. Datos registrales. T 19986 , F 150, S 8, H M 73286, I/A 87 (31.01.17).
09 de Diciembre de 2016Ceses/Dimisiones. Presidente: LEEDS ROBERT ALAN. Nombramientos. Presidente: REINHOLD LAWRENCE PHILIP. Datosregistrales. T 19986 , F 150, S 8, H M 73286, I/A 86 (30.11.16).
21 de Junio de 2016Reelecciones. Auditor: GRANT THORNTON SLP. Datos registrales. T 19986 , F 150, S 8, H M 73286, I/A 85 (13.06.16).
17 de Mayo de 2016Nombramientos. Apo.Manc.: MARIN CURBELO OSCAR. Datos registrales. T 19986 , F 148, S 8, H M 73286, I/A 84 ( 5.05.16).
28 de Abril de 2016Revocaciones. Apo.Manc.: FROWEIN RICARDO. Apoderado: KERESZTENY KINGA AGNES. Datos registrales. T 19986 , F 148, S8, H M 73286, I/A 83 (19.04.16).
17 de Agosto de 2015Ceses/Dimisiones. Consejero: LEEDS BRUCE JAY;LEEDS RICHARD BRIAN. Revocaciones. Apo.Manc.: LEEDS RICHARDBRIAN;DALE PERMINDER SINGH. Nombramientos. Apoderado: LEEDS ROBERT ALAN;KARGER-KOCSIS LASZLOJAZSEL;KERESZTENY KINGA AGNES;NYEKI ESZTER;EMBER PIROSKA GIZELLA. Datos registrales. T 19986 , F 146, S 8, H M73286, I/A 82 ( 7.08.15).
07 de Mayo de 2015Revocaciones. Apo.Man.Soli: NAJERA ALESON DEL CAMPO JULIAN. Apo.Manc.: NAJERA ALESON DEL CAMPOJULIAN;BEDMAR MORACIA ENRIQUE. Apo.Man.Soli: NAJERA-ALESON DEL CAMPO JULIAN;DALE PERMINDER SINGH.
20 de Abril de 2015Reelecciones. Auditor: GRANT THORNTON SLP. Datos registrales. T 19986 , F 144, S 8, H M 73286, I/A 80 (13.04.15).
12 de Septiembre de 2014Revocaciones. Apo.Manc.: NAJERA-ALESON DEL CAMPO JULIAN;BEDMAR MORACIA ENRIQUE. Nombramientos.Apo.Man.Soli: NAJERA-ALESON DEL CAMPO JULIAN;DALE PERMINDER SINGH. Datos registrales. T 19986 , F 143, S 8, H M73286, I/A 79 ( 4.09.14).
28 de Mayo de 2014Ceses/Dimisiones. SecreNoConsj: FERNANDEZ RA脩ADA LOPEZ DORIGA JOSE. VsecrNoConsj: BRAGADO LORENZO JAVIER.Nombramientos. SecreNoConsj: TMF MANAGEMENT (SPAIN) SL. Apo.Manc.: NAJERA-ALESON DEL CAMPO JULIAN;BEDMARMORACIA ENRIQUE. Representan: GARRIGUES CALDERON BELEN. Datos registrales. T 19986 , F 142, S 8, H M 73286, I/A 78(20.05.14).
18 de Febrero de 2014Reelecciones. Auditor: GRANT THORNTON SLP. Datos registrales. T 19986 , F 142, S 8, H M 73286, I/A 77 (10.02.14).
27 de Noviembre de 2013Revocaciones. Apo.Manc.: COMMUNE GERARD. Nombramientos. Apo.Manc.: NAJERA ALESON DEL CAMPO JULIAN;BEDMARMORACIA ENRIQUE. Datos registrales. T 19986 , F 141, S 8, H M 73286, I/A 76 (19.11.13).
28 de Enero de 2013Reelecciones. Auditor: GRANT THORNTON SLP. Datos registrales. T 19986 , F 141, S 8, H M 73286, I/A 75 (18.01.13).
23 de Enero de 2013Ampliaci贸n de capital. Capital: 22.362,00 Euros. Resultante Suscrito: 82.362,00 Euros. Cambio de domicilio social. AVDA DEBARAJAS 30 - PARQUE EMPRESARIAL OMEGA (ALCOBENDAS). Datos registrales. T 19986 , F 141, S 8, H M 73286, I/A 74(16.01.13).
17 de Enero de 2013Nombramientos. Apo.Man.Soli: NAJERA ALESON DEL CAMPO JULIAN. Apo.Manc.: COMMUNE GERARD;BEDMAR MORACIAENRIQUE. Datos registrales. T 19986 , F 139, S 8, H M 73286, I/A 73 ( 8.01.13).