Actos BORME de Mistral Patrimonio Inmobiliario Socimi Sa
15 de Noviembre de 2023Revocaciones. Apoderado: MARAZUELA AZPIROZ MONICA;MARTINEZ GONZALEZ JUAN ANTONIO;MARAZUELA AZPIROZPEDRO;LAPASTORA TURPIN OSCAR;UNZUETA MATA LEIRE. Nombramientos. Apoderado: MARAZUELA AZPIROZMONICA;MARAZUELA AZPIROZ PEDRO;LAPASTORA TURPIN OSCAR;PANIAGUA GUIJARRO MARIA DE LAS MERCEDES.Datos registrales. T 39894 , F 127, S 8, H M 630349, I/A 29 ( 7.11.23).
06 de Noviembre de 2023Reelecciones. Auditor: GRANT THORNTON SLP. Datos registrales. T 39894 , F 127, S 8, H M 630349, I/A 28 (27.10.23).
11 de Octubre de 2023Ceses/Dimisiones. Consejero: MARTINEZ GONZALEZ JUAN ANTONIO. Nombramientos. Consejero: MARAZUELA AZPIROZPEDRO. Reelecciones. Consejero: MARAZUELA AZPIROZ MONICA. Presidente: MARAZUELA AZPIROZ MONICA. Datosregistrales. T 39894 , F 126, S 8, H M 630349, I/A 27 ( 4.10.23).
20 de Enero de 2023Nombramientos. Apo.Sol.: MARAZUELA AZPIROZ MONICA;MARTINEZ GONZALEZ JUAN ANTONIO;LAPASTORA TURPINOSCAR;MARTINEZ SAENZ SUSANA. Datos registrales. T 39894 , F 125, S 8, H M 630349, I/A 26 (13.01.23).
18 de Enero de 2023Reelecciones. Auditor: GRANT THORNTON SLP. Datos registrales. T 39894 , F 125, S 8, H M 630349, I/A 25 (11.01.23).
09 de Mayo de 2022Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 1.703.700,00 Euros. Resultante Suscrito: 6.814.800,00 Euros. Datos registrales. T 39894, F 124, S 8, H M 630349, I/A 24 (29.04.22).
22 de Diciembre de 2021Reelecciones. Auditor: GRANT THORNTON SLP. Datos registrales. T 39894 , F 124, S 8, H M 630349, I/A 23 (15.12.21).
16 de Agosto de 2021Nombramientos. Apo.Sol.: MARAZUELA AZPIROZ MONICA;MARTINEZ GONZALEZ JUAN ANTONIO;LAPASTORA TURPINOSCAR;MARTINEZ SAENZ SUSANA. Datos registrales. T 39894 , F 123, S 8, H M 630349, I/A 22 ( 9.08.21).
18 de Enero de 2021Revocaciones. Apoderado: MISTRAL INVESTMENT MANAGEMENT SL. Datos registrales. T 39894 , F 123, S 8, H M 630349, I/A21 (11.01.21).
24 de Noviembre de 2020Nombramientos. Apoderado: MARAZUELA AZPIROZ MONICA;MARTINEZ GONZALEZ JUAN ANTONIO;MARAZUELA AZPIROZPEDRO;LAPASTORA TURPIN OSCAR;UNZUETA MATA LEIRE. Datos registrales. T 39894 , F 121, S 8, H M 630349, I/A 20(17.11.20).
27 de Julio de 2020Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 2.839.500,00 Euros. Resultante Suscrito: 8.518.500,00 Euros. Modificacionesestatutarias. Art铆culo de los estatutos: 5. Capital social.-. Otros conceptos: RATIFICADO EN SU CARGO DON JUAN ANTONIOMARTINEZ GONZALEZ. Datos registrales. T 39894 , F 120, S 8, H M 630349, I/A 19 (20.07.20).
16 de Marzo de 2020Cambio de domicilio social. C/ SERRANO 93 (MADRID). Datos registrales. T 39894 , F 120, S 8, H M 630349, I/A 18 ( 9.03.20).
23 de Diciembre de 2019Ceses/Dimisiones. Consejero: ALVAREZ GARCIA JUAN JOSE. Presidente: ALVAREZ GARCIA JUAN JOSE. Secretario:LAPASTORA TURPIN OSCAR. Nombramientos. Presidente: MARAZUELA AZPIROZ MONICA. Vicepresid.: LAPASTORA TURPIN
10 de Octubre de 2018Nombramientos. Auditor: GRANT THORNTON SLP. Datos registrales. T 36782 , F 199, S 8, H M 630349, I/A 16 ( 3.10.18).
03 de Agosto de 2018Nombramientos. Ent.Reg.Cont: SOCIEDAD DE GESTION DE LOS SISTEMAS DE REGISTRO CO. Modificaciones estatutarias.Derogaci贸n de Estatutos y aprobaci贸n de un nuevo texto de los mismos.. P谩gina web de la sociedad. Creaci贸n de la p谩gina webcorporativa: www.mistralpatrimonioinmobiliario.com. Datos registrales. T 36782 , F 195, S 8, H M 630349, I/A 15 (25.07.18).
05 de Junio de 2018Ceses/Dimisiones. Consejero: BENZAQUEN CHOCRON LEVY. SecreNoConsj: LAPASTORA TURPIN OSCAR. Nombramientos.Consejero: LAPASTORA TURPIN OSCAR. Secretario: LAPASTORA TURPIN OSCAR. Apoderado: LAPASTORA TURPIN OSCAR.Datos registrales. T 36782 , F 191, S 8, H M 630349, I/A 14 (28.05.18).
28 de Mayo de 2018Nombramientos. Auditor: GRANT THORNTON SLP. Datos registrales. T 36782 , F 191, S 8, H M 630349, I/A 13 (21.05.18).
25 de Mayo de 2018Ceses/Dimisiones. Auditor: AUDILEX AUDITORES SL. Datos registrales. T 36782 , F 191, S 8, H M 630349, I/A 12 (18.05.18).
14 de Febrero de 2018Modificaciones estatutarias. Fecha de Cierre de Ejercicio: 31/12. Datos registrales. T 35048 , F 191, S 8, H M 630349, I/A 11 (6.02.18).
09 de Enero de 2018Ampliaci贸n de capital. Suscrito: 3.235.500,00 Euros. Desembolsado: 3.235.500,00 Euros. Resultante Suscrito: 11.358.000,00 Euros.Resultante Desembolsado: 11.358.000,00 Euros. Datos registrales. T 35048 , F 189, S 8, H M 630349, I/A 10 (29.12.17).
05 de Diciembre de 2017Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: GARCIA TESO JAVIER. Nombramientos. SecreNoConsj: LAPASTORA TURPIN OSCAR.Consejero: MARAZUELA AZPIROZ MONICA;BENZAQUEN CHOCRON LEVY;ALVAREZ GARCIA JUAN JOSE. Presidente: ALVAREZGARCIA JUAN JOSE. Apoderado: MISTRAL INVESTMENT MANAGEMENT SL. Otros conceptos: Cambio del Organo deAdministraci贸n: Administrador 煤nico a Consejo de administraci贸n. Datos registrales. T 35048 , F 186, S 8, H M 630349, I/A 9(28.11.17).
27 de Marzo de 2017P茅rdida del caracter de unipersonalidad. Datos registrales. T 35048 , F 186, S 8, H M 630349, I/A 7 (16.03.17).
21 de Marzo de 2017Ampliaci贸n de capital. Suscrito: 8.062.500,00 Euros. Desembolsado: 8.062.500,00 Euros. Resultante Suscrito: 8.122.500,00 Euros.
16 de Marzo de 2017Nombramientos. Auditor: AUDILEX AUDITORES SL. Datos registrales. T 35048 , F 184, S 8, H M 630349, I/A 5 ( 1.03.17).