Buscador CIF Logo

Actos BORME Mivoriseint Sl

驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Mivoriseint Sl

Actos BORME Mivoriseint Sl - B61696977

Tenemos registrados 31 Actos BORME del Registro Mercantil de Madrid para Mivoriseint Sl con CIF B61696977

馃敊 Perfil de Mivoriseint Sl
馃洅 Comprar listado completo de Empresas de Madrid

Actos BORME de Mivoriseint Sl

31 de Agosto de 2023
Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: LANTERO MORENO ANDRES. Nombramientos. Adm. Mancom.: LANTERO MORENOANDRES;CARRE脩O ALVAREZ DANIEL. Modificaciones estatutarias. Se aprueba la refundici贸n de los estatutos.. Otrosconceptos: Cambio del Organo de Administraci贸n: Administrador 煤nico a Administradores mancomunados. Cambio dedenominaci贸n social. LANINVER GSC SL. Cambio de objeto social. Gesti贸n administrativa, laboral, fiscal y contable. Datosregistrales. T 34528 , F 225, S 8, H M 621044, I/A 19 (24.08.23).

08 de Marzo de 2023
Revocaciones. Apoderado: VAS PIRIS TAMARA;FIGUEROA NAVARRO PILAR. Nombramientos. Apoderado: ANGEL OGANDOJAVIER;FIGUEROA NAVARRO PILAR;VERDES MONTENEGRO ROLLAN PALOMA;CARPIO GARCIA LAURA;NOVILLO BAYANOCRISTINA. Datos registrales. T 34528 , F 223, S 8, H M 621044, I/A 18 ( 1.03.23).

04 de Enero de 2023
Revocaciones. Apoderado: GINES GOMEZ ALVARO. Datos registrales. T 34528 , F 223, S 8, H M 621044, I/A 17 (28.12.22).

03 de Noviembre de 2022
Nombramientos. Apoderado: CALVO ANGUIS MARIA GLORIA;GARCIA BELDA MARIA AUXILIADORA;MONTESINOSBALLESTEROS LUIS;LASSALETTA GONZALEZ JUAN MARIA;CRESPO MOTILLA SOLEDAD;VAS PIRIS TAMARA;GARCIAGARCIA MARIA DEL PILAR;ARGILA GARCIA PILAR;FIGUEROA NAVARRO PILAR;BADIOLA MU脩OZ MARIA ARANZAZU;GINESGOMEZ ALVARO. Datos registrales. T 34528 , F 221, S 8, H M 621044, I/A 16 (26.10.22).

26 de Octubre de 2022
Revocaciones. Apoderado: VEGA DE CELIS ANA;CALVO ANGUIS GLORIA;GARCIA BELDA MARIA AUXILIADORA;MONTESINOSBALLESTEROS LUIS;LASSALETTA GONZALEZ JUAN MARIA;RANZ HERRANZ RAUL;VAS PIRIS TAMARA;FIGUEROA NAVARROPILAR;BADIOLA MU脩OZ MARIA ARANZAZU;GINES GOMEZ ALVARO. Apo.Man.Soli: CRESPO MOTILLA SOLEDAD. Apoderado:ARGILA GARCIA PILAR. Datos registrales. T 34528 , F 221, S 8, H M 621044, I/A 15 (19.10.22).

12 de Julio de 2022
Revocaciones. Apoderado: SANCHEZ RUIZ ANGELA. Nombramientos. Apoderado: ARGILA GARCIA PILAR. Datos registrales.T 34528 , F 220, S 8, H M 621044, I/A 14 ( 5.07.22).

03 de Enero de 2022
Revocaciones. Apoderado: ANGEL OGANDO JAVIER. Nombramientos. Apo.Man.Soli: CRESPO MOTILLA SOLEDAD. Datosregistrales. T 34528 , F 219, S 8, H M 621044, I/A 13 (27.12.21).

22 de Julio de 2021
Nombramientos. Apoderado: VEGA DE CELIS ANA. Datos registrales. T 34528 , F 217, S 8, H M 621044, I/A 9 (15.07.21).

Nombramientos. Apoderado: OSMA HERNANDEZ JORGE. Datos registrales. T 34528 , F 217, S 8, H M 621044, I/A 10 (15.07.21).

Nombramientos. Apoderado: CALVO ANGUIS GLORIA;GARCIA BELDA MARIA AUXILIADORA;MONTESINOS BALLESTEROSLUIS;LASSALETTA GONZALEZ JUAN MARIA;RANZ HERRANZ RAUL;VAS PIRIS TAMARA;ANGEL OGANDO JAVIER;SANCHEZRUIZ ANGELA;FIGUEROA NAVARRO PILAR;BADIOLA MU脩OZ MARIA ARANZAZU;GINES GOMEZ ALVARO. Datos registrales. T34528 , F 218, S 8, H M 621044, I/A 11 (15.07.21).

Revocaciones. Apo.Sol.: GARCIA BELDA MARIA;RANZ HERRANZ RAUL. Apo.Manc.: RANZ HERRANZ RAUL;SANCHEZ RUIZANGELA. Apo.Sol.: SANCHEZ RUIZ ANGELA;VAS PIRIS TAMARA. Apo.Manc.: VAS PIRIS TAMARA;GARCIA DE LA FUENTE ROSAMARIA. Apo.Sol.: GARCIA DE LA FUENTE ROSA MARIA;FIGUEROA NAVARRO PILAR. Apo.Manc.: FIGUEROA NAVARROPILAR;BADIOLA MU脩OZ MARIA ARANZAZU. Apo.Sol.: BADIOLA MU脩OZ MARIA ARANZAZU;GINES GOMEZ ALVARO. Apo.Manc.:GINES GOMEZ ALVARO. Datos registrales. T 34528 , F 219, S 8, H M 621044, I/A 12 (15.07.21).

07 de Octubre de 2020
Nombramientos. Apo.Sol.: GARCIA BELDA MARIA;RANZ HERRANZ RAUL. Apo.Manc.: RANZ HERRANZ RAUL;SANCHEZ RUIZANGELA. Apo.Sol.: SANCHEZ RUIZ ANGELA;VAS PIRIS TAMARA. Apo.Manc.: VAS PIRIS TAMARA;GARCIA DE LA FUENTE ROSAMARIA. Apo.Sol.: GARCIA DE LA FUENTE ROSA MARIA;FIGUEROA NAVARRO PILAR. Apo.Manc.: FIGUEROA NAVARROPILAR;BADIOLA MU脩OZ MARIA ARANZAZU. Apo.Sol.: BADIOLA MU脩OZ MARIA ARANZAZU;GINES GOMEZ ALVARO. Apo.Manc.:GINES GOMEZ ALVARO. Datos registrales. T 34528 , F 216, S 8, H M 621044, I/A 8 (30.09.20).

06 de Octubre de 2020
Revocaciones. Apo.Man.Soli: BENEITEZ PANIZO BEATRIZ;SANCHEZ RUIZ ANGELA;VAS PIRIS TAMARA;ROSA MARIA GARCIADE LA FUENTE;FIGUEROA NAVARRO PILAR;BADIOLA MU脩OZ MARIA ARANZAZU;GINES GOMEZ ALVARO. Datos registrales.T 34528 , F 215, S 8, H M 621044, I/A 7 (29.09.20).

21 de Enero de 2020
Nombramientos. Apo.Man.Soli: BENEITEZ PANIZO BEATRIZ;SANCHEZ RUIZ ANGELA;VAS PIRIS TAMARA;ROSA MARIAGARCIA DE LA FUENTE;FIGUEROA NAVARRO PILAR;BADIOLA MU脩OZ MARIA ARANZAZU;GINES GOMEZ ALVARO. Datosregistrales. T 34528 , F 214, S 8, H M 621044, I/A 6 (14.01.20).

10 de Septiembre de 2019
Nombramientos. Apoderado: COFRADES ACEBES OLGA. Datos registrales. T 34528 , F 214, S 8, H M 621044, I/A 5 ( 3.09.19).

20 de Noviembre de 2018
Ceses/Dimisiones. Consejero: CALVO ANGUIS GLORIA. Secretario: CALVO ANGUIS GLORIA. Consejero: HOLZBACHER VALEROENRIC. Presidente: HOLZBACHER VALERO ENRIC. Co.De.Ma.So: HOLZBACHER VALERO ENRIC. Consejero: LANTEROMORENO ANDRES. Co.De.Ma.So: LANTERO MORENO ANDRES. Nombramientos. Adm. Unico: LANTERO MORENO ANDRES.Modificaciones estatutarias. SE MODIFICAN LOS ARTICULOS 11, 15, 16, 17, 18, 19, 20 Y 24 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES,EN LO RELATIVO AL ORGANO DE ADMINISTRACION. Otros conceptos: Cambio del Organo de Administraci贸n: Consejo deadministraci贸n a Administrador 煤nico. Datos registrales. T 34528 , F 213, S 8, H M 621044, I/A 4 (13.11.18).

19 de Abril de 2018
Declaraci贸n de unipersonalidad. Socio 煤nico: LANINVER S H C SL. Ceses/Dimisiones. Consejero: MIREN VOISINMAXIMO;MIRET VOISIN PEDRO LUIS. Datos registrales. T 34528 , F 213, S 8, H M 621044, I/A 3 ( 9.04.18).

15 de Junio de 2016
Modificaciones estatutarias. Art铆culo de los estatutos: 4. Domicilio social y web corporativa.-. Cambio de domicilio social. C/VELAZQUEZ 157 5& (MADRID). Datos registrales. T 34528 , F 213, S 8, H M 621044, I/A 2 ( 8.06.16).

20 de Enero de 2016
Revocaciones. APODERADO: AVILA MAGRI脩A LLUIS MARIA;JANSA MORATO FINA;JANSA MORATO FINA;JANSA MORATOFINA;VELASCO PI脩ERA ALFONSO;CASTELLET GRAU PEDRO;JANSA MORATO FINA;BARRO LABRADOR CARLOS;MIRET

12 de Diciembre de 2014
Revocaciones. CONSEJERO: AMELA AYORA ANTONIO. SECRETARIO: AMELA AYORA ANTONIO. Nombramientos.CONSEJERO: CALVO ANGUIS GLORIA. SECRETARIO: CALVO ANGUIS GLORIA. Datos registrales. T 38918 , F 199, S 8, H B183117, I/A 20 ( 3.12.14).

13 de Agosto de 2014
Revocaciones. CONSEJERO: MALLO CARCIOFFI JORGE. CONS. DELEG.: AMELA AYORA ANTONIO. PRESIDENTE: MALLOCARCIOFFI JORGE. Nombramientos. CONSEJERO: HOLZBACHER VALERO ENRIC. PRESIDENTE: HOLZBACHER VALEROENRIC. CONS.DEL.M/S: HOLZBACHER VALERO ENRIC;LANTERO MORENO ANDRES. Datos registrales. T 38918 , F 198, S 8, HB 183117, I/A 19 ( 4.08.14).

25 de Abril de 2014
Revocaciones. APODERADO: VELASCO PI脩ERA ALFONSO. Nombramientos. APODERAD.SOL: MONTFORT GUASCHIGNACIO. APOD.SOL/MAN: ROMEU VENTURA JAUME. Datos registrales. T 38918 , F 197, S 8, H B 183117, I/A 18 (16.04.14).

30 de Agosto de 2013
Revocaciones. PRESIDENTE: MIRET VOISIN MAXIMO. Nombramientos. PRESIDENTE: MALLO CARCIOFFI JORGE. Datosregistrales. T 38918 , F 197, S 8, H B 183117, I/A 17 (22.08.13).

08 de Agosto de 2011
Revocaciones. SECRETARIO: MIRET VOISIN PEDRO LUIS. CONS. DELEG.: MIRET VOISIN PEDRO LUIS. Nombramientos.CONSEJERO: AMELA AYORA ANTONIO. SECRETARIO: AMELA AYORA ANTONIO. CONS. DELEG.: AMELA AYORA ANTONIO.Datos registrales. T 38918 , F 195, S 8, H B 183117, I/A 15 (27.07.11).

Nombramientos. APODERADO: CASTELLET GRAU PEDRO;VELASCO PI脩ERA ALFONSO;JANSA MORATO FINA;BARROLABRADOR CARLOS;MIRET CUDIE PERE LLUIS;CLAVER MORENO NURIA. Datos registrales. T 38918 , F 195, S 8, H B 183117,I/A 16 (27.07.11).

29 de Marzo de 2011
Revocaciones. APODERADO: ISERN TORRAS JOAN;JANSA MORATO FINA. Datos registrales. T 38918 , F 195, S 8, H B183117, I/A 14 (17.03.11).

28 de Febrero de 2011
Nombramientos. APODERADO: ISERN TORRAS JOAN;JANSA MORATO FINA. Datos registrales. T 38918 , F 193, S 8, H B183117, I/A 13 (16.02.11).

10 de Febrero de 2011
Nombramientos. APODERADO: JANSA MORATO FINA;VELASCO PI脩ERA ALFONSO. Datos registrales. T 38918 , F 192, S 8, HB 183117, I/A 12 (27.01.11).

27 de Enero de 2011
Ampliaci贸n de capital. Capital: 117.796,00 Euros. Resultante Suscrito: 454.957,00 Euros. Datos registrales. T 38918 , F 192, S 8,H B 183117, I/A 11 (14.01.11).

12 de Enero de 2011
Revocaciones. APODERADO: ISERN TORRAS JOAN. Datos registrales. T 38918 , F 191, S 8, H B 183117, I/A 10 (29.12.10).

23 de Diciembre de 2009
Revocaciones. CONSEJERO: ALONSO ALONSO LUIS;LANTERO ROZPIDE JORGE. Nombramientos. CONSEJERO: MALLOCARCIOFFI JORGE;LANTERO MORENO ANDRES. Datos registrales. T 38918 , F 191, S 8, H B 183117, I/A 9 (11.12.09).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n