Actos BORME de Mixer & Pack Sl
13 de Diciembre de 2022Nombramientos. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 651 , F 192, S 8, H GU 11544, I/A 5 (30.11.22).
26 de Mayo de 2022Ceses/Dimisiones. Presidente: GOMEZ LOECHES GREGORIO. Secretario: GOMEZ LOECHES AGUSTIN. Revocaciones.Apo.Man.Soli: ALBARRAL SILES TERESA. Nombramientos. Presidente: GOMEZ LOECHES AGUSTIN. Secretario: GOMEZLOECHES RODOLFO. Datos registrales. T 651 , F 192, S 8, H GU 11544, I/A 4 (17.05.22).
24 de Diciembre de 2021Reelecciones. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 651 , F 192, S 8, H GU 11544, I/A 3 (13.12.21).
27 de Septiembre de 2021Cambio de domicilio social. C/ LAS LARGAS 2 (CABANILLAS DEL CAMPO). Datos registrales. T 651 , F 192, S 8, H GU 11544,I/A 2 ( 9.09.21).
08 de Marzo de 2021Otros conceptos: Resoluci贸n de la Comisi贸n Delegada del Gobierno de Asuntos Econ贸micos de 18 de diciembre de 2020, relativa ala concesi贸n de incentivos regionales para la realizaci贸n del proyecto del expediente GU/254/P03. Datos registrales. T 8606 , F 109,S 8, H M 138544, I/A 1-M ( 1.03.21).
08 de Octubre de 2020Reelecciones. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 17858 , F 221, S 8, H M 138544, I/A 26 ( 1.10.20).
25 de Junio de 2019Nombramientos. Apo.Manc.: MEDIAVILLA CESTEROS JUAN FRANCISCO. Apo.Sol.: MEDIAVILLA CESTEROS JUANFRANCISCO. Datos registrales. T 17858 , F 219, S 8, H M 138544, I/A 25 (18.06.19).
04 de Abril de 2019Modificaciones estatutarias. Modificaci贸n de la totalidad de los art铆culos de los estatutos sociales. Datos registrales. T 17858 , F217, S 8, H M 138544, I/A 24 (28.03.19).
22 de Diciembre de 2017Nombramientos. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 17858 , F 216, S 8, H M 138544, I/A 23 (14.12.17).
16 de Febrero de 2017Nombramientos. Secretario: GOMEZ LOECHES AGUSTIN. Apo.Man.Soli: GOMEZ LOECHES GREGORIO;GOMEZ LOECHESRODOLFO;GOMEZ LOECHES CAROLINA;GOMEZ LOECHES AGUSTIN;MOSQUERA TORRES JUAN-MANUEL;ALBARRAL SILESTERESA. Apo.Sol.: GARCIA EXPOSITO LORENZO. Datos registrales. T 17858 , F 214, S 8, H M 138544, I/A 22 ( 9.02.17).
01 de Febrero de 2017Ceses/Dimisiones. Consejero: GOMEZ LOECHES CELSO. Secretario: GOMEZ LOECHES CELSO. Cons.Del.Sol: GOMEZLOECHES CELSO. Datos registrales. T 17858 , F 214, S 8, H M 138544, I/A 21 (24.01.17).
26 de Diciembre de 2014Nombramientos. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 17858 , F 214, S 8, H M 138544,I/A 20 (18.12.14).
30 de Marzo de 2012Nombramientos. Auditor: INTER-AUDI SLP. Datos registrales. T 17858 , F 214, S 8, H M 138544, I/A 19 (20.03.12).
09 de Marzo de 2012Ceses/Dimisiones. Consejero: GOMEZ DE VARGAS RODOLFO. Presidente: GOMEZ DE VARGAS RODOLFO. Con.Delegado:GOMEZ DE VARGAS RODOLFO. Consejero: GOMEZ LOECHES RODOLFO;GOMEZ LOECHES CELSO;FRANCO BLANCH LUIS.Secretario: GOMEZ LOECHES CELSO. Consejero: GOMEZ LOECHES GREGORIO. Revocaciones. Apoderado: LALANDA PIJOANEDUARDO;GOMEZ LOECHES CELSO;GOMEZ LOECHES RODOLFO;GOMEZ LOECHES CELSO;SALAMANQUES MAESTROADOLFO. Nombramientos. Consejero: GOMEZ LOECHES RODOLFO;GOMEZ LOECHES CELSO;GOMEZ LOECHESGREGORIO;GOMEZ LOECHES CAROLINA;GOMEZ LOECHES AGUSTIN. Presidente: GOMEZ LOECHES GREGORIO. Secretario:GOMEZ LOECHES CELSO. Cons.Del.Sol: GOMEZ LOECHES CELSO. Datos registrales. T 17858 , F 213, S 8, H M 138544, I/A 18(28.02.12).
25 de Noviembre de 2011Reelecciones. Auditor: ODOS AUDITORES SL. Datos registrales. T 17858 , F 213, S 8, H M 138544, I/A 17 (15.11.11).