Actos BORME de Mizengarden Sl
14 de Noviembre de 2023Disoluci贸n. Fusion. Extinci贸n. Datos registrales. T 11267, L 8545, F 63, S 8, H V 205124, I/A 9 ( 6.11.23).
13 de Noviembre de 2023Revocaciones. Apoderado: GARRIGUES CALDERON BELEN;CORDOBA MONTES MARIA JOSE;OROZCO LAW RICHARDMICHAEL;SANTOS TUDANCA MARIA-TERESA;GUISADO TRUEBA EVA;NAVARRO RODRIGUEZ DANIEL;ANGOS MARTINEZMARIA PALOMA;MU脩OZ UBEDA ALVARO;RODRIGUEZ DE SANTOS ANTONIO;OLIVES CANTALEJO DAVID;ROMERO SANCHEZCRISTINA;INES VERDA JUAN;FERNANDEZ ALGABA CARLOS. Datos registrales. T 11267, L 8545, F 63, S 8, H V 205124, I/A 8 (3.11.23).
26 de Septiembre de 2023Fe de erratas: Rectificada la referencia 05646222022 del BORME 243 de 23/12/222 en cuanto a la fecha del otorgamiento del poderque fue conferido el 26/09/2022 y no el 26/10/2022. Datos registrales. T 11194, L 8472, F 224, S 8, H V 205124, I/A 3 (16.12.22).
23 de Diciembre de 2022Nombramientos. Apoderado: GALLARDO MARTINEZ FERNANDO. Datos registrales. T 11194, L 8472, F 224, S 8, H V 205124,I/A 3 (16.12.22).
Nombramientos. Apoderado: PIQUER SANCHIS ROSA MARIA. Datos registrales. T 11267, L 8545, F 61, S 8, H V 205124, I/A 4(16.12.22).
Nombramientos. Apoderado: FORSTER II THOMAS J. Datos registrales. T 11267, L 8545, F 63, S 8, H V 205124, I/A 5 (16.12.22).
Nombramientos. Apoderado: CUBILLO PERCY. Datos registrales. T 11267, L 8545, F 63, S 8, H V 205124, I/A 6 (16.12.22).
24 de Junio de 2022Cambio de domicilio social. AVDA DEL PROGRES 2 - POLIGONO INDUSTRIAL CAMPO ANI (PUZOL). Datos registrales. T11194, L 8472, F 224, S 8, H V 205124, I/A 2 (17.06.22).
02 de Junio de 2022Fe de erratas: Se public贸 por error en la inscripci贸n 1陋 el nombramiento de 3 administradores 煤nicos, siendo lo correctoadministradores solidarios. Datos registrales. T 43052 , F 1, S 8, H M 760864, I/A 1 ( 3.02.22).
Declaraci贸n de unipersonalidad. Socio 煤nico: PROTECTIVE INDUSTRIAL PRODUCTS INC. Datos registrales. T 43052 , F 2, S8, H M 760864, I/A 2 (26.05.22).
Nombramientos. Apoderado: GARRIGUES CALDERON BELEN;CORDOBA MONTES MARIA JOSE;OROZCO LAW RICHARDMICHAEL;SANTOS TUDANCA MARIA-TERESA;GUISADO TRUEBA EVA;NAVARRO RODRIGUEZ DANIEL;ANGOS MARTINEZMARIA PALOMA;MU脩OZ UBEDA ALVARO;RODRIGUEZ DE SANTOS ANTONIO;OLIVES CANTALEJO DAVID;ROMERO SANCHEZCRISTINA;INES VERDA JUAN;FERNANDEZ ALGABA CARLOS. Datos registrales. T 43052 , F 2, S 8, H M 760864, I/A 3 (26.05.22).
Ceses/Dimisiones. Adm. Solid.: GARRIGUES CALDERON BELEN;OLIVES CANTALEJO DAVID;RODRIGUEZ DE SANTOSANTONIO. Nombramientos. Adm. Solid.: MILOT JR JOSEPH ANTHONY;MILOT REN BRIDGET NICOLE. Datos registrales. T43052 , F 3, S 8, H M 760864, I/A 4 (26.05.22).
10 de Febrero de 2022Constituci贸n. Comienzo de operaciones: 25.01.22. Objeto social: La constituci贸n, participaci贸n por si misma o de forma indirecta enla gesti贸n y control de otras empresas y sociedades; la adquisici贸n , enajenaci贸n, tenencia y explotaci贸n de bienes inmuebles;veh铆culos de todo tipo, 茅poca y lugar; m谩quinas de todo tipo; pinturas de todo tipo y 茅poca; esculturas d. Domicilio: C/ PRINCIPE DEVERGARA 112 (MADRID). Capital: 3.000,00 Euros. Nombramientos. Adm. Unico: GARRIGUES CALDERON BELEN;OLIVESCANTALEJO DAVID;RODRIGUEZ DE SANTOS ANTONIO. Datos registrales. T 43052 , F 1, S 8, H M 760864, I/A 1 ( 3.02.22).