Buscador CIF Logo

Actos BORME Mnemo Evolution & Integration Services Sa

驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Mnemo Evolution & Integration Services Sa

Actos BORME Mnemo Evolution & Integration Services Sa - A82958075

Tenemos registrados 59 Actos BORME del Registro Mercantil de Madrid para Mnemo Evolution & Integration Services Sa con CIF A82958075

馃敊 Perfil de Mnemo Evolution & Integration Services Sa
馃洅 Comprar listado completo de Empresas de Madrid

Actos BORME de Mnemo Evolution & Integration Services Sa

18 de Octubre de 2022
Nombramientos. Apoderado: SANCHEZ ALONSO RAUL. Datos registrales. T 39883 , F 222, S 8, H M 278751, I/A 84 (10.10.22).

12 de Mayo de 2022
Revocaciones. Apoderado: CAYUPAN EPUL MARIO. Datos registrales. T 39883 , F 221, S 8, H M 278751, I/A 83 ( 5.05.22).

18 de Febrero de 2022
Ceses/Dimisiones. SecreNoConsj: VASSALLO Y MORENO ALBERTO. Fe de erratas: Se omiti贸 por error en la inscripci贸n 82 lapublicaci贸n del cese como secretario no consejero de VASSALLO Y MORENO ALBERTO. Datos registrales. T 39883 , F 221, S 8, HM 278751, I/A 82 ( 7.02.22).

14 de Febrero de 2022
Ceses/Dimisiones. Consejero: VICENT PECHARROMAN ANTONIO;VICENT FERNANDEZ CARLOS;VICENT FERNANDEZ LAURA.Presidente: VICENT PECHARROMAN ANTONIO. Con.Delegado: VICENT PECHARROMAN ANTONIO. Nombramientos. Auditor:ATENEA AUDITORES SL. Adm. Unico: VICENT PECHARROMAN ANTONIO. Aud.C.Con.: ATENEA AUDITORES SL.Modificaciones estatutarias. MODIFICADO EL ARTICULO 17 DE LOS ESTATUTOS. . Otros conceptos: Cambio del Organo deAdministraci贸n: Consejo de administraci贸n a Administrador 煤nico. Datos registrales. T 39883 , F 221, S 8, H M 278751, I/A 82 (7.02.22).

29 de Marzo de 2021
Reelecciones. Auditor: ADADE AUDITORES SA. Aud.C.Con.: ADADE AUDITORES SA. Datos registrales. T 39883 , F 221, S 8, HM 278751, I/A 81 (22.03.21).

22 de Junio de 2020
Reelecciones. Consejero: VICENT PECHARROMAN ANTONIO;VICENT FERNANDEZ CARLOS;VICENT FERNANDEZ LAURA.Presidente: VICENT PECHARROMAN ANTONIO. Con.Delegado: VICENT PECHARROMAN ANTONIO. Datos registrales. T 39883 ,F 220, S 8, H M 278751, I/A 80 (15.06.20).

27 de Marzo de 2020
Nombramientos. Aud.C.Con.: ADADE AUDITORES SA. Reelecciones. Auditor: ADADE AUDITORES SA. Datos registrales. T39883 , F 220, S 8, H M 278751, I/A 79 (22.03.20).

11 de Diciembre de 2019
Revocaciones. Apoderado: CUEVAS DE MIGUEL JOSE CARLOS. Datos registrales. T 39883 , F 220, S 8, H M 278751, I/A 78 (2.12.19).

03 de Octubre de 2019
Modificaciones estatutarias. 1. Nuevo texto refundido de los estatutos sociales.. Cambio de domicilio social. C/ CARDENALMARCELO SPINOLA N潞14, PLANTA 5陋 (MADRID). P谩gina web de la sociedad. Creaci贸n de la p谩gina web corporativa:www.areadegobierno.es/A82958075. Datos registrales. T 28863 , F 220, S 8, H M 278751, I/A 77 (26.09.19).

16 de Mayo de 2019
Nombramientos. Apoderado: DEL CASTILLO SANCHEZ ANGEL. Datos registrales. T 28863 , F 219, S 8, H M 278751, I/A 76 (8.05.19).

14 de Mayo de 2019
Revocaciones. Apoderado: GARRIDO VINUESA DANIEL. Datos registrales. T 28863 , F 219, S 8, H M 278751, I/A 75 ( 7.05.19).

25 de Marzo de 2019
Revocaciones. Apoderado: MONTALBAN DE VARGAS JOAQUIN;MONTALBAN DE VARGAS JOAQUIN;MONTALBAN DE VARGASJOAQUIN. Datos registrales. T 28863 , F 217, S 8, H M 278751, I/A 73 (18.03.19).

Nombramientos. Apoderado: CUEVAS DE MIGUEL JOSE CARLOS. Datos registrales. T 28863 , F 217, S 8, H M 278751, I/A 74(18.03.19).

17 de Abril de 2017
Nombramientos. Aud.Supl.C.C: ADADE AUDITORES SA. Reelecciones. Auditor: ADADE AUDITORES SA. Datos registrales. T28863 , F 216, S 8, H M 278751, I/A 71 ( 5.04.17).

Modificaciones estatutarias. 17. Administraci贸n y Representacion.-. Datos registrales. T 28863 , F 217, S 8, H M 278751, I/A 72 (5.04.17).

28 de Octubre de 2016
Revocaciones. Apoderado: MORALES POLO JOAQUIN;MORALES POLO JOAQUIN. Datos registrales. T 28863 , F 215, S 8, H M278751, I/A 69 (20.10.16).

Nombramientos. Apoderado: SANCHEZ ALONSO RAUL. Datos registrales. T 28863 , F 215, S 8, H M 278751, I/A 70 (20.10.16).

18 de Febrero de 2016
Nombramientos. Apoderado: MORALES POLO JOAQUIN. Datos registrales. T 28863 , F 214, S 8, H M 278751, I/A 68 (10.02.16).

15 de Febrero de 2016
Revocaciones. Apoderado: MELIA SORIANO ENRIQUE. Datos registrales. T 28863 , F 213, S 8, H M 278751, I/A 65 ( 8.02.16).

Nombramientos. Apoderado: MONTALBAN DE VARGAS JOAQUIN. Datos registrales. T 28863 , F 213, S 8, H M 278751, I/A 66 (8.02.16).

Nombramientos. Apoderado: MORALES POLO JOAQUIN. Datos registrales. T 28863 , F 213, S 8, H M 278751, I/A 67 ( 8.02.16).

12 de Enero de 2016
Ceses/Dimisiones. Secretario: JIMENEZ GARCIA ALZORRIZ IGNACIO. Nombramientos. SecreNoConsj: VASSALLO Y MORENOALBERTO. Datos registrales. T 28863 , F 212, S 8, H M 278751, I/A 64 (30.12.15).

11 de Enero de 2016
Fe de erratas: Se publico por error en la inscripci贸n 63 un desembolso de capital de 370.000,00 cuando correspondia 375.000,00.Datos registrales. T 28863 , F 212, S 8, H M 278751, I/A 63 (17.12.15).

28 de Diciembre de 2015
Ampliaci贸n de capital. Suscrito: 375.000,00 Euros. Desembolsado: 370.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 2.008.330,00 Euros.Resultante Desembolsado: 2.003.330,00 Euros. Datos registrales. T 28863 , F 212, S 8, H M 278751, I/A 63 (17.12.15).

10 de Diciembre de 2015
Nombramientos. Auditor: ADADE AUDITORES SA. Datos registrales. T 28863 , F 212, S 8, H M 278751, I/A 62 (30.11.15).

03 de Noviembre de 2015
Nombramientos. Apoderado: MONTALBAN DE VARGAS JOAQUIN. Datos registrales. T 28863 , F 211, S 8, H M 278751, I/A 60(26.10.15).

Revocaciones. Apoderado: MELIA SORIANO ENRIQUE. Nombramientos. Apoderado: MELIA SORIANO ENRIQUE. Datosregistrales. T 28863 , F 211, S 8, H M 278751, I/A 61 (26.10.15).

20 de Febrero de 2015
Revocaciones. Apoderado: GARCIA MARTINEZ LUIS IGNACIO;IGLESIAS RODRIGUEZ JOSE ANTONIO;IGLESIAS RODRIGUEZJOSE ANTONIO;IGLESIAS RODRIGUEZ JOSE-ANTONIO. Datos registrales. T 28863 , F 210, S 8, H M 278751, I/A 58 (12.02.15).

05 de Febrero de 2015
Nombramientos. Apoderado: MONTALBAN DE VARGAS JOAQUIN. Datos registrales. T 28863 , F 210, S 8, H M 278751, I/A 57(28.01.15).

28 de Enero de 2015
Ceses/Dimisiones. Consejero: VICENT PECHARROMAN ANTONIO. Presidente: VICENT PECHARROMAN ANTONIO.Con.Delegado: VICENT PECHARROMAN ANTONIO. Consejero: GARCIA LAHIGUERA CAMBRA FERNANDO;VICENT FERNANDEZJORGE;GARCIA MARTINEZ LUIS IGNACIO. Nombramientos. Consejero: VICENT PECHARROMAN ANTONIO;VICENTFERNANDEZ CARLOS;VICENT FERNANDEZ LAURA. Presidente: VICENT PECHARROMAN ANTONIO. Con.Delegado: VICENTPECHARROMAN ANTONIO. Datos registrales. T 28863 , F 209, S 8, H M 278751, I/A 56 (20.01.15).

25 de Noviembre de 2014
Nombramientos. Apoderado: MELIA SORIANO ENRIQUE. Datos registrales. T 28863 , F 208, S 8, H M 278751, I/A 55 (17.11.14).

Nombramientos. Apoderado: GARRIDO VINUESA DANIEL. Datos registrales. T 28863 , F 208, S 8, H M 278751, I/A 54 (17.11.14).

06 de Junio de 2014
Revocaciones. Apoderado: FLORES DELGADO ALVARO. Datos registrales. T 28863 , F 208, S 8, H M 278751, I/A 53 (29.05.14).

04 de Junio de 2014
Nombramientos. Apoderado: IGLESIAS RODRIGUEZ JOSE-ANTONIO. Datos registrales. T 28863 , F 207, S 8, H M 278751, I/A52 (28.05.14).

14 de Marzo de 2014
Revocaciones. Apoderado: CORDOBA BUENO MIGUEL;CORDOBA BUENO MIGUEL. Datos registrales. T 28863 , F 206, S 8, HM 278751, I/A 49 ( 5.03.14).

Nombramientos. Apoderado: IGLESIAS RODRIGUEZ JOSE ANTONIO. Datos registrales. T 28863 , F 207, S 8, H M 278751, I/A50 ( 5.03.14).

Nombramientos. Apoderado: IGLESIAS RODRIGUEZ JOSE ANTONIO. Datos registrales. T 28863 , F 207, S 8, H M 278751, I/A51 ( 5.03.14).

21 de Enero de 2013
Fusi贸n por absorci贸n. Sociedades absorbidas: IRONWALL STRATEGIC SECURITY SYSTEMS SA. Datos registrales. T 28863 , F203, S 8, H M 278751, I/A 48 (11.01.13).

11 de Enero de 2013
Ampliaci贸n de capital. Suscrito: 400.000,00 Euros. Desembolsado: 400.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 1.633.330,00 Euros.Resultante Desembolsado: 1.633.330,00 Euros. Modificaciones estatutarias. Art铆culo de los estatutos: 5. Capital.-. Datosregistrales. T 28863 , F 202, S 8, H M 278751, I/A 47 ( 3.01.13).

30 de Octubre de 2012
Revocaciones. Apoderado: ESTEBARANZ FEIJOO LAURA;GARCIA LAHIGUERA CAMBRA FERNANDO;BRAVO BAUTISTARAMON;RAMIREZ MOLINA ALVARO;BRAVO BAUTISTA RAMON;MU脩OZ FERNANDEZ LUIS. Datos registrales. T 28863 , F 202,S 8, H M 278751, I/A 45 (18.10.12).

Nombramientos. Apoderado: CORDOBA BUENO MIGUEL. Datos registrales. T 28863 , F 202, S 8, H M 278751, I/A 46 (18.10.12).

23 de Octubre de 2012
Ampliaci贸n de capital. Suscrito: 200.000,00 Euros. Desembolsado: 200.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 1.233.330,00 Euros.Resultante Desembolsado: 1.233.330,00 Euros. Datos registrales. T 28863 , F 201, S 8, H M 278751, I/A 44 (10.10.12).

05 de Septiembre de 2012
Nombramientos. Apoderado: CORDOBA BUENO MIGUEL. Datos registrales. T 28863 , F 201, S 8, H M 278751, I/A 42 (14.08.12).

Revocaciones. Apoderado: BRAVO BAUTISTA RAMON;BRAVO BAUTISTA RAMON. Datos registrales. T 28863 , F 201, S 8, H M278751, I/A 43 (14.08.12).

01 de Agosto de 2012
Nombramientos. Aud.C.Con.: AUREN AUDITORES MADRID SL. Datos registrales. T 28863 , F 200, S 8, H M 278751, I/A 41(20.07.12).

31 de Julio de 2012
Nombramientos. Auditor: AUREN AUDITORES MADRID SL. Datos registrales. T 28863 , F 200, S 8, H M 278751, I/A 40(19.07.12).

24 de Enero de 2012
Ceses/Dimisiones. Consejero: IZAGUIRRE GUERRICACOITIA I脩IGO. Nombramientos. Consejero: VICENT FERNANDEZJORGE;GARCIA MARTINEZ LUIS IGNACIO. Datos registrales. T 28863 , F 200, S 8, H M 278751, I/A 39 (13.01.12).

10 de Enero de 2012
Otros conceptos: LA SOCIEDAD " MNEMO EVOLUTION & INTEGRATION SERVICES SA " ABSORBE A LA ENTIDADDOMICILIADA EN LEON DENOMINADA " INSTITUTO TECNOLOGICO DE LEON SA " , ADQUIRIENDO SU PATRIMONIO .- Fusi贸npor absorci贸n. Sociedades absorbidas: INSTITUTO TECNOLOGICO DE LEON SA. Datos registrales. T 28863 , F 195, S 8, H M278751, I/A 38 (26.12.11).

16 de Agosto de 2011
Nombramientos. Apoderado: MU脩OZ FERNANDEZ LUIS. Datos registrales. T 21147 , F 119, S 8, H M 278751, I/A 36 ( 3.08.11).

Nombramientos. Apoderado: GARCIA MARTINEZ LUIS IGNACIO;VICENT FERNANDEZ JORGE. Datos registrales. T 21147 , F120, S 8, H M 278751, I/A 37 ( 4.08.11).

12 de Julio de 2011
Otros conceptos: ABSORBENTE: "MNEMO EVOLUTION & INTEGRATION SERVICES SA", DOMICILIADA EN MADRID, P潞 DE LACASTELLANA N潞 135, PTA.16. INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL DE MADRID, AL TOMO 16397, FOLIO 3, HOJA M-278751.ABSORBIDA: " INSTITUTO TECNOLOGICO DE LEON SA", DOMICILIO EN LEON, AVDA. JOSE AGUADO N 41. INSCRITAEN EL REGISTRO MERCANTIL DE LEON AL TOMO 1106, SECCION 8&, FOLIO 80, HOJA LE-17866. Datos registrales. T 16397 ,F 202, S 8, H M 278751, I/A 1-M ( 1.07.11).

13 de Mayo de 2011
Cambio de domicilio social. PASEO DE LA CASTELLANA 135 16 (MADRID). Datos registrales. T 21147 , F 119, S 8, H M278751, I/A 35 ( 3.05.11).

18 de Abril de 2011
Nombramientos. Apoderado: BRAVO BAUTISTA RAMON. Datos registrales. T 21147 , F 119, S 8, H M 278751, I/A 34 ( 6.04.11).

11 de Octubre de 2010
Nombramientos. Apoderado: RAMIREZ MOLINA ALVARO. Datos registrales. T 21147 , F 118, S 8, H M 278751, I/A 32 (30.09.10).

Nombramientos. Apoderado: CAYUPAN EPUL MARIO. Otros conceptos: AUTORIZAR LA CREACION DE UNA AGENCIA DE LACOMPA脩IA EN CHILE,QUE TENDRA LA DENOMINACION DE "MNEMO EVOLUTION & INTEGRATION SERVICES, AGENCIA ENCHILE",SU CAPITAL ASCENDERA A 10.000EUROS Y SU OBJETO SOCIAL O GIRO CONSISTIRA EN LA PRESTACIONDE TODOTIPO DE SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO A CLIENTES. Datos registrales. T 21147 , F 118, S 8, H M 278751, I/A 33(30.09.10).

19 de Agosto de 2010
Reelecciones. Consejero: IZAGUIRRE GUERRICACOITIA I脩IGO;VICENT PECHARROMAN ANTONIO. Presidente: VICENTPECHARROMAN ANTONIO. Con.Delegado: VICENT PECHARROMAN ANTONIO. Consejero: GARCIA LAHIGUERA CAMBRAFERNANDO. Secretario: JIMENEZ GARCIA ALZORRIZ IGNACIO. Datos registrales. T 21147 , F 117, S 8, H M 278751, I/A 31 (6.08.10).

27 de Agosto de 2009
Reelecciones. Auditor: AUREN CENTRO AUDITORES Y CONSULTORES SL. Datos registrales. T 21147 , F 117, S 8, H M278751, I/A 29 (17.08.09).

Reelecciones. Aud.C.Con.: AUREN CENTRO AUDITORES Y CONSULTORES SL. Datos registrales. T 21147 , F 117, S 8, H M278751, I/A 30 (17.08.09).

02 de Junio de 2009
Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 186.670,00 Euros. Resultante Suscrito: 1.033.330,00 Euros. Datos registrales. T 21147 ,F 116, S 8, H M 278751, I/A 28 (21.05.09).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n