Actos BORME de Moala Properties 2018 Sl
04 de Septiembre de 2023Ceses/Dimisiones. SecreNoConsj: FERNANDEZ GARCIA LAURA. VsecrNoConsj: ACOSTA RAMIREZ MIGUEL PEDRO.Revocaciones. Apoderado: FERNANDEZ GARCIA LAURA;DEL VAL MARTINEZ JORGE. Nombramientos. SecreNoConsj:ACOSTA RAMIREZ MIGUEL PEDRO. VsecrNoConsj: RIQUELME ORTIZ MARIA JOSE. Apo.Sol.: ACOSTA RAMIREZ MIGUELPEDRO. Datos registrales. T 39551 , F 188, S 8, H M 695643, I/A 11 (28.08.23).
14 de Junio de 2023Revocaciones. Apoderado: BLAZQUEZ MARQUEZ ADOLFO. Datos registrales. T 39551 , F 188, S 8, H M 695643, I/A 10 (7.06.23).
19 de Diciembre de 2022Revocaciones. Apoderado: USED ALONSO ENRIQUE. Datos registrales. T 39551 , F 188, S 8, H M 695643, I/A 9 (12.12.22).
04 de Octubre de 2022Nombramientos. Apo.Manc.: BOSSY JEAN-FRANCOIS PASCAL EMMANUEL;ROCH DOROTA;DIETRICH MICHAEL;CABALLEROMARTINEZ JOSE GABRIEL. Otros conceptos: Revocado parcialmente el poder conferido a Clase A. Don Jean-François PascalEnmanuel Bossy, Doña Solveig Diana Hoffmann, Don José Gabriel Caballero Martínez, Don Pierre-Yves Lefebvre, Doña Elena Piaia,Doña Lia Pagés Serra, Doña Dorota Marta Roch. Clase B. Don Eduard Mendiluce Fradera, Doña Tania M. Datos registrales. T 39551, F 187, S 8, H M 695643, I/A 8 (27.09.22).
22 de Diciembre de 2021Revocaciones. Apoderado: MARRERO FERNANDEZ-CID SANTIAGO. Nombramientos. Apoderado: DEL VAL MARTINEZJORGE. Datos registrales. T 39551 , F 186, S 8, H M 695643, I/A 7 (15.12.21).
23 de Julio de 2021Ceses/Dimisiones. Consejero: HOFFMANN SOLVEIG DIANA. Presidente: HOFFMANN SOLVEIG DIANA. Nombramientos.Presidente: BOSSY JEAN FRANCOIS PASCAL EMMANUEL. Consejero: BOSSY JEAN FRANCOIS PASCAL EMMANUEL. Datosregistrales. T 39551 , F 185, S 8, H M 695643, I/A 6 (16.07.21).
21 de Junio de 2021Ceses/Dimisiones. Consejero: BOSSY JEAN-FRANCOIS PASCAL EMMANUEL;SAN JOSE DE SANTIAGO DIEGO. Presidente:SAN JOSE DE SANTIAGO DIEGO. Nombramientos. Consejero: HOFFMANN SOLVEIG DIANA. Apoderado: SUNCAPITALMANAGEMENT SOCIEDAD LIMITADA. Presidente: HOFFMANN SOLVEIG DIANA. Datos registrales. T 39551 , F 185, S 8, H M695643, I/A 5 (14.06.21).
28 de Diciembre de 2020Revocaciones. Apoderado: BAZAGA BUSTOS MARIA ANGELES;PASCUAL GONZALEZ-BABE JOSE MARIA;PASCUALGONZALEZ-BABE JOSE MARIA;JIMENEZ SANCHEZ SARA;BAZAGA BUSTOS MARIA ANGELES. Nombramientos. Apoderado:JIMENEZ CRESPO DULCENOMBRE DE MARIA;MARRERO FERNANDEZ-CID SANTIAGO;GONZALEZ MARTIN MARIAMONTSERRAT;GUTIERREZ GARCIA VICTOR;MARIN DE RODA ANA. Datos registrales. T 39551 , F 183, S 8, H M 695643, I/A 4(18.12.20).
16 de Septiembre de 2019Revocaciones. Apoderado: MUÑOZ OLANO MARIA BELEN;DEL SOL SANCHEZ ANA-ISABEL. Nombramientos. Apoderado:CALVO CARBALLO VICTORIA. Datos registrales. T 39158 , F 129, S 8, H M 695643, I/A 3 ( 9.09.19).
30 de Mayo de 2019Cambio de domicilio social. PASEO DE LA CASTELLANA 280 2 (MADRID). Datos registrales. T 39158 , F 129, S 8, H M 695643,I/A 2 (23.05.19).