Actos BORME de Modagoza Sl
22 de Diciembre de 2015Ceses/Dimisiones. Consejero: GOMEZ DE ZAMORA MARTINEZ REMEDIOS;GARCIA MOLINA FRANCISCO;GOMEZ DE ZAMORAMARTINEZ CLEMENTE;FORD PENELOPE ANN. Presidente: GOMEZ DE ZAMORA MARTINEZ CLEMENTE. Secretario: GOMEZ DEZAMORA MARTINEZ REMEDIOS. Cons.Del.Sol: GARCIA MOLINA FRANCISCO;GOMEZ DE ZAMORA MARTINEZCLEMENTE;FORD PENELOPE ANN;GOMEZ DE ZAMORA MARTINEZ REMEDIOS. Disoluci贸n. Fusion. Extinci贸n. Datosregistrales. T 15263 , F 184, S 8, H M 26052, I/A 36 (15.12.15).
27 de Marzo de 2013Declaraci贸n de unipersonalidad. Socio 煤nico: ORGANIZACION GOMEZ DE ZAMORA SL. Reducci贸n de capital. Importereducci贸n: 60.100,00 Euros. Resultante Suscrito: 60.100,00 Euros. Datos registrales. T 15263 , F 183, S 8, H M 26052, I/A 35(19.03.13).
26 de Marzo de 2013Reelecciones. Consejero: GOMEZ DE ZAMORA MARTINEZ REMEDIOS;GARCIA MOLINA FRANCISCO;GOMEZ DE ZAMORAMARTINEZ CLEMENTE;FORD PENELOPE ANN. Presidente: GOMEZ DE ZAMORA MARTINEZ CLEMENTE. Secretario: GOMEZ DEZAMORA MARTINEZ REMEDIOS. Cons.Del.Sol: GARCIA MOLINA FRANCISCO;GOMEZ DE ZAMORA MARTINEZCLEMENTE;FORD PENELOPE ANN;GOMEZ DE ZAMORA MARTINEZ REMEDIOS. Datos registrales. T 15263 , F 182, S 8, H M26052, I/A 33 (19.03.13).
Nombramientos. Apoderado: FERNANDEZ BOMBIN ALONSO. Datos registrales. T 15263 , F 183, S 8, H M 26052, I/A 34(19.03.13).
16 de Julio de 2012Cambio de domicilio social. AVDA DE LA INDUSTRIA 17 (ALCOBENDAS). Datos registrales. T 15263 , F 182, S 8, H M 26052,I/A 32 ( 4.07.12).
24 de Octubre de 2011Reelecciones. Auditor: HERNANDEZ Y ARRECUBIETA ESTUDIO DE AUDITORIA Y ECO. Datos registrales. T 15263 , F 182, S 8,H M 26052, I/A 31 (11.10.11).