Buscador CIF Logo

Actos BORME Modania Sa

驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Modania Sa

Actos BORME Modania Sa - A78129871

Tenemos registrados 21 Actos BORME del Registro Mercantil de Madrid para Modania Sa con CIF A78129871

馃敊 Perfil de Modania Sa
馃洅 Comprar listado completo de Empresas de Madrid

Actos BORME de Modania Sa

28 de Noviembre de 2023
Reelecciones. Auditor: LILLO AUDITORES ASOCIADOS SL. Datos registrales. T 35848 , F 175, S 8, H M 77530, I/A 42 (21.11.23).

30 de Noviembre de 2022
Reelecciones. Auditor: LILLO AUDITORES ASOCIADOS SL. Datos registrales. T 35848 , F 175, S 8, H M 77530, I/A 41 (23.11.22).

09 de Junio de 2022
Reelecciones. SecreNoConsj: GARCIA GOMEZ DE ZAMORA REMEDIOS. Consejero: GOMEZ DE ZAMORA FORDCLEMENTE;GOMEZ DE ZAMORA FORD CAROLINA;GARCIA GOMEZ DE ZAMORA MIGUEL ANGEL. Con.Delegado: GOMEZ DEZAMORA FORD CLEMENTE;GOMEZ DE ZAMORA FORD CAROLINA;GARCIA GOMEZ DE ZAMORA MIGUEL ANGEL. Presidente:GOMEZ DE ZAMORA FORD CLEMENTE. Datos registrales. T 35848 , F 174, S 8, H M 77530, I/A 40 ( 2.06.22).

03 de Diciembre de 2021
Nombramientos. Auditor: LILLO AUDITORES ASOCIADOS SL. Datos registrales. T 35848 , F 174, S 8, H M 77530, I/A 39(26.11.21).

26 de Enero de 2021
Reelecciones. Auditor: LILLO AUDITORES ASOCIADOS SL. Datos registrales. T 35848 , F 174, S 8, H M 77530, I/A 38 (19.01.21).

02 de Diciembre de 2019
Nombramientos. Auditor: LILLO AUDITORES ASOCIADOS SL. Datos registrales. T 35848 , F 174, S 8, H M 77530, I/A 37(25.11.19).

18 de Octubre de 2018
Reelecciones. Auditor: LILLO AUDITORES ASOCIADOS SL. Datos registrales. T 35848 , F 174, S 8, H M 77530, I/A 36 ( 8.10.18).

10 de Octubre de 2017
Reelecciones. Auditor: LILLO AUDITORES ASOCIADOS SL. Datos registrales. T 35848 , F 173, S 8, H M 77530, I/A 35 ( 3.10.17).

04 de Septiembre de 2017
Ceses/Dimisiones. Consejero: GOMEZ DE ZAMORA MARTINEZ REMEDIOS. Secretario: GOMEZ DE ZAMORA MARTINEZREMEDIOS. Consejero: GOMEZ DE ZAMORA MARTINEZ CLEMENTE;FORD PENELOPE ANN;GARCIA MOLINA FRANCISCO.Cons.Del.Sol: REMEDIOS GOMEZ DE ZAMORA MARTINEZ;GOMEZ DE ZAMORA MARTINEZ CLEMENTE;ANN FORDPENELOPE;GARCIA MOLINA FRANCISCO. Nombramientos. SecreNoConsj: GARCIA GOMEZ DE ZAMORA REMEDIOS.Modificaciones estatutarias. SE MODIFICAN Y REFUNDEN LA TOTALIDAD DE LOS ESTATUTOS SOCIALES.. Datosregistrales. T 35848 , F 171, S 8, H M 77530, I/A 34 (22.08.17).

19 de Mayo de 2017
Fe de erratas: SE PUBLICO POR ERROR EN LA INSCRIPCION 33陋 LA REELECCION DEL PRESIDENTE GOMEZ DE ZAMORAMARTINEZ CLEMENTE, SIENDO LO CORRECTO EL CESE DEL MISMO Y EL NOMBRAMIENTO PARA EL MISMO CARGO DEGOMEZ DE ZAMORA FORD CLEMENTE. Datos registrales. T 20551 , F 225, S 8, H M 77530, I/A 33 (10.05.17).

Ceses/Dimisiones. Presidente: GOMEZ DE ZAMORA MARTINEZ CLEMENTE. Nombramientos. Presidente: GOMEZ DEZAMORA FORD CLEMENTE. Datos registrales. T 20551 , F 225, S 8, H M 77530, I/A 33 (10.05.17).

18 de Mayo de 2017
Nombramientos. Consejero: GOMEZ DE ZAMORA FORD CLEMENTE;GOMEZ DE ZAMORA FORD CAROLINA;GARCIA GOMEZDE ZAMORA MIGUEL ANGEL. Con.Delegado: GOMEZ DE ZAMORA FORD CLEMENTE;GOMEZ DE ZAMORA FORDCAROLINA;GARCIA GOMEZ DE ZAMORA MIGUEL ANGEL. Reelecciones. Presidente: GOMEZ DE ZAMORA MARTINEZ

07 de Marzo de 2017
Ceses/Dimisiones. Cons.Del.Sol: GOMEZ DE ZAMORA MARTINEZ REMEDIOS;GOMEZ DE ZAMORA MARTINEZCLEMENTE;FORD PENELOPE ANN;GARCIA MOLINA FRANCISCO. Nombramientos. Cons.Del.Sol: REMEDIOS GOMEZ DEZAMORA MARTINEZ;GOMEZ DE ZAMORA MARTINEZ CLEMENTE;ANN FORD PENELOPE;GARCIA MOLINA FRANCISCO.Reelecciones. Consejero: GOMEZ DE ZAMORA MARTINEZ REMEDIOS. Secretario: GOMEZ DE ZAMORA MARTINEZ REMEDIOS.Consejero: GOMEZ DE ZAMORA MARTINEZ CLEMENTE. Presidente: GOMEZ DE ZAMORA MARTINEZ CLEMENTE. Consejero:FORD PENELOPE ANN;GARCIA MOLINA FRANCISCO. Datos registrales. T 20551 , F 225, S 8, H M 77530, I/A 32 (27.02.17).

03 de Febrero de 2016
Cambio de domicilio social. C/ CANTABRIA, 2 - PRIMERA PLANTA (ALCOBENDAS). Datos registrales. T 20551 , F 225, S 8, HM 77530, I/A 31 (26.01.16).

22 de Diciembre de 2015
Fusi贸n por absorci贸n. Sociedades absorbidas: MODAGOZA SL. BAVIERA MODA SA. Datos registrales. T 20551 , F 222, S 8, H M77530, I/A 30 (15.12.15).

21 de Octubre de 2014
Nombramientos. Auditor: LILLO AUDITORES ASOCIADOS SL. Datos registrales. T 20551 , F 222, S 8, H M 77530, I/A 29(14.10.14).

21 de Marzo de 2013
Nombramientos. Apoderado: FERNANDEZ BOMBIN ALONSO. Datos registrales. T 20551 , F 222, S 8, H M 77530, I/A 28(13.03.13).

23 de Julio de 2012
Cambio de domicilio social. AVDA DE LA INDUSTRIA 17 (ALCOBENDAS). Datos registrales. T 20551 , F 221, S 8, H M 77530,I/A 27 (10.07.12).

07 de Marzo de 2012
Reelecciones. Consejero: GOMEZ DE ZAMORA MARTINEZ REMEDIOS. Secretario: GOMEZ DE ZAMORA MARTINEZ REMEDIOS.Cons.Del.Sol: GOMEZ DE ZAMORA MARTINEZ REMEDIOS. Consejero: GOMEZ DE ZAMORA MARTINEZ CLEMENTE. Presidente:GOMEZ DE ZAMORA MARTINEZ CLEMENTE. Cons.Del.Sol: GOMEZ DE ZAMORA MARTINEZ CLEMENTE. Consejero: FORDPENELOPE ANN. Cons.Del.Sol: FORD PENELOPE ANN. Consejero: GARCIA MOLINA FRANCISCO. Cons.Del.Sol: GARCIAMOLINA FRANCISCO. Datos registrales. T 20551 , F 221, S 8, H M 77530, I/A 26 (24.02.12).

24 de Octubre de 2011
Reelecciones. Auditor: HERNANDEZ Y ARRECUBIETA ESTUDIO DE AUDITORIA Y ECO. Datos registrales. T 20551 , F 221, S 8,H M 77530, I/A 25 (13.10.11).

25 de Noviembre de 2010
Revocaciones. Apoderado: SABATES VIDAL RAMON. Nombramientos. Apoderado: GARCIA GOMEZ DE ZAMORA MIGUELANGEL. Datos registrales. T 20551 , F 219, S 8, H M 77530, I/A 24 (16.11.10).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n