Actos BORME de Molina Y Franch Sl
05 de Agosto de 2014Situaci贸n concursal. Procedimiento concursal 228/2013. FIRME: Si, Fecha de resoluci贸n 8/07/2014. Auto de conclusi贸n del concursoFinalizacion de la fase de liquidacion. Juzgado: num. 10 JUZGADO DE LO MERCANTIL DE MADRID. Juez: DO脩A OLGA MARTINALONSO. Situaci贸n concursal. Procedimiento concursal 228/2013. FIRME: Si, Fecha de resoluci贸n 8/07/2014. Cese de laslimitaciones de las facultades de administraci贸n. Juzgado: num. 10 JUZGADO DE LO MERCANTIL DE MADRID. Juez: DO脩A OLGAMARTIN ALONSO. Extinci贸n. Datos registrales. T 28673 , F 2, S 8, H M 50711, I/A 11 (25.07.14).
12 de Diciembre de 2013Situaci贸n concursal. Procedimiento concursal 228/2013. FIRME: No, Fecha de resoluci贸n 18/07/2013. Auto de declaraci贸n deconcurso. Voluntario. Juzgado: num. 10 JUZGADO DE LO MERCANTIL. Juez: OLGA MARTIN ALONSO. Resoluciones: Se declaraque el auto de declaraci贸n de concurso de fecha 18 de juliod e 2013,.ha devenido firme, quedando convertida la anotaci贸n preventivaA. que motivo el.mismo en inscripcion. Datos registrales. T 28673 , F 1, S 8, H M 50711, I/A 9 ( 3.12.13).
21 de Octubre de 2013Nombramientos. Representan: FRIES MICHAEL CLAUS. Situaci贸n concursal. Procedimiento concursal 228/2013. Fecha deresoluci贸n 18/07/2013. Nombramiento de administradores. Juzgado: num. 10 JUZGADO DE LO MERCANTIL. Juez: OLGA MARTINALONSO. Administrador Concursal. Fecha 18/07/2013, NIF/CIF B65924177. MONEREO MEYER MARINEL LO RESOLVENZ SLP.Situaci贸n concursal. Procedimiento concursal 228/2013. FIRME: No, Fecha de resoluci贸n 18/07/2013. Solicitud de declaraci贸n.Juzgado: num. 10 JUZGADO DE LO MERCANTIL. Juez: OLGA MARTIN ALONSO. Resoluciones: DECLARACION DEL CONCURSODE ACREEDORES CON CARACTER VOLUNTARIO Y NOMBRAMIENTO DE ADMINISTRADOR CONCURSAL. Datos registrales.T 28673 , F 1, S 8, H M 50711, I/A A (10.10.13).
06 de Abril de 2011Ceses/Dimisiones. Consejero: FRANCH TUTELAR ALFONSO. Datos registrales. T 2957 , F 155, S 8, H M 50711, I/A 6 (28.03.11).
Ceses/Dimisiones. Con.Delegado: FRANCH MENEU VICENTE. Datos registrales. T 2957 , F 155, S 8, H M 50711, I/A 7(28.03.11).
Ceses/Dimisiones. Consejero: FRANCH ORENGA MARIA ISABEL. Datos registrales. T 28673 , F 1, S 8, H M 50711, I/A 8(28.03.11).
06 de Noviembre de 2009Ceses/Dimisiones. Con.Delegado: MOLINA SEGOVIA MIGUEL. Consejero: PEREZ RODRIGUEZ JESUS;MOLINA SEGOVIAMIGUEL;MOLINA SEGOVIA MANUEL. Presidente: MOLINA SEGOVIA MANUEL. Secretario: MOLINA SEGOVIA MIGUEL.Con.Delegado: MOLINA SEGOVIA MIGUEL. Nombramientos. Consejero: FRANCH MENEU ALFONSO;FRANCH TUTELARALFONSO;FRANCH ORENGA MARIA ISABEL;PEREZ RODRIGUEZ JESUS;GALVEZ HERNANDEZ LUIS;FRANCH MENEUVICENTE;MARTIN DIEGO PEDRO. Presidente: FRANCH MENEU ALFONSO. Con.Delegado: FRANCH MENEU VICENTE.SecreNoConsj: MIRAVET SORRIBES PASCUAL EMILIO. Datos registrales. T 2957 , F 154, S 8, H M 50711, I/A 3 (26.10.09).
Modificaciones estatutarias. Fecha de Cierre de Ejercicio: 30/9. Datos registrales. T 2957 , F 155, S 8, H M 50711, I/A 4(26.10.09).
Nombramientos. Apoderado: FRANCH MENEU ALFONSO. Datos registrales. T 2957 , F 155, S 8, H M 50711, I/A 5 (26.10.09).