Actos BORME de Molinos De Castilla La Mancha Sl
09 de Octubre de 2023Revocaciones. Apo.Man.Soli: RODRIGUEZ MORENO JOSE ANTONIO. Datos registrales. T 493 , F 171, S 8, H P 4856, I/A 40(27.09.23).
16 de Mayo de 2023Nombramientos. Apo.Man.Soli: FONTS CAVESTANY JUAN BOSCO. Datos registrales. T 493 , F 169, S 8, H P 4856, I/A 39 (4.05.23).
02 de Marzo de 2023Revocaciones. Apo.Sol.: GOMEZ GARCIA MARIA DEL PILAR. Datos registrales. T 493 , F 169, S 8, H P 4856, I/A 38 (22.02.23).
19 de Septiembre de 2022Nombramientos. Apo.Sol.: RUEDA GONZALEZ PEDRO ANTONIO;ESCUDERO PERAL JOSE ANTONIO. Datos registrales. T 493, F 169, S 8, H P 4856, I/A 35 ( 8.09.22).
Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: GONZALEZ SERNA JUAN MANUEL. Nombramientos. Adm. Unico: KARAKAS HALIL CEM.Datos registrales. T 493 , F 169, S 8, H P 4856, I/A 36 ( 8.09.22).
Revocaciones. Apo.Man.Soli: TAPIA BAJO LORENZA. Apoderado: URBAN LOPEZ LUCIA. Datos registrales. T 493 , F 169, S 8, HP 4856, I/A 37 ( 9.09.22).
04 de Febrero de 2022Revocaciones. Apo.Sol.: LOPEZ LOPEZ ANTONIO;RODRIGUEZ BALDOMINOS CARMEN MARIA;RUBIA PRADANA MARINA.Datos registrales. T 493 , F 169, S 8, H P 4856, I/A 34 (31.01.22).
02 de Marzo de 2021Nombramientos. Apo.Man.Soli: GONZALEZ DEL AGUA MARTA;RODRIGUEZ MORENO JOSE ANTONIO. Datos registrales. T493 , F 167, S 8, H P 4856, I/A 33 (23.02.21).
20 de Julio de 2020Fusi贸n por absorci贸n. Sociedades absorbidas: INMUEBLES RIMARSA SL. Datos registrales. T 399 , F 8, S 8, H P 4856, I/A 32(10.07.20).
30 de Junio de 2020Cambio de domicilio social. AVDA DE BURGOS 29 (VENTA DE BA脩OS). Datos registrales. T 399 , F 8, S 8, H P 4856, I/A 31(23.06.20).
17 de Diciembre de 2019Revocaciones. Apoderado: LOPEZ RODRIGUEZ ALVARO. Nombramientos. Apo.Sol.: LOPEZ LOPEZ ANTONIO;RODRIGUEZBALDOMINOS CARMEN MARIA;RUBIA PRADANA MARINA;DIEZ ALONSO MERCEDES;HERRERO CALLE MARIA DE LOSMILAGROS;GOMEZ GARCIA MARIA DEL PILAR;NIETO MATE SANDRA. Datos registrales. T 399 , F 7, S 8, H P 4856, I/A 30 (5.12.19).
03 de Enero de 2019Revocaciones. Apo.Man.Soli: CONEJERO URBAN ANTONIO. Datos registrales. T 399 , F 7, S 8, H P 4856, I/A 29 (24.12.18).
19 de Junio de 2017Nombramientos. Apoderado: LOPEZ RODRIGUEZ ALVARO. Datos registrales. T 399 , F 7, S 8, H P 4856, I/A 27 ( 9.06.17).
Revocaciones. Apoderado: BENITO BENITO FRANCISCO JAVIER. Datos registrales. T 399 , F 7, S 8, H P 4856, I/A 28 ( 9.06.17).
22 de Octubre de 2014Revocaciones. Apoderado: GONZALEZ SERNA VIRGINIA. Datos registrales. T 399 , F 7, S 8, H P 4856, I/A 26 (16.10.14).
03 de Abril de 2014Nombramientos. Apoderado: GONZALEZ SERNA VIRGINIA. Datos registrales. T 399 , F 6, S 8, H P 4856, I/A 25 (27.03.14).
19 de Abril de 2013Nombramientos. Apoderado: BENITO BENITO FRANCISCO JAVIER. Datos registrales. T 399 , F 6, S 8, H P 4856, I/A 24(11.04.13).
29 de Diciembre de 2011Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 764.475,00 Euros. Resultante Suscrito: 855.525,00 Euros. Datos registrales. T 399 , F 6,S 8, H P 4856, I/A 23 (19.12.11).
28 de Enero de 2011Revocaciones. Apoderado: HEVIA OBRAS FRANCISCO RAMON. Datos registrales. T 399 , F 6, S 8, H P 4856, I/A 22 (19.01.11).
17 de Noviembre de 2009Revocaciones. Apoderado: DE LA LASTRA MARCOS IGNACIO. Datos registrales. T 399 , F 6, S 8, H P 4856, I/A 21 ( 5.11.09).