Buscador CIF Logo

Actos BORME Molypharma Sa

驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Molypharma Sa

Actos BORME Molypharma Sa - A82046285

Tenemos registrados 15 Actos BORME del Registro Mercantil de Madrid para Molypharma Sa con CIF A82046285

馃敊 Perfil de Molypharma Sa
馃洅 Comprar listado completo de Empresas de Madrid

Actos BORME de Molypharma Sa

15 de Junio de 2015
Ceses/Dimisiones. Consejero: DEHARENG RENAUD;MARION HERVE;BRENDEL FRANCOIS. Presidente: MARION HERVE.SecreNoConsj: DUTILH CARVAJAL JOSE MARIA. Disoluci贸n. Fusion. Extinci贸n. Datos registrales. T 18943 , F 136, S 8, H M214351, I/A 38 ( 5.06.15).

01 de Abril de 2015
Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 3.927.468,89 Euros. Resultante Suscrito: 1.481.531,11 Euros. Datos registrales. T 18943, F 135, S 8, H M 214351, I/A 37 (20.03.15).

19 de Enero de 2015
Declaraci贸n de unipersonalidad. Socio 煤nico: IBA MOLECULAR SPAIN SA. Ceses/Dimisiones. Presidente: GONZALEZMARTINEZ JOSE LUIS. Consejero: GONZALEZ MARTINEZ JOSE LUIS;FERNANDEZ-TRESGUERRES HERNANDEZ-GILFERNANDO;PEREZ BOADA ANDRES;ARTIEDA GONZALEZ-GRANDA JUAN;LOZANO SANCHEZ FERNANDO. Secretario:LOZANO SANCHEZ FERNANDO. Nombramientos. Consejero: DEHARENG RENAUD;MARION HERVE;BRENDEL FRANCOIS.Cambio de domicilio social. AVDA DOCTOR SEVERO OCHOA NUMERO 29 (ALCOBENDAS). Datos registrales. T 18943 , F 133,S 8, H M 214351, I/A 35 ( 9.01.15).

Revocaciones. Apo.Sol.: ELIAS DE TEJADA LOZANO JOSE MARIA;LOZANO SANCHEZ FERNANDO;LLUCH TEJEROJESUS;GONZALEZ MARTINEZ JOSE LUIS;OYARZABAL DELGADO IGNACIO;JIMENEZ SHAW RAFAEL;GONZALEZ MARTINEZJOSE LUIS;OYARZABAL DELGADO IGNACIO;RIOS MITCHEL JOSE MIGUEL;GONZALEZ MARTINEZ JOSE LUIS;OYARZABALDELGADO IGNACIO. Apo.Manc.: GONZALEZ MARTINEZ JOSE LUIS;OYARZABAL DELGADO IGNACIO;GARCIA-CALDERONROMEO GERMAN;RODERGAS PUNTAS FERNANDO;RIOS MITCHELL JOSE-MIGUEL. Apo.Sol.: GARCIA-CALDERON ROMEOGERMAN;RODERGAS PUNTAS FERNANDO;RIOS MITCHELL JOSE-MIGUEL.Apo.Manc.: GONZALEZ MARTINEZ JOSELUIS;RODERGAS PUNTAS FERNANDO;OYARZABAL DELGADO IGNACIO. Apoderado: GONZALEZ MARTINEZ JOSELUIS;OYARZABAL DELGADO IGNACIO. Apo.Manc.: GONZALEZ MARTINEZ JOSE LUIS;OYARZABAL DELGADOIGNACIO;ARTIEDA GONZALEZ-GRANDA JUAN IGNACIO;DIAZ-VARELA ARRESE BEGO脩A;RIOS MITCHELL JOSE-MIGUEL.Apoderado: DIAZ-VARELA ARRESE BEGO脩A;RIOS MITCHELL JOSE-MIGUEL. Apo.Manc.: GONZALEZ MARTINEZ JOSELUIS;DIAZ-VARELA ARRESE BEGO脩A;OYARZABAL DELGADO IGNACIO.Apoderado: ARTIEDA GONZALEZ-GRANDA JUANIGNACIO. Nombramientos. SecreNoConsj: DUTILH CARVAJAL JOSE MARIA. Presidente: MARION HERVE. Apoderado:DEHARENG RENAUD;MARION HERVE;PEREZ BOADA ANDRES. Datos registrales. T 18943 , F 134, S 8, H M 214351, I/A 36 (9.01.15).

17 de Diciembre de 2014
Reelecciones. Presidente: GONZALEZ MARTINEZ JOSE LUIS. Consejero: GONZALEZ MARTINEZ JOSE LUIS;FERNANDEZ-TRESGUERRES HERNANDEZ-GIL FERNANDO;PEREZ BOADA ANDRES;ARTIEDA GONZALEZ-GRANDA JUAN;LOZANOSANCHEZ FERNANDO. Datos registrales. T 18943 , F 133, S 8, H M 214351, I/A 34 ( 9.12.14).

27 de Diciembre de 2013
Nombramientos. Apoderado: GONZALEZ MARTINEZ JOSE LUIS;DIAZ-VARELA ARRESE BEGO脩A;LOZANO SANCHEZFERNANDO;ARTIEDA GONZALEZ-GRANDA JUAN;RIOS MITCHEL JOSE MIGUEL. Datos registrales. T 18943 , F 131, S 8, H M214351, I/A 33 (18.12.13).

26 de Diciembre de 2013
Ceses/Dimisiones. Consejero: OYARZABAL DELGADO IGNACIO. Nombramientos. Consejero: LOZANO SANCHEZ FERNANDO.Datos registrales. T 18943 , F 130, S 8, H M 214351, I/A 32 (18.12.13).

14 de Enero de 2013
Nombramientos. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Aud.C.Con.: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 18943 , F 130, S 8, H M214351, I/A 31 ( 3.01.13).

18 de Mayo de 2011
Nombramientos. Apoderado: GONZALEZ MARTINEZ JOSE LUIS;OYARZABAL DELGADO IGNACIO. Apo.Manc.: GONZALEZMARTINEZ JOSE LUIS;OYARZABAL DELGADO IGNACIO;ARTIEDA GONZALEZ GRANDA JUAN IGNACIO;DIAZ-VARELA ARRESEBEGO脩A;RIOS MITCHELL JOSE-MIGUEL. Apoderado: DIAZ-VARELA ARRESE BEGO脩A;RIOS MITCHELL JOSE-MIGUEL.Apo.Manc.: GONZALEZ MARTINEZ JOSE LUIS;DIAZ-VARELA ARRESE BEGO脩A;OYARZABAL DELGADO IGNACIO.Apoderado:ARTIEDA GONZALEZ GRANDA JUAN IGNACIO. Datos registrales. T 18943 , F 128, S 8, H M 214351, I/A 30 ( 9.05.11).

06 de Abril de 2011
Ceses/Dimisiones. Consejero: GARCIA-CALDERON ROMEO GERMAN. Nombramientos. Consejero: ARTIEDA GONZALEZ-GRANDA JUAN. Datos registrales. T 18943 , F 128, S 8, H M 214351, I/A 28 (28.03.11).

Ceses/Dimisiones. Consejero: MU脩IZ MU脩IZ JOSE ANTONIO;MORENO DE ACEVEDO ENRIQUE;DEHARENG RENAUD.Modificaciones estatutarias. MODIFICACION ARTICULO 18 REFERENTE AL ORGANO DE ADMINISTRACION. Datosregistrales. T 18943 , F 128, S 8, H M 214351, I/A 29 (28.03.11).

02 de Febrero de 2010
Reelecciones. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 18943 , F 128, S 8, H M 214351, I/A 27 (21.01.10).

15 de Diciembre de 2009
Ceses/Dimisiones. Consejero: JUSTE SESE RAFAEL. Reelecciones. Presidente: GONZALEZ MARTINEZ JOSE LUIS. Consejero:OYARZABAL DELGADO IGNACIO;GONZALEZ MARTINEZ JOSE LUIS;MU脩IZ MU脩IZ JOSE ANTONIO;GARCIA-CALDERONROMEO GERMAN;MORENO DE ACEVEDO ENRIQUE;FERNANDEZ-TRESGUERRES HERNANDEZ-GIL FERNANDO;PEREZBOADA ANDRES;DEHARENG RENAUD. Datos registrales. T 18943 , F 126, S 8, H M 214351, I/A 26 ( 1.12.09).

24 de Febrero de 2009
Revocaciones. Apoderado: GONZALEZ MARTINEZ JOSE LUIS;RODERGAS PUNTAS FERNANDO;OYARZABAL DELGADOIGNACIO;GARCIA-CALDERON ROMEO GERMAN;JIMENEZ SHAW RAFAEL. Nombramientos. Apoderado: PORTABALLESTEROS BARBARA. Datos registrales. T 18943 , F 125, S 8, H M 214351, I/A 25 (13.02.09).

07 de Enero de 2009
Reelecciones. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 18943 , F 125, S 8, H M 214351, I/A 24 (22.12.08).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n