Actos BORME de Momentum Task Force Sl
28 de Febrero de 2022Nombramientos. Auditor: ABDON BAS LOPEZ LUENGO Y ASOCIADOS AUDITORES SL. Datos registrales. T 28170 , F 102, S 8,H M 62690, I/A 44 (21.02.22).
06 de Abril de 2021Nombramientos. Apoderado: LOPEZ PARIS NOELIA. Datos registrales. T 28170 , F 101, S 8, H M 62690, I/A 43 (26.03.21).
31 de Enero de 2020Modificaciones estatutarias. Modificado el Articulo 22 de los Estatutos Sociales.. Art铆culo de los estatutos: 2. Objeto social.-.Ampliacion del objeto social. 5.- La promoci贸n, distribuci贸n, comercializaci贸n al por mayor y al por menor, intermediaci贸n,importaci贸n y exportaci贸n de toda clase de productos y art铆culos, comprendiendo los alimenticios, bebidas y los relacionados con laindustria del tabaco y cigarrillos electr贸nicos de todas clases, ... Datos registrales. T 28170 , F 100, S 8, H M 62690, I/A 42(24.01.20).
16 de Octubre de 2019Nombramientos. Apoderado: GUILLEN PEREZ SARA. Datos registrales. T 28170 , F 100, S 8, H M 62690, I/A 41 ( 9.10.19).
05 de Julio de 2019Revocaciones. Apoderado: VEGA GARCIA LUIS ADOLFO. Datos registrales. T 28170 , F 99, S 8, H M 62690, I/A 40 (28.06.19).
13 de Junio de 2019Nombramientos. Apoderado: ESCOBEDO GONZALEZ RAMON IGNACIO. Datos registrales. T 28170 , F 99, S 8, H M 62690, I/A39 ( 6.06.19).
27 de Agosto de 2018Reelecciones. Auditor: LOPEZ JUAREZ AUDITORES SLP. Datos registrales. T 28170 , F 98, S 8, H M 62690, I/A 38 (17.08.18).
24 de Octubre de 2017Nombramientos. Apoderado: VEGA GARCIA LUIS ADOLFO. Datos registrales. T 28170 , F 98, S 8, H M 62690, I/A 36 (11.10.17).
Revocaciones. Apoderado: CAMPOMANES DIAZ FERNANDO. Datos registrales. T 28170 , F 98, S 8, H M 62690, I/A 37(11.10.17).
25 de Agosto de 2017Cambio de domicilio social. C/ SANTA MARIA MAGDALENA, NUMERO 6 BIS (MADRID). Datos registrales. T 28170 , F 97, S 8,H M 62690, I/A 35 (16.08.17).
07 de Julio de 2017Reelecciones. Auditor: LOPEZ JUAREZ AUDITORES SLP. Datos registrales. T 28170 , F 97, S 8, H M 62690, I/A 34 (29.06.17).
01 de Julio de 2016Ceses/Dimisiones. Presidente: COTANDA ORTA CRISTINA. Consejero: MURO MOLINA ANTONIO. Nombramientos. Consejero:ALMENDROS FERNANDEZ MERCE. Presidente: ALMENDROS FERNANDEZ MERCE. Con.Delegado: ALMENDROS FERNANDEZMERCE. Datos registrales. T 28170 , F 96, S 8, H M 62690, I/A 33 (22.06.16).
07 de Junio de 2016Ceses/Dimisiones. Consejero: ALMENDROS FERNANDEZ MERCE. Presidente: ALMENDROS FERNANDEZ MERCE. Consejero:COTANDA ORTA CRISTINA;OCA脩A GRAJAL JAVIER. Secretario: OCA脩A GRAJAL JAVIER. Nombramientos. Consejero:COTANDA ORTA CRISTINA. Presidente: COTANDA ORTA CRISTINA. Consejero: OCA脩A GRAJAL JAVIER. Secretario: OCA脩AGRAJAL JAVIER. Consejero: MURO MOLINA ANTONIO. Datos registrales. T 28170 , F 96, S 8, H M 62690, I/A 32 (31.05.16).
05 de Mayo de 2014Ceses/Dimisiones. Consejero: DURAN RUIZ DE HUIDOBRO ALBERTO. Secretario: DURAN RUIZ DE HUIDOBRO ALBERTO.Revocaciones. Apoderado: DURAN RUIZ DE HUIDOBRO ALBERTO. Nombramientos. Consejero: OCA脩A GRAJAL JAVIER.Secretario: OCA脩A GRAJAL JAVIER. Datos registrales. T 28170 , F 95, S 8, H M 62690, I/A 31 (23.04.14).
01 de Abril de 2014Ceses/Dimisiones. VsecrNoConsj: SOSA ALGUACIL CARRASCO GONZALO. Datos registrales. T 28170 , F 95, S 8, H M 62690,I/A 30 (24.03.14).
10 de Mayo de 2013Reelecciones. Auditor: LOPEZ JUAREZ AUDITORES SLP. Datos registrales. T 28170 , F 95, S 8, H M 62690, I/A 28 (29.04.13).
Nombramientos. Apoderado: MURO MOLINA ANTONIO. Datos registrales. T 28170 , F 95, S 8, H M 62690, I/A 29 ( 3.05.13).
07 de Mayo de 2013P谩gina web de la sociedad. Creaci贸n de la p谩gina web corporativa: www.momentumtf.es. Datos registrales. T 28170 , F 94, S 8, HM 62690, I/A 27 (25.04.13).
29 de Octubre de 2012Modificaciones estatutarias. Modificaci贸n y nueva redacci贸n de los Estatutos Sociales para adaptarlos al Texto Refundido de la Leyde Sociedades de Capital.. Ampliacion del objeto social. LA ACTIVIDAD DE PROMOCION Y DIFUSION DE PRODUCTOS YSERVICIOS, ANIMACION DEVENTAS, REPARTO Y REPOSICION DE PROPAGANDA,... Datos registrales. T 28170 , F 92, S 8, HM 62690, I/A 26 (17.10.12).
23 de Octubre de 2012Nombramientos. Apoderado: MATE DOMINGUEZ LORENA. Datos registrales. T 28170 , F 92, S 8, H M 62690, I/A 25 (11.10.12).
23 de Noviembre de 2010Ampliaci贸n de capital. Capital: 34.800,00 Euros. Resultante Suscrito: 40.810,12 Euros. Datos registrales. T 3764 , F 219, S 8, H M62690, I/A 24 (11.11.10).
23 de Agosto de 2010Revocaciones. Apoderado: ALMENDROS FERNANDEZ MERCE;COTANDA ORTA CRISTINA;DURAN RUIZ DE HUIDOBROALBERTO. Nombramientos. Apoderado: ALMENDROS FERNANDEZ MERCE;OCA脩A GRAJAL JAVIER;DURAN RUIZ DEHUIDOBRO ALBERTO;CAMPOMANES DIAZ FERNANDO. Datos registrales. T 3764 , F 218, S 8, H M 62690, I/A 23 (12.08.10).
15 de Junio de 2010Reelecciones. Auditor: LOPEZ JUAREZ AUDITORES SLP. Datos registrales. T 3764 , F 218, S 8, H M 62690, I/A 22 ( 2.06.10).