Actos BORME de Monelec Sl
20 de Febrero de 2023Revocaciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 6056, L 4963, F 61, S 8, H MA 12641, I/A 76 ( 3.02.23).
30 de Junio de 2022Revocaciones. Apoderado: FERNANDEZ GARCIA JOSE ANTONIO. Datos registrales. T 6056, L 4963, F 60, S 8, H MA 12641, I/A74 (22.06.22).
Revocaciones. Apoderado: CASANUEVA MURUAIS CARLA. Datos registrales. T 6056, L 4963, F 61, S 8, H MA 12641, I/A 75(22.06.22).
16 de Junio de 2022Nombramientos. Apoderado: GARCIA SANCHEZ MARGARITA. Datos registrales. T 6056, L 4963, F 60, S 8, H MA 12641, I/A 73 (7.06.22).
27 de Mayo de 2022Nombramientos. Apoderado: ARCE SELMA LORENZO. Datos registrales. T 6056, L 4963, F 59, S 8, H MA 12641, I/A 72(16.05.22).
06 de Mayo de 2022Revocaciones. Apo.Man.Soli: ARCE SELMA LORENZO;SANZ RUIZ ALBERTO. Datos registrales. T 6056, L 4963, F 59, S 8, H MA12641, I/A 71 (25.04.22).
22 de Febrero de 2022Nombramientos. Auditor: DELOITTE SL. Otros conceptos: Revocada la entidad auditora "KPMG AUDITORES SL" para el ejerciciode 2021.- Datos registrales. T 6056, L 4963, F 59, S 8, H MA 12641, I/A 70 ( 9.02.22).
09 de Diciembre de 2021Nombramientos. Apo.Sol.: FERNANDEZ SENAC GLORIA. Datos registrales. T 6056, L 4963, F 58, S 8, H MA 12641, I/A 69(26.11.21).
22 de Noviembre de 2021Revocaciones. Apoderado: PULGAR FERRERO ARIADNA GOMEZ DEL. Apo.Sol.: PULGAR FERRERO ARIADNA GOMEZ DEL.
10 de Noviembre de 2021Revocaciones. Apo.Manc.: FLORES AGUILAR-AMAT FERNANDO;SAGRADO FERNANDEZ VENERANDO;FLORES AGUILAR-AMAT FERNANDO;SAGRADO FERNANDEZ VENERANDO. Apo.Sol.: FLORES AGUILAR-AMAT FERNANDO. Datos registrales. T6056, L 4963, F 58, S 8, H MA 12641, I/A 67 (27.10.21).
06 de Octubre de 2021Nombramientos. Apo.Man.Soli: FLORES AGUILAR-AMAT FERNANDO;MERINO REBOLLO NURIA. Datos registrales. T 6056, L4963, F 57, S 8, H MA 12641, I/A 66 (22.09.21).
30 de Junio de 2021Revocaciones. Apoderado: LOPEZ-MEDEL MARINA MIGUEL. Apo.Sol.: LOPEZ-MEDEL MARINA MIGUEL. Datos registrales. T5570, L 4477, F 29, S 8, H MA 12641, I/A 64 (22.06.21).
Nombramientos. Apoderado: PENEDO SIENES ANDREA. Datos registrales. T 5570, L 4477, F 29, S 8, H MA 12641, I/A 65(22.06.21).
08 de Enero de 2020Nombramientos. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 5570, L 4477, F 28, S 8, H MA 12641, I/A 62 (26.12.19).
30 de Octubre de 2019Nombramientos. Apo.Man.Soli: ARCE SELMA LORENZO;MANZANO DEL POZO JESUS. Datos registrales. T 5570, L 4477, F 27,S 8, H MA 12641, I/A 61 (21.10.19).
21 de Enero de 2019Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 5570, L 4477, F 27, S 8, H MA 12641, I/A 60 (10.01.19).
28 de Noviembre de 2018Nombramientos. Apoderado: CASANUEVA MURUAIS CARLA. Datos registrales. T 5570, L 4477, F 26, S 8, H MA 12641, I/A 59(15.11.18).
07 de Noviembre de 2018Revocaciones. Apoderado: RODRIGUEZ SANCHEZ SARA. Datos registrales. T 5570, L 4477, F 25, S 8, H MA 12641, I/A 57(22.10.18).
Nombramientos. Apo.Sol.: VERCET BOTET CARLOS;PULGAR FERRERO ARIADNA GOMEZ DEL;LOPEZ-MEDEL MARINAMIGUEL. Datos registrales. T 5570, L 4477, F 26, S 8, H MA 12641, I/A 58 (22.10.18).
24 de Septiembre de 2018Nombramientos. Apo.Manc.: FLORES AGUILAR-AMAT FERNANDO;SAGRADO FERNANDEZ VENERANDO;FLORES AGUILAR-AMAT FERNANDO;SAGRADO FERNANDEZ VENERANDO. Apo.Sol.: FLORES AGUILAR-AMAT FERNANDO. Datos registrales. T5570, L 4477, F 25, S 8, H MA 12641, I/A 56 (17.09.18).
27 de Junio de 2018Revocaciones. Apoderado: ALBIACH DOMINGO JOSE FERNANDO;GOMEZ PEREIRO CESAR. Apo.Manc.: ALBIACH DOMINGOJOSE FERNANDO;GOMEZ PEIRO CESAR. Datos registrales. T 5570, L 4477, F 25, S 8, H MA 12641, I/A 55 (15.06.18).
02 de Abril de 2018Nombramientos. Apoderado: MANZANO DEL POZO JESUS. Datos registrales. T 5570, L 4477, F 23, S 8, H MA 12641, I/A 53(20.03.18).
Nombramientos. Apo.Man.Soli: CAÑERO CARRASCO RAFAEL. Apoderado: GAVIRA IGLESIAS RAFAEL ANTONIO. Datosregistrales. T 5570, L 4477, F 24, S 8, H MA 12641, I/A 54 (20.03.18).
22 de Marzo de 2018Nombramientos. Apo.Sol.: GAVIRA IGLESIAS RAFAEL ANTONIO. Datos registrales. T 5570, L 4477, F 23, S 8, H MA 12641, I/A52 (13.03.18).
15 de Febrero de 2018Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 5570, L 4477, F 23, S 8, H MA 12641, I/A 51 ( 6.02.18).
05 de Diciembre de 2017Nombramientos. Apoderado: PULGAR FERRERO ARIADNA GOMEZ DEL. Datos registrales. T 5570, L 4477, F 22, S 8, H MA12641, I/A 48 (27.11.17).
Nombramientos. Apoderado: LOPEZ-MEDEL MARINA MIGUEL. Datos registrales. T 5570, L 4477, F 22, S 8, H MA 12641, I/A 49(27.11.17).
Revocaciones. Apoderado: CASTILLO SIERRA ALEJANDRA. Datos registrales. T 5570, L 4477, F 23, S 8, H MA 12641, I/A 50(27.11.17).
24 de Agosto de 2017Nombramientos. Apo.Man.Soli: ARCE SELMA LORENZO;SANZ RUIZ ALBERTO. Datos registrales. T 5570, L 4477, F 21, S 8, HMA 12641, I/A 47 (16.08.17).
16 de Enero de 2017Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 5570, L 4477, F 21, S 8, H MA 12641, I/A 46 ( 4.01.17).
02 de Diciembre de 2016Nombramientos. Apoderado: MORA PRIOR ESTANISLAO. Datos registrales. T 5130, L 4037, F 70, S 8, H MA 12641, I/A 45(23.11.16).
13 de Octubre de 2016Nombramientos. Apoderado: CASTILLO SIERRA ALEJANDRA. Datos registrales. T 5130, L 4037, F 70, S 8, H MA 12641, I/A 44 (4.10.16).
01 de Agosto de 2016Revocaciones. Apoderado: CRISTOBAL MARQUEZ PONCE. Datos registrales. T 5130, L 4037, F 70, S 8, H MA 12641, I/A 43(21.07.16).
22 de Junio de 2016Revocaciones. Apo.Man.Soli: MANZANO DEL POZO JESUS. Datos registrales. T 5130, L 4037, F 70, S 8, H MA 12641, I/A 42(14.06.16).
04 de Mayo de 2016Nombramientos. Apo.Manc.: MANZANO DEL POZO JESUS. Apo.Sol.: MANZANO DEL POZO JESUS. Apo.Manc.: MANZANO DELPOZO JESUS;CAÑERO CARRASCO RAFAEL;CAÑERO CARRASCO RAFAEL. Datos registrales. T 5130, L 4037, F 69, S 8, H MA12641, I/A 41 (25.04.16).
03 de Diciembre de 2015Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 5130, L 4037, F 69, S 8, H MA 12641, I/A 40 (25.11.15).
27 de Mayo de 2015Revocaciones. Apoderado: PEREZ GONZALEZ SARA. Datos registrales. T 5130, L 4037, F 69, S 8, H MA 12641, I/A 39(19.05.15).
04 de Febrero de 2015Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 5130, L 4037, F 69, S 8, H MA 12641, I/A 38 (26.01.15).
20 de Enero de 2014Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 5130, L 4037, F 39, S 8, H MA 12641, I/A 37 (10.01.14).
24 de Julio de 2013Revocaciones. Apoderado: MARTINEZ CACHAFEIRO ANTONIO JESUS;RUIZ GARCIA JOSE;ROPERO AMERIGO JOSEMANUEL;MEDINA DE CASTRO ANGEL;RUIZ GARCIA JOSE;MURGA TOME JOSE FERNANDO. Datos registrales. T 5130, L 4037,F 68, S 8, H MA 12641, I/A 36 (11.07.13).
05 de Julio de 2013Nombramientos. Apoderado: MONTESANTO ROTA SOFIA. Datos registrales. T 5130, L 4037, F 67, S 8, H MA 12641, I/A 33(27.06.13).
Nombramientos. Apo.Man.Soli: CAÑERO CARRASCO RAFAEL;MONTESANTO ROTA SOFIA. Datos registrales. T 5130, L 4037,F 67, S 8, H MA 12641, I/A 34 (27.06.13).
Nombramientos. Apoderado: PEREZ GONZALEZ SARA. Datos registrales. T 5130, L 4037, F 68, S 8, H MA 12641, I/A 35(27.06.13).
09 de Mayo de 2013Nombramientos. Apo.Man.Soli: MANZANO DEL POZO JESUS. Datos registrales. T 4260, L 3170, F 15, S 8, H MA 12641, I/A 32(25.04.13).
26 de Noviembre de 2012Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 4260, L 3170, F 15, S 8, H MA 12641, I/A 31 ( 9.11.12).
08 de Noviembre de 2011Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 4260, L 3170, F 15, S 8, H MA 12641, I/A 30 (26.10.11).
19 de Octubre de 2011Nombramientos. Apoderado: RODRIGUEZ SANCHEZ SARA. Datos registrales. T 4260, L 3170, F 14, S 8, H MA 12641, I/A 29 (5.10.11).
20 de Abril de 2011Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 4260, L 3170, F 13, S 8, H MA 12641, I/A 27 ( 4.04.11).
04 de Abril de 2011Cambio de objeto social. a).- El estudio, concesión, construcción, explotación, mantenimiento y conservación, en cualquiera de lasformas previstas por la Ley, de toda clase de obras e instalaciones, suministros y montajes ásean públicos o privados,sin limitaciónalguna€, eléctricos, de alumbrado, iluminac. Datos registrales. T 4260, L 3170, F 12, S 8, H MA 12641, I/A 26 (21.03.11).
27 de Diciembre de 2010Declaración de unipersonalidad. Socio único: EXTRALUX SA. Datos registrales. T 4260, L 3170, F 12, S 8, H MA 12641, I/A 24(14.12.10).
31 de Marzo de 2010Nombramientos. Apoderado: FERNANDEZ GARCIA JOSE ANTONIO. Datos registrales. T 4260, L 3170, F 11, S 8, H MA 12641,I/A 23 (18.03.10).
10 de Noviembre de 2009Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 4260, L 3170, F 11, S 8, H MA 12641, I/A 22 (28.10.09).
24 de Agosto de 2009Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: SANCHEZ BERNAL JUAN AGUSTIN. Nombramientos. Adm. Unico: ELECTRONIC TRAFIC SA.Datos registrales. T 4260, L 3170, F 11, S 8, H MA 12641, I/A 21 (11.08.09).
05 de Mayo de 2009Nombramientos. Apoderado: LOSADA SANZ JOSE LUIS. Datos registrales. T 4260, L 3170, F 10, S 8, H MA 12641, I/A 19(20.04.09).
Nombramientos. Apoderado: MURGA TOME JOSE FERNANDO. Datos registrales. T 4260, L 3170, F 10, S 8, H MA 12641, I/A 20(20.04.09).