Actos BORME de Montero Aramburu Slp
17 de Julio de 2023Revocaciones. Soc.Prof.: FERNANDEZ ARAMBURU HEPBURN ARMANDO;MONTERO GOMEZ ENRIQUE. Reducci贸n de capital.Importe reducci贸n: 960,00 Euros. Resultante Suscrito: 5.280,00 Euros. Modificaciones estatutarias. Art铆culo de los estatutos: 8.Capital social.-. Otros conceptos: Don Enrique Montero G贸mez ha vendido las participaciones n煤meros 481 a 960 de las que era
23 de Mayo de 2023Ceses/Dimisiones. Consejero: MONTERO GOMEZ ENRIQUE. Vicepresid.: MONTERO GOMEZ ENRIQUE. Datos registrales. T6521 , F 93, S 8, H SE 22970, I/A 38 (15.05.23).
Ceses/Dimisiones. Consejero: FERNANDEZ ARAMBURU HEPBURN ARMANDO. Presidente: FERNANDEZ ARAMBURUHEPBURN ARMANDO. Nombramientos. Consejero: FERNANDEZ REYES SOLEDAD ROSA;CUESTA BOOTHMAN MIGUEL.Presidente: MOLINO BARRERO ENCARNACION. Vicepresid.: ALBENDEA SOLIS IGNACIO. Reelecciones. Consejero: ORTEGATRUJILLO JAVIER;SELLERS FERIA IGNACIO;CEREZO MONTA脩EZ MARIA TERESA;CASADO GONZALEZ RAFAEL;MORINARVELO JOSE ALBERTO;MOLINO BARRERO ENCARNACION;NERI FERNANDEZ LEONARDO;VALDECANTOS LORA TAMAYOJAVIER;ALBENDEA SOLIS IGNACIO. Cons.Del.Man: NERI FERNANDEZ LEONARDO;VALDECANTOS LORA TAMAYO JAVIER.Secretario: CEREZO MONTA脩EZ MARIA TERESA. Vicesecret.: CASADO GONZALEZ RAFAEL. Datos registrales. T 6521 , F 93, S8, H SE 22970, I/A 39 (15.05.23).
29 de Septiembre de 2022Reelecciones. Auditor: AUDITORES Y CONSULTORES DEL SUR SLP. Datos registrales. T 6521 , F 93, S 8, H SE 22970, I/A 37(22.09.22).
06 de Septiembre de 2022Nombramientos. Soc.Prof.: FERNANDEZ REYES SOLEDAD;CUESTA BOOTHMAN MIGUEL. Ampliaci贸n de capital. Capital:960,00 Euros. Resultante Suscrito: 6.240,00 Euros. Modificaciones estatutarias. Art铆culo de los estatutos: 8. Capital social.-. Datosregistrales. T 6521 , F 92, S 8, H SE 22970, I/A 36 (26.08.22).
01 de Octubre de 2021Ceses/Dimisiones. Cons.Del.Man: FERNANDEZ ARAMBURU HEPBURN ARMANDO;MONTERO GOMEZ ENRIQUE. Secretario:VALDECANTOS LORA TAMAYO JAVIER. Vicesecret.: CEREZO MONTA脩EZ MARIA TERESA. Nombramientos. Cons.Del.Man:NERI FERNANDEZ LEONARDO;VALDECANTOS LORA TAMAYO JAVIER. Secretario: CEREZO MONTA脩EZ MARIA TERESA.Vicesecret.: CASADO GONZALEZ RAFAEL. Datos registrales. T 6521 , F 92, S 8, H SE 22970, I/A 35 (24.09.21).
21 de Septiembre de 2020Nombramientos. Soc.Prof.: ALBENDEA SOLIS IGNACIO;ORTEGA TRUJILLO FRANCISCO JAVIER;SELLERS FERIAIGNACIO;CEREZO MONTA脩EZ MARIA TERESA;CASADO GONZALEZ RAFAEL;MORIN ARVELO JOSE ALBERTO;MOLINOBARRERO ENCARNACION. Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 2.243,50 Euros. Resultante Suscrito: 2.221,50 Euros.Ampliaci贸n de capital. Capital: 3.058,50 Euros. Resultante Suscrito: 5.280,00 Euros. Modificaciones estatutarias. Art铆culo de losestatutos: 8. Capital social.-. Datos registrales. T 6521 , F 89, S 8, H SE 22970, I/A 33 ( 8.09.20).
Ceses/Dimisiones. VsecrNoConsj: CEREZO MONTA脩EZ MARIA TERESA. Nombramientos. Consejero: ORTEGA TRUJILLOJAVIER;SELLERS FERIA IGNACIO;CEREZO MONTA脩EZ MARIA TERESA;CASADO GONZALEZ RAFAEL;MORIN ARVELO JOSEALBERTO;MOLINO BARRERO ENCARNACION. Vicesecret.: CEREZO MONTA脩EZ MARIA TERESA. Reelecciones. Vicepresid.:MONTERO GOMEZ ENRIQUE. Presidente: FERNANDEZ ARAMBURU HEPBURN ARMANDO. Consejero: FERNANDEZARAMBURU HEPBURN ARMANDO;MONTERO GOMEZ ENRIQUE;NERI FERNANDEZ LEONARDO;VALDECANTOS LORATAMAYO JAVIER;ALBENDEA SOLIS IGNACIO. Cons.Del.Man: FERNANDEZ ARAMBURU HEPBURN ARMANDO;MONTEROGOMEZ ENRIQUE. Secretario: VALDECANTOS LORA TAMAYO JAVIER. Datos registrales. T 6521 , F 91, S 8, H SE 22970, I/A 34(10.09.20).
31 de Agosto de 2020Revocaciones. Soc.Prof.: CLAVERO TERNERO MANUEL FRANCISCO. Otros conceptos: El socio don Manuel Francisco ClaveroTernero transmite 1607 participaciones a la sociedad MONTERO ARAMBURU SLP para su posterior amortizaci贸n. Datos registrales.T 6521 , F 88, S 8, H SE 22970, I/A 31 (20.08.20).
27 de Agosto de 2020Modificaciones estatutarias. 11. Incorporaci贸n y promoci贸n de nuevos socios.-. Datos registrales. T 6521 , F 89, S 8, H SE 22970,I/A 32 (20.08.20).
29 de Octubre de 2019Reelecciones. Auditor: AUDITORES Y CONSULTORES DEL SUR SLP. Datos registrales. T 6521 , F 88, S 8, H SE 22970, I/A 30(21.10.19).
18 de Enero de 2019Ceses/Dimisiones. Soc.Prof.: ASTORGA MORANO RICARDO. Otros conceptos: El socio Ricardo Astorga Morano, transmite 1607
02 de Enero de 2019Nombramientos. Apoderado: FERNANDO TOLEDO BERMEJO MANUEL. Datos registrales. T 6521 , F 87, S 8, H SE 22970, I/A 28(18.12.18).
17 de Octubre de 2018Revocaciones. Apo.Sol.: ASTORGA MORANO RICARDO. Datos registrales. T 6521 , F 87, S 8, H SE 22970, I/A 26 ( 4.10.18).
Ceses/Dimisiones. Consejero: ASTORGA MORANO RICARDO;CLAVERO TERNERO MANUEL FRANCISCO. Vicesecret.:VALDECANTOS LORA TAMAYO JAVIER. Secretario: ASTORGA MORANO RICARDO. Nombramientos. Secretario:VALDECANTOS LORA TAMAYO JAVIER. VsecrNoConsj: CEREZO MONTA脩EZ MARIA TERESA. Datos registrales. T 6521 , F 87,S 8, H SE 22970, I/A 27 ( 5.10.18).
27 de Abril de 2018Nombramientos. Apo.Sol.: VALDECANTOS LORA TAMAYO JAVIER;CASADO GONZALEZ RAFAEL;ASTORGA MORANORICARDO;MORIN ARVELO JOSE ALBERTO;ORTEGA TRUJILLO FRANCISCO JAVIER;LORENZO VAZQUEZ JUAN LUIS. Datosregistrales. T 5881 , F 70, S 8, H SE 22970, I/A 25 (19.04.18).
23 de Abril de 2018Otros conceptos: Revocado el poder no inscrito conferido a Don Bernardo Jordano de la Torre, otorgado ante el Notario de Sevilla,don Francisco Javier L贸pez Camo, el d铆a diez de diciembre de dos mil trece, bajo el n煤mero 2.575 de protocolo Revocado el poder noinscrito conferido a favor Don Rafael Casado Gonz谩lez, en escritura otorgada ante el Notario de Sevilla, don Francisco Javier L贸pezCano, el d铆a cuatro de marzo de dos mil catorce, bajo el n煤mero 1.051 de protocolo. Datos registrales. T 5881 , F 70, S 8, H SE22970, I/A 24 (16.04.18).
17 de Enero de 2018Fusi贸n por absorci贸n. Sociedades absorbidas: MONTERO ARAMBURU HUELVA, S.L.P. MONTERO ARAMBURU CANARIAS SLP.Datos registrales. T 5881 , F 64, S 8, H SE 22970, I/A 23 (10.01.18).
27 de Julio de 2017Ceses/Dimisiones. Consejero: LINARES MORALES RAFAEL. Presidente: LINARES MORALES RAFAEL. Nombramientos.Vicepresid.: MONTERO GOMEZ ENRIQUE. Presidente: FERNANDEZ ARAMBURU HEPBURN ARMANDO. Reelecciones.Consejero: FERNANDEZ ARAMBURU HEPBURN ARMANDO;MONTERO GOMEZ ENRIQUE;NERI FERNANDEZLEONARDO;VALDECANTOS LORA TAMAYO JAVIER;CLAVERO TERNERO MANUEL FRANCISCO;ASTORGA MORANORICARDO;ALBENDEA SOLIS IGNACIO. Secretario: ASTORGA MORANO RICARDO. Vicesecret.: VALDECANTOS LORA TAMAYOJAVIER. Cons.Del.Man: FERNANDEZ ARAMBURU HEPBURN ARMANDO;MONTERO GOMEZ ENRIQUE. Datos registrales. T5881 , F 64, S 8, H SE 22970, I/A 22 (19.07.17).
24 de Marzo de 2017Ceses/Dimisiones. Soc.Prof.: HERNANDEZ PEREZ LORENZO. Otros conceptos: El socio HERNANDEZ PEREZ, LORENZOtransmite un n煤mero de 1920 participaciones a la propia sociedad MONTERO ARAMBURU SLP. Datos registrales. T 5881 , F 62, S8, H SE 22970, I/A 21 (14.03.17).
23 de Febrero de 2017Ceses/Dimisiones. Soc.Prof.: LINARES MORALES RAFAEL. Datos registrales. T 5881 , F 62, S 8, H SE 22970, I/A 19 (15.02.17).
Ceses/Dimisiones. Soc.Prof.: ALVAREZ TELLO ALFREDO. Datos registrales. T 5881 , F 62, S 8, H SE 22970, I/A 20 (15.02.17).
04 de Octubre de 2016Reelecciones. Auditor: AUDITORES Y CONSULTORES DEL SUR SLP. Datos registrales. T 5881 , F 62, S 8, H SE 22970, I/A 18(23.09.16).
01 de Junio de 2015Ceses/Dimisiones. Consejero: ALVAREZ TELLO ALFREDO;HERNANDEZ PEREZ LORENZO. Vicepresid.: LINARES MORALESRAFAEL. Presidente: ALVAREZ TELLO ALFREDO. Revocaciones. Apoderado: ALVAREZ TELLO ALFREDO. Apo.Sol.: ALVAREZTELLO ALFREDO. Nombramientos. Presidente: LINARES MORALES RAFAEL. Datos registrales. T 5881 , F 61, S 8, H SE 22970,I/A 17 (22.05.15).
16 de Julio de 2014Nombramientos. Apoderado: FERNANDEZ LEAL MANUEL. Datos registrales. T 5006 , F 44, S 8, H SE 22970, I/A 16 ( 9.07.14).
13 de Noviembre de 2013Ceses/Dimisiones. Con.Delegado: ALVAREZ TELLO ALFREDO. Nombramientos. Cons.Del.Man: FERNANDEZ ARAMBURUHEPBURN ARMANDO;MONTERO GOMEZ ENRIQUE. Datos registrales. T 5006 , F 43, S 8, H SE 22970, I/A 15 ( 6.11.13).
09 de Octubre de 2013Nombramientos. Apo.Sol.: MONTERO GOMEZ ENRIQUE;FERNANDEZ ARAMBURU HEPBURN ARMANDO. Datos registrales. T5006 , F 42, S 8, H SE 22970, I/A 13 (27.09.13).
Revocaciones. Apoderado: SOLANES GASOS GREGORIO;FERNANDEZ BASTUS PATRICIA. Datos registrales. T 5006 , F 43, S8, H SE 22970, I/A 14 (30.09.13).
25 de Julio de 2013Nombramientos. Apo.Manc.: ROMO CABALLERO JAVIER. Apo.Sol.: FERNANDEZ LEAL MANUEL. Otros conceptos: Forma deactuaci贸n de los apoderados: don Javier Romo Caballero actuar谩 mancomunadamente con don Manuel Fern谩ndez Leal. Don ManuelFern谩ndez Leal actuar谩 solidariamente.- Datos registrales. T 5006 , F 42, S 8, H SE 22970, I/A 12 (18.07.13).
03 de Febrero de 2012Nombramientos. Apoderado: FERNANDEZ BASTUS PATRICIA. Datos registrales. T 5006 , F 41, S 8, H SE 22970, I/A 11(25.01.12).
28 de Octubre de 2010Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: ALVAREZ TELLO ALFREDO. Nombramientos. Consejero: ALVAREZ TELLO ALFREDO;LINARESMORALES RAFAEL;FERNANDEZ ARAMBURU HEPBURN ARMANDO;MONTERO GOMEZ ENRIQUE;NERI FERNANDEZLEONARDO;VALDECANTOS LORA TAMAYO JAVIER;CLAVERO TERNERO MANUEL FRANCISCO;ASTORGA MORANORICARDO;ALBENDEA SOLIS IGNACIO;HERNANDEZ PEREZ LORENZO. Presidente: ALVAREZ TELLO ALFREDO. Con.Delegado:ALVAREZ TELLO ALFREDO. Vicepresid.: LINARES MORALES RAFAEL. Secretario: ASTORGA MORANO RICARDO. Vicesecret.:VALDECANTOS LORA TAMAYO JAVIER. Ampliaci贸n de capital. Capital: 480,00 Euros. Resultante Suscrito: 4.465,00 Euros.Modificaciones estatutarias. Art铆culo de los estatutos: 8. Capital.-.Cambio del Organo de Administraci贸n: Administrador 煤nico aConsejo de administraci贸n. Datos registrales. T 5006 , F 40, S 8, H SE 22970, I/A 10 (15.10.10).