Actos BORME de Montnuri Sl
31 de Agosto de 2022Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 82.757,70 Euros. Resultante Suscrito: 19.412,30 Euros. Escisi贸n parcial. Sociedadesbeneficiarias de la escisi贸n: WL MOLLET S.L. Datos registrales. T 22182 , F 194, S 8, H B 32641, I/A 16 (24.08.22).
15 de Enero de 2021Nombramientos. VICESECRET.: GRAELLS GONZALVO MONTSERRAT. Datos registrales. T 22182 , F 194, S 8, H B 32641, I/A15 ( 7.01.21).
31 de Enero de 2017Revocaciones. CONSEJERO: COMAS GRAELLS CRISTIAN. SECRETARIO: COMAS GRAELLS CRISTIAN. Nombramientos.CONSEJERO: COMAS GRAELLS FEDERICO. SECRETARIO: COMAS GRAELLS FEDERICO. Datos registrales. T 22182 , F 194, S8, H B 32641, I/A 14 (23.01.17).
13 de Febrero de 2015Revocaciones. CONSEJERO: COMAS GRAELLS NURIA. SECRETARIO: COMAS GRAELLS NURIA. Nombramientos.CONSEJERO: COMAS GRAELLS CRISTIAN. SECRETARIO: COMAS GRAELLS CRISTIAN. Datos registrales. T 22182 , F 193, S8, H B 32641, I/A 12 ( 6.02.15).
Nombramientos. APODERAD.SOL: CREUS GRAELLS FRANCESC XAVIER. Datos registrales. T 22182 , F 193, S 8, H B 32641,I/A 13 ( 6.02.15).
11 de Octubre de 2011Revocaciones. CONSEJERO: CREUS GRAELLS FRANCESC XAVIER. Nombramientos. CONSEJERO: GRAELLS GONZALVOMONTSERRAT. Datos registrales. T 22182 , F 193, S 8, H B 32641, I/A 11 (29.09.11).
12 de Abril de 2011Revocaciones. ADMINISTR.: COMAS HOFMANN FEDERICO. Nombramientos. CONSEJERO: CREUS GRAELLS JORGE.PRESIDENTE: CREUS GRAELLS JORGE. CONS. DELEG.: CREUS GRAELLS JORGE. CONSEJERO: COMAS GRAELLS NURIA.SECRETARIO: COMAS GRAELLS NURIA. CONSEJERO: CREUS GRAELLS FRANCESC XAVIER. Cambio de domicilio social.CL FRANCESC LAYRET Num.75 P.7 PTA.3 (MOLLET DEL VALLES). Datos registrales. T 22182 , F 191, S 8, H B 32641, I/A 10(31.03.11).